ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01105441 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
- Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FTBF LEASING DECEMBER (A) LIMITED | 15 feb 1995 | 15 feb 1995 |
| FORWARD ASSET LEASING DECEMBER (A) LIMITED | 14 ago 1992 | 14 ago 1992 |
| MIDLAND MONTAGU EQUIPMENT FINANCE LIMITED | 30 mar 1973 | 30 mar 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Seconda presentazione per la cessazione di Robin Louise Henning Bencard come amministratore | 5 pagine | RP04TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Robin Louis Henning Bencard come amministratore in data 08 ago 2016 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Simon Einar Long come amministratore in data 15 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John Cavanna come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Connelly Anderson come amministratore in data 16 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Cessazione della carica di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 28 mag 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Ms Romana Lewis come segretario in data 28 mag 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 05 gen 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tony Bhambhra come segretario in data 05 gen 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Tony Bhambhra come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Katherine Dean come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 52 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Romana | Segretario | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E145HQ London, Greater London 8 England England | 198057230001 | |||||||
| ANDERSON, Michael Connelly | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 269666390001 | |||||
| KENT, John Richard | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 174308200001 | |||||
| LONG, Simon Einar | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 206202590001 | |||||
| OWEN CONWAY, Gareth | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 82999960002 | |||||
| SUBRAMANIYAN, Jaya | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Malaysian | 136924480002 | |||||
| BAYER, George William | Segretario | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| BHAMBHRA, Tony | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 187824150001 | |||||||
| DEAN, Katherine | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180092200001 | |||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Segretario | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| MCKENZIE, John Hume | Segretario | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Segretario | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Segretario | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Segretario | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Segretario | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Segretario | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
| READ, Alice | Segretario | 188 Berglen Court 7 Branch Road E14 7JZ London | British | 106168980003 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194209400001 | |||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 154911860001 | |||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 166967460001 | |||||||
| BARKER, Fiona Ann | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||
| BENCARD, Robin Louis Henning | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 46782110002 | |||||
| BROOKES, Malcolm James | Amministratore | 3 School Close Pinvin WR10 2TZ Pershore Worcestershire | British | 61727900003 | ||||||
| CARNEY, Brian | Amministratore | Springwood Lodge Owler Park Road LS29 0BG Ilkley West Yorkshire | British | 100001170001 | ||||||
| CAVANNA, David John | Amministratore | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| EVANS, Geoffrey William | Amministratore | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | 42712190001 | ||||||
| GILMAN, David William | Amministratore | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | 5681410002 | ||||||
| HARRIS, Christopher David | Amministratore | 8 Verdon Place Barford CV35 8BT Warwick | British | 28742940002 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Amministratore | 18 The Badgers Mearse Lane Barnt Green B45 8QR Birmingham | British | 28497420002 | ||||||
| KELL, Christopher Raymond | Amministratore | 6 Gorse Close WR9 7SG Droitwich Worcestershire | British | 87307470001 | ||||||
| KENNY, Mary Bridget | Amministratore | 178 Empire Square West Long Lane SE1 4NL London | United Kingdom | British | 118995490002 | |||||
| LANE, Robert David | Amministratore | 42 Bridgnorth Road WV5 0AA Wombourne Staffordshire | England | British | 150099050001 | |||||
| LEECH, Ian Robert | Amministratore | 139 Lordswood Road Harborne B17 9BL Birmingham | British | 52909330001 | ||||||
| LESTER, Edward Paul | Amministratore | 26 St Barnabas Road CB1 2BY Cambridge Cambridgeshire | British | 4300370001 | ||||||
| MEAD, David Harry | Amministratore | Willowbank Pirton WR8 9ED Worcester Worcestershire | England | British | 254170760001 |
ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Amended and restated intercreditor agreement | Creato il 19 dic 1997 Consegnato il 31 dic 1997 | In corso | Importo garantito In favour of chase manhattan international limited as security agent and trustee for the senior creditors (as defined) and the lessors (as defined) (1)the senior debt, subject to clause 11.2, clause 11.4, clause 27.3(iii) and clause 27.4(b) of the intercreditor agreement all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents (as defined), (2)the lease debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the lessors under or in connection with the lease finance documents (as defined) and (3) the subordinated debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the subordinated creditors (as defined) under or in connection with the subordinated debt documents or in connection with treasury debt and all indemnity rights | |
Brevi particolari If at any time prior to the later of the senior discharge date the company receives a payment or distribution in cash or kind of or on account of any lease debt or prior to the senior discharge date any lease debt is discharged in each case in a manner not permitted by clause 6 (permitted lease payments) by clause 7 (permitted subordinated payments) or clause 15.1 (permitted lease enforcement) clause 15.2 (permitted enforcement action in respect of vat) or by clause 17 (proceeds of enforcement of security) the company will subject to clause 10.9 (exclusion of trust) hold such recovery payment distribution proceeds set-off or other amount in trust for the security trustee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 19 dic 1997 Consegnato il 31 dic 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the chattel mortgage under and in accordance with clause 4 (sales representative) of the direct agreement | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the english assets ,the scottish assets and the northern irish assets including the sale proceeds thereof for full details of charged assets please refer to form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Lessor's security assignment (as defined) | Creato il 19 dic 1996 Consegnato il 27 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage | |
Brevi particolari All rights,title and interest in respect of clause 5.1 of the conditional sale agreement to acquire ownership of the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 10 dic 1996 Consegnato il 20 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage | |
Brevi particolari All rights,title,interest,insurances and proceeds of sale in the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0