ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED

ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01105441
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FTBF LEASING DECEMBER (A) LIMITED15 feb 199515 feb 1995
    FORWARD ASSET LEASING DECEMBER (A) LIMITED14 ago 199214 ago 1992
    MIDLAND MONTAGU EQUIPMENT FINANCE LIMITED30 mar 197330 mar 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Seconda presentazione per la cessazione di Robin Louise Henning Bencard come amministratore

    5 pagineRP04TM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Cessazione della carica di Robin Louis Henning Bencard come amministratore in data 08 ago 2016

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    09 set 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 09/09/2016

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2016

    Stato del capitale al 05 mag 2016

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Nomina di Mr Simon Einar Long come amministratore in data 15 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David John Cavanna come amministratore in data 31 dic 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Michael Connelly Anderson come amministratore in data 16 dic 2015

    2 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    19 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 28 mag 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Romana Lewis come segretario in data 28 mag 2015

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2015

    Stato del capitale al 08 mag 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Nomina di Hannah Elizabeth Shepherd come segretario in data 05 gen 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Tony Bhambhra come segretario in data 05 gen 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    20 pagineAA

    Nomina di Tony Bhambhra come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Katherine Dean come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2014

    Stato del capitale al 08 mag 2014

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    52 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Segretario
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    198057230001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Segretario
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    187824150001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180092200001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Segretario
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Segretario
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Segretario
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Segretario
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Segretario
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Segretario
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Segretario
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194209400001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154911860001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    166967460001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    BROOKES, Malcolm James
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    British61727900003
    CARNEY, Brian
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    British100001170001
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Amministratore
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Amministratore
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Amministratore
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HARRIS, Christopher David
    8 Verdon Place
    Barford
    CV35 8BT Warwick
    Amministratore
    8 Verdon Place
    Barford
    CV35 8BT Warwick
    British28742940002
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Amministratore
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KELL, Christopher Raymond
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    British87307470001
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Amministratore
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    LANE, Robert David
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    Amministratore
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    EnglandBritish150099050001
    LEECH, Ian Robert
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    Amministratore
    139 Lordswood Road
    Harborne
    B17 9BL Birmingham
    British52909330001
    LESTER, Edward Paul
    26 St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    26 St Barnabas Road
    CB1 2BY Cambridge
    Cambridgeshire
    British4300370001
    MEAD, David Harry
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish254170760001

    ASSETFINANCE DECEMBER (A) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Amended and restated intercreditor agreement
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 31 dic 1997
    In corso
    Importo garantito
    In favour of chase manhattan international limited as security agent and trustee for the senior creditors (as defined) and the lessors (as defined) (1)the senior debt, subject to clause 11.2, clause 11.4, clause 27.3(iii) and clause 27.4(b) of the intercreditor agreement all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the senior creditors under or in connection with the senior finance documents (as defined), (2)the lease debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the lessors under or in connection with the lease finance documents (as defined) and (3) the subordinated debt, all present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by the obligors to the subordinated creditors (as defined) under or in connection with the subordinated debt documents or in connection with treasury debt and all indemnity rights
    Brevi particolari
    If at any time prior to the later of the senior discharge date the company receives a payment or distribution in cash or kind of or on account of any lease debt or prior to the senior discharge date any lease debt is discharged in each case in a manner not permitted by clause 6 (permitted lease payments) by clause 7 (permitted subordinated payments) or clause 15.1 (permitted lease enforcement) clause 15.2 (permitted enforcement action in respect of vat) or by clause 17 (proceeds of enforcement of security) the company will subject to clause 10.9 (exclusion of trust) hold such recovery payment distribution proceeds set-off or other amount in trust for the security trustee.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited
    Transazioni
    • 31 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 31 dic 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the chattel mortgage under and in accordance with clause 4 (sales representative) of the direct agreement
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the english assets ,the scottish assets and the northern irish assets including the sale proceeds thereof for full details of charged assets please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited
    Transazioni
    • 31 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Lessor's security assignment (as defined)
    Creato il 19 dic 1996
    Consegnato il 27 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in respect of clause 5.1 of the conditional sale agreement to acquire ownership of the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samoco 1233 Trust
    Transazioni
    • 27 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 10 dic 1996
    Consegnato il 20 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage
    Brevi particolari
    All rights,title,interest,insurances and proceeds of sale in the vessel "hull 1233". see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samoco 1233 Trust
    Transazioni
    • 20 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0