PRESTIGE HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PRESTIGE HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01110225 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PRESTIGE HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED?
- Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere
Dove si trova PRESTIGE HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 2 Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PRESTIGE HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PRESTIGE & HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED | 03 apr 2017 | 03 apr 2017 |
| HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED | 27 ott 2011 | 27 ott 2011 |
| SHEPHERD PARK & LEISURE HOMES LIMITED | 14 nov 2008 | 14 nov 2008 |
| HOMESEEKER HOMES LIMITED | 19 gen 1984 | 19 gen 1984 |
| PANTHER CARAVANS LIMITED | 26 apr 1973 | 26 apr 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PRESTIGE HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PRESTIGE HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 15 gen 2027 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 29 gen 2027 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 15 gen 2026 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per PRESTIGE HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Iscrizione dell'ipoteca 011102250015, creata il 21 gen 2026 | 17 pagine | MR01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2026 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Westwood il 23 gen 2026 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Wake il 23 gen 2026 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary Corlyon il 23 gen 2026 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2024 | 29 pagine | AA | ||
Iscrizione dell'ipoteca 011102250014, creata il 15 set 2025 | 42 pagine | MR01 | ||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mar 2025 al 31 dic 2024 | 1 pagine | AA01 | ||
Nomina di Mr Michael Paul Fry come amministratore in data 12 giu 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Daniel James Chapman come amministratore in data 15 apr 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 30 mar 2024 | 38 pagine | AA | ||
Iscrizione dell'ipoteca 011102250013, creata il 20 mar 2025 | 11 pagine | MR01 | ||
Nomina di Mr Gary Corlyon come amministratore in data 10 mar 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Mitchell Andrew Comer come amministratore in data 10 mar 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Robert Edward Wilde come amministratore in data 04 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Timothy John Rix come amministratore in data 04 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Ms Sally Joanna Rix come amministratore in data 04 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Harry James Rix come amministratore in data 04 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Duncan John Lambert come amministratore in data 04 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Peter Jeffrey Hasnip come amministratore in data 04 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr James Ian Doyle come amministratore in data 04 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Rory Michael Andrew Clarke come amministratore in data 04 lug 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 8 Shipton Way Express Business Park Rushden Northamptonshire NN10 6GL a 2 Humber Quays Wellington Street West Hull HU1 2BN in data 09 lug 2024 | 1 pagine | AD01 | ||
Notifica di Prestige Communities Group Limited come persona con controllo significativo il 29 mar 2024 | 2 pagine | PSC02 | ||
Chi sono gli amministratori di PRESTIGE HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Rory Michael Andrew | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 88279430004 | |||||
| CORLYON, Gary Leslie | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 333267580001 | |||||
| DOYLE, James Ian | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 237964780001 | |||||
| FRY, Michael Paul | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 333402240001 | |||||
| HASNIP, Peter Jeffrey | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 324923360001 | |||||
| LAMBERT, Duncan John | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 137664460002 | |||||
| RIX, Harry James | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 280558050001 | |||||
| RIX, Sally Joanna | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 46555370001 | |||||
| RIX, Timothy John | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 147684090001 | |||||
| WAKE, Jonathan Richard | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 218245950003 | |||||
| WESTWOOD, Andrew John | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 218241500001 | |||||
| WILDE, Robert Edward | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 304181120001 | |||||
| CHRISTISON, Mark | Segretario | Shipton Way Express Business Park NN10 6GL Rushden 8 Northamptonshire | 218250940001 | |||||||
| CLARKE, Philip John | Segretario | c/o Clifford Roberts Chartered Accountants Broad Green NN8 4LQ Wellingborough 63 Northamptonshire England | British | 33455570004 | ||||||
| COLBY, Peter John | Segretario | 16 Sunnyside Earls Barton NN6 0EX Northampton Northamptonshire | British | 2054510001 | ||||||
| HADDOCK, David George | Segretario | 68 Ridgeway NN3 3AR Northampton Northamptonshire | British | 86772370001 | ||||||
| ROWLINSON, Alan Francis | Segretario | The Cottage 1 Strensall Road Huntington YO32 9RF York North Yorkshire | British | 21322230001 | ||||||
| ARNETT, Stephen | Amministratore | Shipton Way Express Business Park NN10 6GL Rushden 8 Northamptonshire | United Kingdom | British | 201307740001 | |||||
| AVERY, Gordon Hurrell | Amministratore | 2 Ashby Close NN8 5FH Wellingborough Northamptonshire | British | 33127730001 | ||||||
| BERWICK, Peter Robert | Amministratore | Huntington House Jockey Lane, YO32 9XW Huntington York | England | British | 165752060001 | |||||
| BRISTOW, Simon John | Amministratore | Huntington House Jockey Lane, YO32 9XW Huntington York | England | British | 47863910001 | |||||
| BROWN, Colin Leslie | Amministratore | Huntington House Jockey Lane, YO32 9XW Huntington York | United Kingdom | British | 35341260003 | |||||
| BULL, Robert Lee Jack | Amministratore | Shipton Way Express Business Park NN10 6GL Rushden 8 Northamptonshire | England | British | 240346910002 | |||||
| CATTELL, Joyce Cynthia | Amministratore | 134 Northampton Road NN10 6AL Rushden Northamptonshire | British | 2286500004 | ||||||
| CATTELL, Roy Norman | Amministratore | 58 Station Road Irthlingborough NN9 5QE Wellingborough Northamptonshire | British | 1869580001 | ||||||
| CHAPMAN, Daniel James | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 313779040001 | |||||
| CHRISTISON, Mark Andrew | Amministratore | Shipton Way Express Business Park NN10 6GL Rushden 8 Northamptonshire | United Kingdom | British | 75146270003 | |||||
| CLARKE, Billy | Amministratore | 11 Netherwoods Strensall YO32 5WE York North Yorkshire | British | 99773490001 | ||||||
| COLBY, Peter John | Amministratore | 16 Sunnyside Earls Barton NN6 0EX Northampton Northamptonshire | British | 2054510001 | ||||||
| COMER, Mitchell Andrew, Dr | Amministratore | Humber Quays Wellington Street West HU1 2BN Hull 2 England | England | British | 100386700002 | |||||
| DOUGLAS, Karl | Amministratore | Shipton Way Express Business Park NN10 6GL Rushden 8 Northamptonshire United Kingdom | England | British | 305074950001 | |||||
| FOULKE, Debbie Joanne | Amministratore | Shipton Way Express Business Park NN10 6GL Rushden 8 Northamptonshire | United Kingdom | British | 218237490001 | |||||
| GERANIO, Silvano | Amministratore | Shipton Way Express Business Park NN10 6GL Rushden 8 Northamptonshire | United Kingdom | Italian | 297538470001 | |||||
| HANGER, Keith Andrew | Amministratore | Cleeve Way NN8 2RT Wellingborough 7 Northants England United Kingdom | England | British | 77135240003 | |||||
| HARDIMAN, William Bernard | Amministratore | Huntington House Jockey Lane, YO32 9XW Huntington York | England | British | 99773540001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PRESTIGE HOMESEEKER PARK & LEISURE HOMES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige Communities Group Limited | 29 mar 2024 | Express Business Park NN10 6GL Rushden 8 Shipton Way England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Sek Holdings Limited | 25 mar 2019 | Shipton Way Express Business Park NN10 6GL Rushden 8 Northamptonshire England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Sek Manufacturing Ltd | 06 apr 2016 | Broad Green NN8 4LQ Wellingborough 63 United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0