RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED
Panoramica
Nome della società | RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01117341 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Forge 43 Church Street West GU21 6HT Woking Surrey England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
RADFORD RETAIL SYSTEMS LIMITED | 25 lug 1997 | 25 lug 1997 |
ACE REFRIGERATION LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
INTERNATIONAL CO-ORDINATION (WELDING PRODUCTS) LIMITED | 08 giu 1973 | 08 giu 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 3 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Patterson il 27 apr 2023 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 3 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Lansing Group Limited come persona con controllo significativo il 01 apr 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da The Priestley Centre 10 Priestley Road the Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7XY a Forge 43 Church Street West Woking Surrey GU21 6HT in data 04 apr 2022 | 1 pagine | AD01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher James Cossins il 01 apr 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sally Ann Williams il 01 apr 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Julian Michael Bland il 01 apr 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Patterson il 01 apr 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Susan Kathleen Kelly il 01 apr 2022 | 1 pagine | CH03 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Christopher James Cossins come amministratore in data 15 nov 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Julian Michael Bland il 28 giu 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 3 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Patterson il 21 mag 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Andrew Christopher Brackfield come amministratore in data 31 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KELLY, Susan Kathleen | Segretario | 43 Church Street West GU21 6HT Woking Linde, Forge Surrey England | British | 71087960003 | ||||||
BLAND, Julian Michael | Amministratore | 43 Church Street West GU21 6HT Woking Linde, Forge Surrey England | England | British | Head Of Accounting | 193502260038 | ||||
COSSINS, Christopher James | Amministratore | 43 Church Street West GU21 6HT Woking Linde, Forge Surrey England | England | British | Tax Manager | 156918520002 | ||||
PATTERSON, Benjamin | Amministratore | 43 Church Street West GU21 6HT Woking Linde, Forge Surrey England | England | British | Solicitor | 208185060037 | ||||
WILLIAMS, Sally Ann | Amministratore | 43 Church Street West GU21 6HT Woking Linde, Forge Surrey England | England | British | Accountant | 204065740002 | ||||
BRACKFIELD, Andrew Christopher | Segretario | The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd Surrey Research Park GU2 7XY Guildford Surrey | British | Solicitor | 118706260003 | |||||
LARKINS, Sarah Louise | Segretario | 11 Bluebell Road Lindford GU35 0YN Bordon Hampshire | British | 99307280001 | ||||||
NORRIS, David William Worsley | Segretario | Tidmarsh House Tidmarsh Lane, Pangbourne RG8 8HA Reading Berkshire | British | 85579400001 | ||||||
SIMMONDS, Peter John | Segretario | Cleveland House 109 Pack Lane Kempshott RG22 5HH Basingstoke Hampshire | British | Chartered Accountant | 108212170001 | |||||
BAILEY, Melvyn Horace | Amministratore | 13 Clearview Lodge Lane DY6 9XQ Kingswinford West Midlands | British | Executive | 16583740001 | |||||
BEST, Peter Michael | Amministratore | 2 Clent Drive DY9 9LN Hagley West Midlands | England | British | Company Executive | 125898570001 | ||||
BRACKFIELD, Andrew Christopher | Amministratore | The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd Surrey Research Park GU2 7XY Guildford Surrey | England | British | Solicitor | 118706260003 | ||||
BROWN, John | Amministratore | 17 Callas Rise SN4 0AQ Wanborough Swindon | British | Company Executive | 74970430001 | |||||
BUTLER, Andrew | Amministratore | 2 Sutton Acres Flore NN7 4NW Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Executive | 1506150002 | ||||
DEVERS, Dorian Kevin Thomas | Amministratore | 10 Priestley Road, Surrey Research Park GU2 7XY Guildford The Linde Group The Priestley Centre Surrey England | England | British | Head Of Finance, Africa & Uk | 208186510001 | ||||
FINKEN, Thorben, Dr | Amministratore | 10 Priestley Road Surrey Research Park GU2 7XY Guildford The Linde Group, The Priestley Centre Surrey | England | German | Finance Director Region Africa And Uk | 152685750001 | ||||
FUERST, Reinhard | Amministratore | Muhlackstrasse 7 6000 Frankfurt 1 Main 56 FOREIGN West Germany | German | Director Of Finance Linde K T | 11458570001 | |||||
GARNER, Graham Edward | Amministratore | Inshallah Bredons Norton GL20 7HB Tewkesbury Gloucestershire | British | Company Director | 27804640001 | |||||
GEUECKE, Wolfgang Dieter | Amministratore | Rulaenderstr. 22 Mainz 55129 Germany | German | Company Executive | 74668400002 | |||||
HAESELER, Hans-Georg | Amministratore | Birkenweg 13 65817 Eppstein Germany | German | Lawyer | 26020450001 | |||||
KROSSA, Hubertus | Amministratore | Panoramaweg 3 65191 Wiesbaden Germany | German | Company Exeecutive | 54057150002 | |||||
LARKINS, Sarah Louise | Amministratore | 11 Bluebell Road Lindford GU35 0YN Bordon Hampshire | British | Chartered Secretary | 99307280001 | |||||
LEWIS, Nigel Andrew | Amministratore | The Linde Group The Priestley Centre 10 Priestley Rd The Surrey, Research Park GU2 7XY Guildford Surrey | United Kingdom | British | Director Acquisitions & New Vent | 146324340001 | ||||
LOWERY, Robert Brian | Amministratore | 61 Earlswood Park NE9 6AZ Gateshead Tyne & Wear | British | General Manager | 54245630001 | |||||
MOFFAT, Derek Peter | Amministratore | Tryst Park EH10 7HD Edinburgh 28 | Scotland | British | Manager | 129061330002 | ||||
MOSTYN, Gareth | Amministratore | The Linde Group The Priestley Centre 10 Priestley Road Surrey Research Park GU2 7XY Guildford Surrey | British | Accountant | 126699160001 | |||||
MULLER, Gerhard | Amministratore | Am Eibenhang 6 6581 Eppstein FOREIGN Germany | German | Director | 40452970001 | |||||
NORRIS, David William Worsley | Amministratore | Tidmarsh House Tidmarsh Lane, Pangbourne RG8 8HA Reading Berkshire | British | Chartered Accountant/Managing Director | 85579400001 | |||||
PALMER, Nathan | Amministratore | The Priestley Centre, 10 Priestley Road GU2 7XY Guildford The Linde Group Surrey England | England | British | Head Of Regional Sales & Marketing | 168273890001 | ||||
SCHLING, Falko | Amministratore | Muehlenweg 3 Hofheim 65719 FOREIGN Germany | German | Company Executive | 68966340002 | |||||
SCHUPPAR, Helmut | Amministratore | Konrad Adenauer Strasse 11 Idstein D 65510 Hessen Germany | German | Company Executive | 54057380001 | |||||
SIMMONDS, Peter John | Amministratore | Cleveland House 109 Pack Lane Kempshott RG22 5HH Basingstoke Hampshire | United Kingdom | British | Director | 108212170001 | ||||
SPENCE, Patrick Charles Gordon | Amministratore | The Linde Group The Priestley Centre 10 Priestley Road GU2 7XY Surrey Research Park Surrey | British | Chartered Accountant | 79853340013 | |||||
TANDLER, Gerold | Amministratore | Am Burgerwald 17 8X4524 Neuotting Bavaria Germany | German | Company Director | 54056820001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lansing Group Limited | 06 apr 2016 | 43 Church Street West GU21 6HT Woking Forge Surrey England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Creato il 31 lug 1997 Consegnato il 05 ago 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Property k/a unit 13 hobso industrial estate burnopfield durham t/n DU209732, land and buildings at hobson industrial estate, burnopfield durham t/n du 164067, land and buildings at north alloy industrial estate pontardawe t/n wa 43610 and all other properties listed on the schedule attatched to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0