RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED

RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRRS (FEBRUARY 2004) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01117341
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Forge
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Surrey
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RADFORD RETAIL SYSTEMS LIMITED25 lug 199725 lug 1997
    ACE REFRIGERATION LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    INTERNATIONAL CO-ORDINATION (WELDING PRODUCTS) LIMITED08 giu 197308 giu 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Patterson il 27 apr 2023

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    3 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Lansing Group Limited come persona con controllo significativo il 01 apr 2022

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da The Priestley Centre 10 Priestley Road the Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7XY a Forge 43 Church Street West Woking Surrey GU21 6HT in data 04 apr 2022

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher James Cossins il 01 apr 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sally Ann Williams il 01 apr 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Julian Michael Bland il 01 apr 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Patterson il 01 apr 2022

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Susan Kathleen Kelly il 01 apr 2022

    1 pagineCH03

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Christopher James Cossins come amministratore in data 15 nov 2021

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Julian Michael Bland il 28 giu 2021

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Patterson il 21 mag 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Andrew Christopher Brackfield come amministratore in data 31 dic 2018

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KELLY, Susan Kathleen
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Segretario
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    British71087960003
    BLAND, Julian Michael
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Amministratore
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    EnglandBritishHead Of Accounting193502260038
    COSSINS, Christopher James
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Amministratore
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    EnglandBritishTax Manager156918520002
    PATTERSON, Benjamin
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Amministratore
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    EnglandBritishSolicitor208185060037
    WILLIAMS, Sally Ann
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    Amministratore
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Linde, Forge
    Surrey
    England
    EnglandBritishAccountant204065740002
    BRACKFIELD, Andrew Christopher
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Segretario
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    BritishSolicitor118706260003
    LARKINS, Sarah Louise
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    Segretario
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    British99307280001
    NORRIS, David William Worsley
    Tidmarsh House
    Tidmarsh Lane, Pangbourne
    RG8 8HA Reading
    Berkshire
    Segretario
    Tidmarsh House
    Tidmarsh Lane, Pangbourne
    RG8 8HA Reading
    Berkshire
    British85579400001
    SIMMONDS, Peter John
    Cleveland House
    109 Pack Lane Kempshott
    RG22 5HH Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    Cleveland House
    109 Pack Lane Kempshott
    RG22 5HH Basingstoke
    Hampshire
    BritishChartered Accountant108212170001
    BAILEY, Melvyn Horace
    13 Clearview
    Lodge Lane
    DY6 9XQ Kingswinford
    West Midlands
    Amministratore
    13 Clearview
    Lodge Lane
    DY6 9XQ Kingswinford
    West Midlands
    BritishExecutive16583740001
    BEST, Peter Michael
    2 Clent Drive
    DY9 9LN Hagley
    West Midlands
    Amministratore
    2 Clent Drive
    DY9 9LN Hagley
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Executive125898570001
    BRACKFIELD, Andrew Christopher
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Amministratore
    The Linde Group, Priestley Centre 10 Priestley Rd
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    EnglandBritishSolicitor118706260003
    BROWN, John
    17 Callas Rise
    SN4 0AQ Wanborough
    Swindon
    Amministratore
    17 Callas Rise
    SN4 0AQ Wanborough
    Swindon
    BritishCompany Executive74970430001
    BUTLER, Andrew
    2 Sutton Acres
    Flore
    NN7 4NW Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    2 Sutton Acres
    Flore
    NN7 4NW Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishExecutive1506150002
    DEVERS, Dorian Kevin Thomas
    10 Priestley Road, Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group The Priestley Centre
    Surrey
    England
    Amministratore
    10 Priestley Road, Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group The Priestley Centre
    Surrey
    England
    EnglandBritishHead Of Finance, Africa & Uk208186510001
    FINKEN, Thorben, Dr
    10 Priestley Road
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    Amministratore
    10 Priestley Road
    Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group, The Priestley Centre
    Surrey
    EnglandGermanFinance Director Region Africa And Uk152685750001
    FUERST, Reinhard
    Muhlackstrasse 7
    6000 Frankfurt 1 Main 56
    FOREIGN
    West Germany
    Amministratore
    Muhlackstrasse 7
    6000 Frankfurt 1 Main 56
    FOREIGN
    West Germany
    GermanDirector Of Finance Linde K T11458570001
    GARNER, Graham Edward
    Inshallah
    Bredons Norton
    GL20 7HB Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Inshallah
    Bredons Norton
    GL20 7HB Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishCompany Director27804640001
    GEUECKE, Wolfgang Dieter
    Rulaenderstr. 22
    Mainz
    55129
    Germany
    Amministratore
    Rulaenderstr. 22
    Mainz
    55129
    Germany
    GermanCompany Executive74668400002
    HAESELER, Hans-Georg
    Birkenweg 13
    65817 Eppstein
    Germany
    Amministratore
    Birkenweg 13
    65817 Eppstein
    Germany
    GermanLawyer26020450001
    KROSSA, Hubertus
    Panoramaweg 3
    65191
    Wiesbaden
    Germany
    Amministratore
    Panoramaweg 3
    65191
    Wiesbaden
    Germany
    GermanCompany Exeecutive54057150002
    LARKINS, Sarah Louise
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    Amministratore
    11 Bluebell Road
    Lindford
    GU35 0YN Bordon
    Hampshire
    BritishChartered Secretary99307280001
    LEWIS, Nigel Andrew
    The Linde Group The Priestley
    Centre 10 Priestley Rd The Surrey, Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Amministratore
    The Linde Group The Priestley
    Centre 10 Priestley Rd The Surrey, Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector Acquisitions & New Vent146324340001
    LOWERY, Robert Brian
    61 Earlswood Park
    NE9 6AZ Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    61 Earlswood Park
    NE9 6AZ Gateshead
    Tyne & Wear
    BritishGeneral Manager54245630001
    MOFFAT, Derek Peter
    Tryst Park
    EH10 7HD Edinburgh
    28
    Amministratore
    Tryst Park
    EH10 7HD Edinburgh
    28
    ScotlandBritishManager129061330002
    MOSTYN, Gareth
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    Amministratore
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road Surrey Research Park
    GU2 7XY Guildford
    Surrey
    BritishAccountant126699160001
    MULLER, Gerhard
    Am Eibenhang 6
    6581 Eppstein
    FOREIGN Germany
    Amministratore
    Am Eibenhang 6
    6581 Eppstein
    FOREIGN Germany
    GermanDirector40452970001
    NORRIS, David William Worsley
    Tidmarsh House
    Tidmarsh Lane, Pangbourne
    RG8 8HA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Tidmarsh House
    Tidmarsh Lane, Pangbourne
    RG8 8HA Reading
    Berkshire
    BritishChartered Accountant/Managing Director85579400001
    PALMER, Nathan
    The Priestley Centre, 10 Priestley Road
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group
    Surrey
    England
    Amministratore
    The Priestley Centre, 10 Priestley Road
    GU2 7XY Guildford
    The Linde Group
    Surrey
    England
    EnglandBritishHead Of Regional Sales & Marketing168273890001
    SCHLING, Falko
    Muehlenweg 3
    Hofheim 65719
    FOREIGN Germany
    Amministratore
    Muehlenweg 3
    Hofheim 65719
    FOREIGN Germany
    GermanCompany Executive68966340002
    SCHUPPAR, Helmut
    Konrad Adenauer Strasse 11
    Idstein
    D 65510 Hessen
    Germany
    Amministratore
    Konrad Adenauer Strasse 11
    Idstein
    D 65510 Hessen
    Germany
    GermanCompany Executive54057380001
    SIMMONDS, Peter John
    Cleveland House
    109 Pack Lane Kempshott
    RG22 5HH Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Cleveland House
    109 Pack Lane Kempshott
    RG22 5HH Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector108212170001
    SPENCE, Patrick Charles Gordon
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road
    GU2 7XY Surrey Research Park
    Surrey
    Amministratore
    The Linde Group The Priestley Centre
    10 Priestley Road
    GU2 7XY Surrey Research Park
    Surrey
    BritishChartered Accountant79853340013
    TANDLER, Gerold
    Am Burgerwald 17
    8X4524 Neuotting
    Bavaria
    Germany
    Amministratore
    Am Burgerwald 17
    8X4524 Neuotting
    Bavaria
    Germany
    GermanCompany Director54056820001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Forge
    Surrey
    England
    06 apr 2016
    43 Church Street West
    GU21 6HT Woking
    Forge
    Surrey
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleThe Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02122421
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RRS (FEBRUARY 2004) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 31 lug 1997
    Consegnato il 05 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a unit 13 hobso industrial estate burnopfield durham t/n DU209732, land and buildings at hobson industrial estate, burnopfield durham t/n du 164067, land and buildings at north alloy industrial estate pontardawe t/n wa 43610 and all other properties listed on the schedule attatched to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Linde Holdings Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0