THE UK OFFSHORE ENERGIES ASSOCIATION LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE UK OFFSHORE ENERGIES ASSOCIATION LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale |
| Numero di società | 01119804 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE UK OFFSHORE ENERGIES ASSOCIATION LIMITED?
- Attività di organizzazioni professionali di categoria (94120) / Altre attività di servizi
Dove si trova THE UK OFFSHORE ENERGIES ASSOCIATION LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Cannongate House 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE UK OFFSHORE ENERGIES ASSOCIATION LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| THE UK OIL AND GAS INDUSTRY ASSOCIATION LIMITED | 24 dic 2012 | 24 dic 2012 |
| THE UNITED KINGDOM OFFSHORE OIL AND GAS INDUSTRY ASSOCIATION LIMITED | 24 apr 2007 | 24 apr 2007 |
| U.K. OFFSHORE OPERATORS ASSOCIATION LIMITED | 25 giu 1973 | 25 giu 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE UK OFFSHORE ENERGIES ASSOCIATION LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THE UK OFFSHORE ENERGIES ASSOCIATION LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 09 dic 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 23 dic 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 09 dic 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per THE UK OFFSHORE ENERGIES ASSOCIATION LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 09 dic 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Neil James Mcculloch come amministratore in data 01 gen 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Camilla Salthe come amministratore in data 31 dic 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Edward Roddy come amministratore in data 31 dic 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven David Bowyer come amministratore in data 30 nov 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew John Brodie come amministratore in data 06 nov 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Martin Cox come amministratore in data 17 set 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2024 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Jillian Owen come amministratore in data 13 mar 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 39 pagine | MA | ||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Nomina di Mrs Diane Francoise Agnes Frachon come amministratore in data 05 feb 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Luciano Maria Vasques come amministratore in data 05 feb 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Barry John Macleod come amministratore in data 05 feb 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Nathan Paul Morgan come amministratore in data 05 feb 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil James Mcculloch come amministratore in data 05 feb 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Harris come amministratore in data 15 ott 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Paternoster House 1st Floor 65 st Paul's Churchyard London EC4M 8AB England a Cannongate House 2nd Floor 62-64 Cannon Street London EC4N 6AE in data 06 gen 2025 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Camilla Salthe come amministratore in data 18 set 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sayma Cox come amministratore in data 10 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 dic 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2023 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Arne Gurtner come amministratore in data 31 ago 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Abderrehmane Beloucif come amministratore in data 15 ago 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE UK OFFSHORE ENERGIES ASSOCIATION LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELGIE, Graham | Segretario | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | 165709110001 | |||||||
| BARR, Scott | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | British | 313787450001 | |||||
| COX, Christopher Martin | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | England | British | 115341280003 | |||||
| DRUMMOND, Robert Sommerville | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | British | 84360450003 | |||||
| FRACHON, Diane Francoise Agnes | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | England | French | 324262130001 | |||||
| MACLEOD, Barry John | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | British | 157306160002 | |||||
| MCCULLOCH, Neil James | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | British | 194750980002 | |||||
| MILTON, Philip Stephen | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | British | 72762500003 | |||||
| MOORE, Sarah Robyn | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | British | 166922760003 | |||||
| MORGAN, Nathan Paul | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | England | British | 305696170001 | |||||
| NICOL, Stephen James | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | British | 162632260012 | |||||
| PAN, Yiyong | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | Chinese | 311719650002 | |||||
| PAYER, Nicolas | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | French | 304323980001 | |||||
| PEARSON, John Graham | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | United Kingdom | British | 291099510001 | |||||
| REITER, Doris Friederike | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | Austrian,American | 254720120001 | |||||
| VASQUES, Luciano Maria | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | United Kingdom | Italian | 328385110001 | |||||
| WHITEHOUSE, David Benjamin | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | British | 190468650001 | |||||
| WISELY, Stephen George | Amministratore | 2nd Floor 62-64 Cannon Street EC4N 6AE London Cannongate House England | Scotland | British | 195133350001 | |||||
| ESSEX, Nigel | Segretario | Second Floor 232-242 Vauxhall Bridge Road SW1V 1AU London | British | 61174120002 | ||||||
| VOLK, Kenneth Christopher | Segretario | 3 Hans Crescent SW1X 0LN London | British | 32115710001 | ||||||
| WEBB, Malcolm | Segretario | Grayscroft 32 Grays Lane KT21 1BU Ashtead Surrey | British | 76875120001 | ||||||
| ABBEY, Mark Antony | Amministratore | 1st Floor 65 St Paul's Churchyard EC4M 8AB London Paternoster House England | England | British | 314390500001 | |||||
| AFFLECK, Lewis Grant | Amministratore | 1 Hamilton Park SL6 4TB Maidenhead | United Kingdom | British | 97617060001 | |||||
| ALLAN, Robert Andrew | Amministratore | 1st Floor 65 St Paul's Churchyard EC4M 8AB London Paternoster House England | United Kingdom | British | 173055720001 | |||||
| ALTON, Russell Alexander | Amministratore | 1st Floor 65 St Paul's Churchyard EC4M 8AB London Paternoster House England | England | British | 276172990001 | |||||
| ANDERSON, Mary Grace | Amministratore | Derrywood Ramsay Road AB31 5TT Banchory | United States Citizen | 93232180001 | ||||||
| BALLARD, Gordon George Reid | Amministratore | Beechwood Avenue KT13 9TF Weybridge 4 Surrey United Kingdom | England | British | 106821230001 | |||||
| BELOUCIF, Abderrehmane | Amministratore | 1st Floor 65 St Paul's Churchyard EC4M 8AB London Paternoster House England | Scotland | French | 310311580001 | |||||
| BETTS, Matthew | Amministratore | Bressenden Place SW1E 5BH London 6th Floor East, Portland House | United Kingdom | British | 119391640001 | |||||
| BIRD, Christopher Terence | Amministratore | Bressenden Place SW1E 5BH London 6th Floor East, Portland House | Scotland | British | 187786850001 | |||||
| BLACKWOOD, David John | Amministratore | The Willows Dalmuinzie Road Bieldside AB15 9EB Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 109831990001 | |||||
| BLAKELEY, Alexander Paul | Amministratore | Old Montrose House DD10 9LN Montrose Angus | British | 46323710001 | ||||||
| BOOTH, Alan | Amministratore | 49 Grovewood Close WD3 5PX Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | 104760690001 | |||||
| BORGHESI, Gerrard Raymond | Amministratore | The Fairway KT13 0RZ Weybridge Greenside Cottage Surrey | England | Australian | 139196030001 | |||||
| BOWYER, Michael Lewis | Amministratore | Deveron Facility Howe Moss Place, Dyce AB21 0GS Aberdeen | British | 43449270009 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per THE UK OFFSHORE ENERGIES ASSOCIATION LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 09 dic 2016 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0