ASCOT ESTATES LIMITED

ASCOT ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASCOT ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01127031
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASCOT ESTATES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ASCOT ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASCOT ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BELHAVEN ESTATES LIMITED11 mag 199011 mag 1990
    LEDBURY ESTATES LIMITED07 ago 197307 ago 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASCOT ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per ASCOT ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert William Game il 01 feb 2013

    2 pagineCH01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    2 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE in data 31 dic 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 dic 2012

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 apr 2012

    Stato del capitale al 05 apr 2012

    • Capitale: GBP 449,558
    SH01

    Cessazione della carica di Vinod Bachulal Vaghela come amministratore in data 21 dic 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert William Game come amministratore in data 13 ott 2011

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Philip Warner come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Game come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    8 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine88(2)

    legacy

    2 pagine123

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di aumento del capitale sociale autorizzato

    RES04
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ASCOT ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Segretario
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    GAME, Robert William
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Olympia House
    Amministratore
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Olympia House
    United KingdomEnglish139555050001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Amministratore
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Segretario
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    JONES, William Rhodri
    28 Burnham Road
    Knaphill
    GU21 2AE Woking
    Surrey
    Segretario
    28 Burnham Road
    Knaphill
    GU21 2AE Woking
    Surrey
    British75686880001
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Segretario
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Segretario
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    Segretario
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    69324550001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    FERGUSON, Daniel
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish29071630001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Amministratore
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    GAME, Robert William
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    Amministratore
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United KingdomEnglish139555050001
    GRANT, John Albert Martin
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish55161940001
    HEATHWOOD, Derek Kevin
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    Amministratore
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    British85468580002
    HEWITT, Edwin John
    Rushkin
    260 Old Bedford Road
    LU2 7EA Luton
    Beds
    Amministratore
    Rushkin
    260 Old Bedford Road
    LU2 7EA Luton
    Beds
    British19723670001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118074370001
    MEYERS, Richard John
    84 Hemingford Road
    Islington
    N1 1DD London
    Amministratore
    84 Hemingford Road
    Islington
    N1 1DD London
    British71241210001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    British73793650001
    MURSALEEN, Zia
    53 Leatherhead Road
    KT21 2TP Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    53 Leatherhead Road
    KT21 2TP Ashtead
    Surrey
    EnglandBritish35570020001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Amministratore
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Amministratore
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Amministratore
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE DIRECTORS LIMIYED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    Amministratore
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    67372750003

    ASCOT ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 dic 1998
    Consegnato il 07 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC.as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 07 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 mag 1995
    Consegnato il 15 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to barclays bank PLC as trustee for the beneficiaries under the terms of various documents (all as defined)
    Brevi particolari
    F/H land adjoining the albion public house k/a 164 manchester road, longroyd bridge, huddersfield; l/h land adjoining the rope and anchor public house 132 halifax road, tormorden t/nos: YK12686 and WYK445169. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 22 dic 1994
    Consegnato il 04 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors to the chargee under the terms of or in respect of various documents (all as defined)
    Brevi particolari
    F/H-the new inn public house, 425 huddersfield road wyke BD12 8NP t/n-WYK445174. F/h-the golden lion public house t/n-SGL172632. L/h-the star inn, 63 bridge street, bury t/n-GM567441. F/h-12 market street, birkenhead and being part of the glass barrel t/n-MS302974. F/h-the commercial hotel, 1 manchester road, haslingden t/n-LA665726. F/h-26 lees road, tyldesley, greater manchester, H29 8HS and being part of the railway inn t/n-GM567437. And all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time on such f/h, l/h and other immoveable property.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee on Behalf of the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 04 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 21 dic 1994
    Consegnato il 10 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    An amount equal to the top up liability (as such sum is defined in the standstill agreement dated 20TH may 1993 as amended and restated on 21 december 1994) due and owing by ascot holdings PLC to the chargee less all monies paid or realised in reduction thereof
    Brevi particolari
    Floating charge all the undertaking and all the property and assets of the company both present and future other than the excluded joint ventures.
    Persone aventi diritto
    • The Yasuda Trust & Banking Co., Limited
    Transazioni
    • 10 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 1994
    Consegnato il 29 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the mezzanine charge and mezzanine debt instrument both dated 21ST december 1994
    Brevi particolari
    Various properties as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eletra Kingsway Limitedthe "Security Trustee"
    Transazioni
    • 29 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 20 dic 1993
    Consegnato il 24 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of various documents all as defined
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time on such f/h, l/h and othe immoveable property.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 17 giu 1993
    Consegnato il 23 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of this charge (the "secured obligations")
    Brevi particolari
    Floating charge of the company both present and future other than the excluded joint ventures. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Yasuda Trust & Banking Co. Limited
    Transazioni
    • 23 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 01 giu 1993
    Consegnato il 10 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due fro any of the obligors (as defined) to the chargee under or in respect of various documents (all as defined)
    Brevi particolari
    F/H-the rope & anchor, 132 halifax road, todmorden, lancashire. T/n-WYK445165. F/h-the travellers rest, 508 rochdale road, rossendale, lancashire, OL13 9SD. T/n-LA621811 (for full details of charge see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee on Behalf of the Beneficiaries
    Transazioni
    • 10 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    190593
    Creato il 19 mag 1993
    Consegnato il 03 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the floating charge (the guaranteed obligations as defined)
    Brevi particolari
    All the property and assets of the company both present and future other than the property set out in annex 2. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Tokyo International Limitedthe "Security Trustee"
    Transazioni
    • 03 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of ,charge
    Creato il 17 feb 1993
    Consegnato il 19 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to barclays bank PLC as security trustee on behalf of the beneficiaries (as defined) under the terms of a loan agreement dated 20 july 1989 and/or this deed of charge.
    Brevi particolari
    In favour of the security trustee on behalf of all of the beneficiaries,by way of first fixed charge (which so far as it relates to land in england and wales vested in any of the companies at the date of charge shall be a charge by way of legal mortgage) the belhaven estates limited property being the f/h l/h property owned by the chargor specified in the first schedule of the charge (see relevant form 395 and continuation sheets for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 21 dic 1992
    Consegnato il 22 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of various documents (all as defined)
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the belhaven estates limited see relevant form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 20 nov 1992
    Consegnato il 24 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the security documents (all as defined)
    Brevi particolari
    All buildings trade and other fixtures fixed plant and machiney from time to time (for full details see form 395 and contd sheets).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 24 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 30 set 1992
    Consegnato il 06 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or any of the other companies named therein to the chargee under theterms of the security agreements as defined
    Brevi particolari
    The control property the belhaven estates property the belhaven hotels property see form 395 ref m*115.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 31 lug 1992
    Consegnato il 13 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the security documents
    Brevi particolari
    The intellectual property and assets as specified in form 395 ref M103.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed fo charge
    Creato il 23 lug 1992
    Consegnato il 06 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the various deeds and documents as defined in this charge
    Brevi particolari
    First fixed charge over the real property and assignment on all right title and interest on all rights and claims in relation to the policies (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 set 1991
    Consegnato il 18 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from control securities PLC and any other borrower or obliger as defined under the terms of the secured obligations
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 17 lug 1991
    Consegnato il 19 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/Hold - the gray coat bay public house, 92 roan street london SE10 9JT t/no. Ln 35288 and fixed charge over the company's right title and interest in and to any proceeds of any insurance flaoting charge over (see form 395 for fulldetails). Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Grand Metropolitan PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 02 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 apr 1990
    Consegnato il 12 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 16/2/90
    Brevi particolari
    L/H property k/a the drayman arms 44 little london spalding lincolnshire. For further particulars see form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Grand Metropolitan PLC.
    Transazioni
    • 12 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 apr 1990
    Consegnato il 12 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 16/2/90
    Brevi particolari
    L/H property k/a the don johns cross 312 church road bristol. For further particlars see form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Grand Metropolitan PLC.
    Transazioni
    • 12 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 apr 1990
    Consegnato il 12 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 16/2/9/
    Brevi particolari
    L/H property k/a the dog & fox 33 ashley road bradford-on-avon BA15 1RT. For further particulars see form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Grand Metropolitan PLC.
    Transazioni
    • 12 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 apr 1990
    Consegnato il 12 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 16/2/90
    Brevi particolari
    L/H property k/a the crown. High street. Doncaster DB6 opb. For further particulars see form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Grand Metropolitan PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 apr 1990
    Consegnato il 12 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 16/2/90
    Brevi particolari
    L/H property k/a the crown russell road shepperton for further particulars see form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Grand Metroplitan PLC.
    Transazioni
    • 12 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 apr 1990
    Consegnato il 12 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 16/2/90
    Brevi particolari
    L/H property k/a the corwn 12 church street seaford for further particulars see form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Grand Metropolitn PLC.
    Transazioni
    • 12 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 apr 1990
    Consegnato il 12 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 16/2/90
    Brevi particolari
    L/H property k/a the crown 29 perry street gravesend. For further particulars see form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Grand Metropolitan PLC.
    Transazioni
    • 12 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 apr 1990
    Consegnato il 12 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 16/2/90
    Brevi particolari
    L/H proeprty k/a the cross inn 142 woodfield street swansea. For further particulars see form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Grand Metropolitan PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ASCOT ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 giu 2013Data di scioglimento
    19 dic 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Praticante
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0