ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01129454 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES PLC | 16 ago 1973 | 16 ago 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 011294540025 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 011294540026 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Ben Jenkins come amministratore in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Philip Simon Slavin come amministratore in data 13 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 13 dic 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Angus Alexander Dodd come amministratore in data 07 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 03 apr 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 15 feb 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAZELL, Frances Victoria | Segretario | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | 215875630001 | |||||||
| SAUNDERS, James Michael Edward | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 192568400002 | |||||
| SLAVIN, Philip Simon | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 267205160001 | |||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Segretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Segretario | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| GIBSON, Timothy David | Segretario | 52a Grenville Road N19 4EH London | British | 50070710001 | ||||||
| HUGHES, Paul | Segretario | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Segretario | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175104150001 | |||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Segretario | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Segretario | 17 Field Close Locks Heath SO31 6TX Southampton Hampshire | British | 58498140001 | ||||||
| WOOLLEY, Peter Thomas Griffith | Segretario | 2 Fernsleigh Close SL9 0HR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 39676720001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Segretario | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| AL-SAGER, Mohammed Jassem | Amministratore | Dahiyat Abdullah Al Salem Area 4 Street No 43 Viilla 24 FOREIGN Kuwait City Kuwaiti | British | 36413770001 | ||||||
| ARRA, Giorgio | Amministratore | 26 Hereford House 66 North Row W1R 1DE London | Italian | 71142090001 | ||||||
| BROOKER, Alfred Thomas | Amministratore | Crispin The Approach, Dormans Park RH19 3NU East Grinstead West Sussex | England | British | 29444930001 | |||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 184444990001 | |||||
| CLARK, James Robert | Amministratore | Logmore 37 The Avenue SM2 7QA Cheam Surrey | United Kingdom | British | 52063220001 | |||||
| DEAR, Michael Raymond | Amministratore | 16 Calvin Close GU15 1DN Camberley Surrey | British | 11171470001 | ||||||
| DODD, Angus Alexander | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 201606390001 | |||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Amministratore | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | 35942980003 | |||||
| DWYER, Tonianne | Amministratore | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Amministratore | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Amministratore | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| GREENSLADE, Daniel Mark | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 196504990001 | |||||
| HAMILTON STUBBER, James Robert | Amministratore | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | 84913850002 | |||||
| HOOPER, Patrick Paul | Amministratore | Thornfield 92 Station Road Balsall Common CV7 7FL Coventry West Midlands | British | 455570001 | ||||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 164108510003 | |||||
| JENKINS, Michael Ben | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 221017630001 | |||||
| KATZ, Jonathan | Amministratore | 60 Mount Ephraim Lane SW16 1JD London | England | British | 33805490001 | |||||
| KNIGHT, Eric | Amministratore | 7 Boulevard Des Moulins MC9800 Monaco | Italian | 55114600003 | ||||||
| LAZARUS, James Nicholas | Amministratore | Misbourne 47 Foxdell Way Chalfont St Peter SL9 0PL Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 8315580001 | |||||
| PARRY, John Richard | Amministratore | High Barn The Paddocks Dog Kennel Lane WD3 5EE Chorleywood Hertfordshire | British | 2995850001 | ||||||
| RILEY, Michael Edward | Amministratore | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SANDERSON, Eric Fenton | Amministratore | 10 Harelaw Road EH13 0DR Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 126848980001 | |||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Amministratore | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintain Limited | 06 apr 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 03 nov 2017 Consegnato il 07 nov 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione None. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 03 nov 2016 Consegnato il 15 nov 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge security agreement | Creato il 14 mar 2008 Consegnato il 17 mar 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari First floating charge all its assets see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A security agreement | Creato il 04 feb 2008 Consegnato il 15 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A security agreement | Creato il 29 gen 2008 Consegnato il 07 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A security agreement | Creato il 29 gen 2008 Consegnato il 01 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 22 ott 2007 Consegnato il 25 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 26 ott 2005 Consegnato il 11 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 26 ott 2005 Consegnato il 11 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage by way of assignment | Creato il 03 mar 2000 Consegnato il 09 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under a legal mortgage dated 25TH march 1999 | |
Brevi particolari All the company's rights title and interest in and to a building contract dated 4TH october 1999 made between holmes building PLC (1) and the company (2) (the "building contract").. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 25 mar 1999 Consegnato il 30 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Property k/a land lying to the north of holloway lane harmondsworth hillingdon t/n AGL17932 along with the goodwill of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 07 dic 1998 Consegnato il 11 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever except for any obligation which, if it were so included, would result in a contravention of section 151 of the companies act 1985 | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 mag 1998 Consegnato il 08 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 22 buckingham gate l/b of city of westminster t/n 61747. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 09 gen 1998 Consegnato il 17 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H mevile house 8 10 & 12 woodhouse road finchley london N3 t/n NGL429496. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 14 feb 1996 Consegnato il 20 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 29 buckingham gate, l/b of city of westminster t/no: 44712. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Shares charge | Creato il 23 gen 1995 Consegnato il 31 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under each of a credit agreement of even date,the debenture dated 26TH january 1995,the subordination deed dated 23RD january 1995 and this charge | |
Brevi particolari 100 ordinary shares of £1 each fully paid up and 50,000 ordinary £1 shares paid up as to 25 pence each in the issued capital; all other shares in english & overseas investments PLC.......all stocks,shares and other securities.............etc.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 apr 1989 Consegnato il 06 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 77 st john street, london EC1. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 apr 1989 Consegnato il 14 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The coalyard marsh lane hampton in arden west midlands t/n wm 441272. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 apr 1989 Consegnato il 14 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Enterprise house fentham road hampton in arden west midlands t/nos: wm 294348 & wm 439700. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 04 lug 1988 Consegnato il 13 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or blegberry limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari F/H property k/a 94 & 94A st john's wood high street london NW8 T.N. ln 104564. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 lug 1988 Consegnato il 12 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 28/30 coppergate york north yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 lug 1988 Consegnato il 12 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 5/6 horsemarket darlington durham. Title no:- du 22186. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 lug 1988 Consegnato il 12 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at pembroke park waterbeach cambridge cambridgeshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 lug 1988 Consegnato il 12 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at maskell road and garratt lane l/b of wandsworth. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 lug 1988 Consegnato il 12 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 17 st sepulchre gate doncaster south yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0