ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED

ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01129454
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES PLC16 ago 197316 ago 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 011294540025 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 011294540026 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Michael Ben Jenkins come amministratore in data 31 dic 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Philip Simon Slavin come amministratore in data 13 feb 2020

    2 pagineAP01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 13 dic 2019

    • Capitale: GBP 100
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    The company capital redemption reserve account of the company be cancelled 09/12/2019
    RES13

    Cessazione della carica di Angus Alexander Dodd come amministratore in data 07 nov 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mag 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 03 apr 2018

    • Capitale: GBP 100
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium a/c cancelled 12/03/2018
    RES13

    Stato del capitale al 15 feb 2018

    • Capitale: GBP 100
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Chi sono gli amministratori di ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEAZELL, Frances Victoria
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    215875630001
    SAUNDERS, James Michael Edward
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish192568400002
    SLAVIN, Philip Simon
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish267205160001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Segretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Segretario
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    GIBSON, Timothy David
    52a Grenville Road
    N19 4EH London
    Segretario
    52a Grenville Road
    N19 4EH London
    British50070710001
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Segretario
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175104150001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    ROBSON SKEETE, Gail
    17 Field Close
    Locks Heath
    SO31 6TX Southampton
    Hampshire
    Segretario
    17 Field Close
    Locks Heath
    SO31 6TX Southampton
    Hampshire
    British58498140001
    WOOLLEY, Peter Thomas Griffith
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Segretario
    2 Fernsleigh Close
    SL9 0HR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British39676720001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Segretario
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    AL-SAGER, Mohammed Jassem
    Dahiyat Abdullah Al Salem
    Area 4 Street No 43 Viilla 24
    FOREIGN Kuwait City Kuwaiti
    Amministratore
    Dahiyat Abdullah Al Salem
    Area 4 Street No 43 Viilla 24
    FOREIGN Kuwait City Kuwaiti
    British36413770001
    ARRA, Giorgio
    26 Hereford House
    66 North Row
    W1R 1DE London
    Amministratore
    26 Hereford House
    66 North Row
    W1R 1DE London
    Italian71142090001
    BROOKER, Alfred Thomas
    Crispin
    The Approach, Dormans Park
    RH19 3NU East Grinstead
    West Sussex
    Amministratore
    Crispin
    The Approach, Dormans Park
    RH19 3NU East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritish29444930001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish184444990001
    CLARK, James Robert
    Logmore 37 The Avenue
    SM2 7QA Cheam
    Surrey
    Amministratore
    Logmore 37 The Avenue
    SM2 7QA Cheam
    Surrey
    United KingdomBritish52063220001
    DEAR, Michael Raymond
    16 Calvin Close
    GU15 1DN Camberley
    Surrey
    Amministratore
    16 Calvin Close
    GU15 1DN Camberley
    Surrey
    British11171470001
    DODD, Angus Alexander
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish201606390001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Amministratore
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritish35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Amministratore
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Amministratore
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritish151855940001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Amministratore
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritish84913850002
    HOOPER, Patrick Paul
    Thornfield 92 Station Road
    Balsall Common
    CV7 7FL Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    Thornfield 92 Station Road
    Balsall Common
    CV7 7FL Coventry
    West Midlands
    British455570001
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish164108510003
    JENKINS, Michael Ben
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish221017630001
    KATZ, Jonathan
    60 Mount Ephraim Lane
    SW16 1JD London
    Amministratore
    60 Mount Ephraim Lane
    SW16 1JD London
    EnglandBritish33805490001
    KNIGHT, Eric
    7 Boulevard Des Moulins
    MC9800 Monaco
    Amministratore
    7 Boulevard Des Moulins
    MC9800 Monaco
    Italian55114600003
    LAZARUS, James Nicholas
    Misbourne 47 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Misbourne 47 Foxdell Way
    Chalfont St Peter
    SL9 0PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish8315580001
    PARRY, John Richard
    High Barn The Paddocks
    Dog Kennel Lane
    WD3 5EE Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    High Barn The Paddocks
    Dog Kennel Lane
    WD3 5EE Chorleywood
    Hertfordshire
    British2995850001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SANDERSON, Eric Fenton
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    10 Harelaw Road
    EH13 0DR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish126848980001
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Amministratore
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2694983
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ENGLISH & OVERSEAS PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2017
    Consegnato il 07 nov 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Homes and Communities Agency
    Transazioni
    • 07 nov 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2016
    Consegnato il 15 nov 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch, 90 Long Acre, London, WC2E 9RA (As Common Security Agent for Each of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 15 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge security agreement
    Creato il 14 mar 2008
    Consegnato il 17 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 17 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 04 feb 2008
    Consegnato il 15 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 15 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 07 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 07 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 01 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 01 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 22 ott 2007
    Consegnato il 25 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 26 ott 2005
    Consegnato il 11 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 26 ott 2005
    Consegnato il 11 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first floating charge all its assets not at any time othererwise effectively mortgages charged of assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage by way of assignment
    Creato il 03 mar 2000
    Consegnato il 09 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a legal mortgage dated 25TH march 1999
    Brevi particolari
    All the company's rights title and interest in and to a building contract dated 4TH october 1999 made between holmes building PLC (1) and the company (2) (the "building contract").. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Wales PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 mar 1999
    Consegnato il 30 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land lying to the north of holloway lane harmondsworth hillingdon t/n AGL17932 along with the goodwill of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Wales PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 11 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever except for any obligation which, if it were so included, would result in a contravention of section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mag 1998
    Consegnato il 08 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    22 buckingham gate l/b of city of westminster t/n 61747.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 gen 1998
    Consegnato il 17 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H mevile house 8 10 & 12 woodhouse road finchley london N3 t/n NGL429496.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 feb 1996
    Consegnato il 20 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    29 buckingham gate, l/b of city of westminster t/no: 44712.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Shares charge
    Creato il 23 gen 1995
    Consegnato il 31 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under each of a credit agreement of even date,the debenture dated 26TH january 1995,the subordination deed dated 23RD january 1995 and this charge
    Brevi particolari
    100 ordinary shares of £1 each fully paid up and 50,000 ordinary £1 shares paid up as to 25 pence each in the issued capital; all other shares in english & overseas investments PLC.......all stocks,shares and other securities.............etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 31 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 1989
    Consegnato il 06 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    77 st john street, london EC1.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 06 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 apr 1989
    Consegnato il 14 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The coalyard marsh lane hampton in arden west midlands t/n wm 441272.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 apr 1989
    Consegnato il 14 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Enterprise house fentham road hampton in arden west midlands t/nos: wm 294348 & wm 439700.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 lug 1988
    Consegnato il 13 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or blegberry limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/H property k/a 94 & 94A st john's wood high street london NW8 T.N. ln 104564.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 12 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    28/30 coppergate york north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 12 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5/6 horsemarket darlington durham. Title no:- du 22186.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 12 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at pembroke park waterbeach cambridge cambridgeshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 12 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at maskell road and garratt lane l/b of wandsworth.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 12 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    17 st sepulchre gate doncaster south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0