AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED

AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01130005
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor 5 Merchant Square
    W2 1AS London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    A.I.R. RADIO PRODUCTIONS LIMITED20 ago 197320 ago 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    L53TUZLC

    Bilancio annuale redatto al 13 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 feb 2016

    Stato del capitale al 07 feb 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01
    X508H0V5

    Cessazione della carica di Mark David Ranyard come amministratore in data 21 dic 2015

    1 pagineTM01
    X4MP7G6O

    Nomina di Mrs Erika Brennan come segretario in data 01 nov 2015

    2 pagineAP03
    X4KDB4BF

    Nomina di Mr Paul Jonathan Wilson come amministratore in data 01 ott 2015

    2 pagineAP01
    X4HWL2C2

    Cessazione della carica di John Leslie Dobinson come amministratore in data 11 giu 2015

    1 pagineTM01
    X4A34DX5

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Maximilian Dressendoerfer il 26 mag 2015

    2 pagineCH01
    X487CBG8

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark David Ranyard il 26 mag 2015

    2 pagineCH01
    X487CB4H

    Dettagli del direttore cambiati per Hartwig Masuch il 26 mag 2015

    2 pagineCH01
    X487CBFK

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Alexi Cory-Smith il 26 mag 2015

    2 pagineCH01
    X487CB9G

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Leslie Dobinson il 26 mag 2015

    2 pagineCH01
    X487CBF4

    Indirizzo della sede legale modificato da 33 Wigmore Street London W1U 1QX a 8th Floor 5 Merchant Square London W2 1AS in data 26 mag 2015

    1 pagineAD01
    X487B3KB

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    23 pagineAA
    A44XA6NS

    Bilancio annuale redatto al 13 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2015

    Stato del capitale al 28 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01
    X400TSPM

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Maximilian Dressendoerfer il 17 ott 2014

    2 pagineCH01
    X3K45B2R

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Alexi Cory-Smith il 17 ott 2014

    2 pagineCH01
    X3K1KP8R

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark David Ranyard il 17 ott 2014

    2 pagineCH01
    X3K1JVC3

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN England a Simons Muirhead & Burton 8-9 Frith Street London England W1D 3JB

    1 pagineAD02
    X3DUC5GZ

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Davenport Lyons 6 Agar Street London WC2N 4HN

    1 pagineAD03
    X3DUD0O9

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    23 pagineAA
    A39PNQM8

    Cessazione della carica di Julian French come segretario

    1 pagineTM02
    X34TLBOI

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03
    X30MYU6W

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02
    X30MYU6G

    Chi sono gli amministratori di AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRENNAN, Erika
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Segretario
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    202754140001
    CORY-SMITH, Alexi
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishSenior Vice President130148150002
    DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    GermanyGermanNone157717080010
    MASUCH, Hartwig
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    GermanyGermanChief Executive Officer157716080001
    WILSON, Paul Jonathan
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector201764770001
    FRENCH, Julian
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    181311950001
    HARVEY, Simon
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    Segretario
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    United Kingdom
    British159313010001
    MOLLETT, Andrew John
    Crieff Road
    Wandsworth
    SW18 2EB London
    19
    United Kingdom
    Segretario
    Crieff Road
    Wandsworth
    SW18 2EB London
    19
    United Kingdom
    British84808940002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    BURGESS, John Edward
    2 Sudbury Hill
    Harrow On The Hill
    HA1 3SB Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    2 Sudbury Hill
    Harrow On The Hill
    HA1 3SB Harrow
    Middlesex
    BritishManaging Director1987530001
    BUTTERFIELD, Nigel Robert Adamson
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    Amministratore
    Bullrush Farm Hillgrove
    Lurgashall
    GU28 9EP Petworth
    West Sussex
    United KingdomBritishFinancial Director36186210001
    CONNOLE, Michael Damien
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    Amministratore
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    EnglandIrishAccountant47934750001
    DOBINSON, John Leslie
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Operating Officer34942720003
    FENTON, Neil Robert
    2 Arbuthnot Road
    SE14 5NP New Cross
    London
    Amministratore
    2 Arbuthnot Road
    SE14 5NP New Cross
    London
    United KingdomBritishChartered Accountant39021340002
    LASCELLES, Robert Jeremy Hugh, Mr.
    Keble Place
    SW13 8HL London
    15
    United Kingdom
    Amministratore
    Keble Place
    SW13 8HL London
    15
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector150637740002
    LEWIS, Stephen Graeme
    40 Litchfield Way
    NW11 6NG London
    Amministratore
    40 Litchfield Way
    NW11 6NG London
    BritishMusic Publisher34323630001
    MOLLETT, Andrew John
    Crieff Road
    Wandsworth
    SW18 2EB London
    19
    United Kingdom
    Amministratore
    Crieff Road
    Wandsworth
    SW18 2EB London
    19
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant84808940002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritishCompany Secretary3182530002
    RANYARD, Mark David
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Merchant Square
    W2 1AS London
    8th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director154884950002

    AIR MANAGEMENT SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture between chrysalis music limited (the borrower) each of the chargors (as defined) and music finance corp. (The "mf lender")
    Creato il 02 mar 2001
    Consegnato il 22 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    A covenant by the borrower with the mf lender to discharge each and every liability which the chargors may now or hereafter have to the mf lender under or pursuant to the facility agreement the debenture or any other chrysalis transaction document and to discharge or pay to the mf lender when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) now or hereafter owing due or incurred by chargors to the mf lender in respect of any such liabilities in accordance with the terms set out in the facility agreement the debenture or any other chrysalis transaction document (the "secured amounts")
    Brevi particolari
    All of the company's right title benefit and interest in and to each of the chrysalis transaction documents to which it is a party including a). The facility agreement b). The assignment agreement dated 2ND march 2001 between, inter alia,chrysalis music publishing B.V. and chrysalis music international B.V. c). The assignment agreement dated 2ND march 2001 between the mf lender,the borrower and chrysalis music publishing limited, d). The master admistration agreement e). The hedge agreement f). The german security agreement dated 27TH february 2001 between fanfare kg and the borrower g). The assignment agreement dated 2ND march 2001 between acsl, the borrower and air chrysalis scandinavia ab and h). The hedge administration agreement together with floating charge over all undertaking and assets other than assets charged by way of fixed charge above.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Music Finance Corp. (The "Mf Lender")
    Transazioni
    • 22 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0