CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED

CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCITY & THAMES PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01130323
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O THRINGS LLP
    Kinnaird House
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOUTH THAMES PROPERTIES LIMITED 15 ott 199315 ott 1993
    E.W.A. SECURITIES LIMITED21 ago 197321 ago 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rinvio della dissoluzione

    1 pagineL64.04

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 29 dic 2015 al 28 dic 2015

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 dic 2015 al 29 dic 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 gen 2016

    Stato del capitale al 04 gen 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Ewa Maria Lewis il 15 set 2015

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Meredith Lewis il 15 set 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 dic 2014

    5 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2014 al 30 dic 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2015

    Stato del capitale al 04 feb 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 feb 2014

    Stato del capitale al 03 feb 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 28 feb 2013 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 ago 2012 al 28 feb 2013

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Thring Townsend Kinnaird House 1 Pall Mall East London SW1Y 5AU* in data 16 gen 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2009

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEWIS, Ewa Maria
    Horn Lane
    Evenlode
    GL56 0NT Moreton-In-Marsh
    The Old Forge
    Gloucestershire
    England
    Segretario
    Horn Lane
    Evenlode
    GL56 0NT Moreton-In-Marsh
    The Old Forge
    Gloucestershire
    England
    British33321140004
    LEWIS, Anthony Meredith
    Ovington Street
    SW3 2JB London
    14
    United Kingdom
    Amministratore
    Ovington Street
    SW3 2JB London
    14
    United Kingdom
    United KingdomBritish42617910002
    CODY, Nicholas John
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y ODX Blackfriars
    London
    Segretario
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y ODX Blackfriars
    London
    British1611240001
    HAND, Stephen Brian
    61 Chigwell Park Drive
    IG7 5AZ Chigwell
    Essex
    Amministratore
    61 Chigwell Park Drive
    IG7 5AZ Chigwell
    Essex
    British52239970002
    LEWIS, Alexander Edward Meredith
    Hampnett House
    Northleach
    GL54 3NN Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Hampnett House
    Northleach
    GL54 3NN Cheltenham
    Gloucestershire
    British85515130001
    LEWIS, Ewa Maria Anna
    C/O Taylor Joynson Garrett
    10 Maltravers Street
    WC2R 3BS London
    Amministratore
    C/O Taylor Joynson Garrett
    10 Maltravers Street
    WC2R 3BS London
    British33321140002

    Chi sono le persone con controllo significativo di CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Anthony Meredith Lewis
    c/o C/O THRINGS LLP
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AU London
    Kinnaird House
    06 apr 2016
    c/o C/O THRINGS LLP
    1 Pall Mall East
    SW1Y 5AU London
    Kinnaird House
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over shares
    Creato il 14 gen 2004
    Consegnato il 21 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and any right title & interest which the company holds in one ordinary share of £1 in the share capital of city & thames (fetter lane) limited including any other stocks, shares, securities or property, the proeceeds of sale of the securities and all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 21 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 set 2003
    Consegnato il 03 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    St clements house bell lane spitalfields stepney london tower hamlets t/n LN95726. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 set 2003
    Consegnato il 03 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1999
    Consegnato il 14 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 4-10 (formerly k/a 4-8 (even numbers) leyden street 11-19 (odd numbers) cobb street and 9-17 (odd numbers) bell lane london E1 t/no LN95726. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1999
    Consegnato il 14 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 33 and 35 baylis road lambeth t/no SGL372830 & LN227408. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 ott 1997
    Consegnato il 29 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Restriction on charges and disposals:- the company may not without the previous written consent of the bank create or attempt to create any mortgage charge or encumbrance on any freehold or leasehold property of the company or any other asset subject to a fixed charge under the debenture nor in any way dispose of the equity of redemption thereof or any interest therein. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 apr 1997
    Consegnato il 07 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,144,250 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    27 minories london EC3.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Scb Pension Scheme
    Transazioni
    • 07 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 dic 1995
    Consegnato il 15 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land k/as 337 kennington lane.t/no.SGL286005 together with all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery thereon held or owned by the company please see ch microfiche for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 15 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 giu 1994
    Consegnato il 04 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a 337 kennington lane t/no: SGL286005 .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 04 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 dic 1987
    Consegnato il 10 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    18 denbigh terrace london W11 T.N. 458615 &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1982
    Consegnato il 22 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 31 cumberland street, parts 31 clarenden street, london SW1. Title no. Ngl 61616 & 123039.
    Persone aventi diritto
    • Lazard Brothers & Co. (Jersey) Limited
    Transazioni
    • 22 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 08 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 apr 1981
    Consegnato il 15 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises situate at & known as:- 103 & 105 alderley street in the city of westminster.
    Persone aventi diritto
    • Lazard Brothers & Co (Jersey) Limited
    Transazioni
    • 15 mag 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 08 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 ott 1976
    Consegnato il 02 nov 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    13 redcliffe street london SW10. Title no ln 167373. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 08 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 ott 1976
    Consegnato il 25 ott 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property known as 24 clivden place london SW1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 08 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CITY & THAMES PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 ago 2016Data della petizione
    20 giu 2018Conclusione della liquidazione
    06 feb 2017Inizio della liquidazione
    06 apr 2023Data prevista di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0