P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED

P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàP.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01131488
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT a C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX in data 20 apr 2021

    2 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT in data 28 set 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 ago 2020

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 02 lug 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Deborah Grimason come amministratore in data 06 mar 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    1 pagineAA

    Nomina di Mr Alan Richard Williams come amministratore in data 11 lug 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Deborah Grimason il 13 ott 2016

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 giu 2016

    Stato del capitale al 01 giu 2016

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Cessazione della carica di John Peter Carter come amministratore in data 21 ott 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMS, Alan Richard
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137582690004
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03480295
    191205550001
    HARRIS, Jane Gwendoline
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    Segretario
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    British13905760001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Segretario
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    RICHARDSON, Barbara Jane
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    British48223350001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    EnglandBritish178011680002
    CARTER, John Peter
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish46226920007
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish104472550001
    ELLIOT, Colin Richard
    3 Meadow Crescent
    Castle Donington
    DE74 2LX Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    3 Meadow Crescent
    Castle Donington
    DE74 2LX Derby
    Derbyshire
    British13905780002
    GRIMASON, Deborah
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    EnglandBritish185755960002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    HARRIS, Jane Gwendoline
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    Amministratore
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    British13905760001
    HARRIS, Peter Christopher Peile
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    Amministratore
    Tithe Farm Barton Road
    Congerstone
    CV13 6NB Nuneaton
    Warks
    United KingdomBritish13905790002
    MCKAY, Francis John
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    British78787530001
    RICHARDSON, Barbara Jane
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    British48223350001
    RICHARDSON, Peter David
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    8 Wide Street
    Hathern
    LE12 5JH Loughborough
    Leicestershire
    British13905770002

    Chi sono le persone con controllo significativo di P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    P.C.P. Harris (Holdings) Limited
    Lodge Way
    Lodge Farm Industrial Estate
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    06 apr 2016
    Lodge Way
    Lodge Farm Industrial Estate
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione3679395
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 22 dic 1998
    Consegnato il 05 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 ago 1989
    Consegnato il 07 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property units 5 & 6 old station close, shepshed. Title no lt 124595 by way of equitable charge all moneys received of any insurance in respect of loss or damage by fire or otherwide to the buildings or any part being subject to the security.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 apr 1989
    Consegnato il 05 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 gen 1986
    Consegnato il 04 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over piece of land situate & having a frontage to trent lane, castle donington leics., Containing an area of 1.76 acres or thereabouts, together with all buildings fixtures fixed plant & machinery. All other l/h & f/h property together with buildings fixtures fixed plant & machinery. Goodwill, uncalled capital book & other debts. Floating charge over stock-on-trade, work-in-progress, pre payments investments all other undertaking & property & assets.
    Persone aventi diritto
    • Investor in Industry PLC.
    Transazioni
    • 04 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 23 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 giu 1985
    Consegnato il 10 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 dic 1982
    Consegnato il 13 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H units 5 & 6 old station close shepshed leicestershire by way of equi table charge all moneys received of any insurance whatsoever in respect of loss or damage by fire or otherwise to the buildings or any part thereof being subject to the security.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 05 nov 1979
    Consegnato il 07 nov 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of legal mortgage upon plot 5B old station close, shepshed, leics together with all buildings and fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Cooperation Limited
    Transazioni
    • 07 nov 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    P.C.P. HARRIS (BUILDERS MERCHANTS ) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 ago 2020Inizio della liquidazione
    28 set 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Praticante
    Mazars Llp 45 Church Street
    B3 2RT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0