TP SHELFCO NO.3 LIMITED

TP SHELFCO NO.3 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTP SHELFCO NO.3 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01132499
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BIRCHWOOD PRODUCTS LIMITED04 dic 199604 dic 1996
    J.B. SIMONS LIMITED04 set 197304 set 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 set 2021

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX in data 29 set 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG

    2 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    1 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 02 lug 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name26 set 2018

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 25 set 2018

    RES15

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Deborah Grimason come amministratore in data 06 mar 2018

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di John Peter Carter come amministratore in data 18 lug 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Deborah Grimason come amministratore in data 18 lug 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony David Buffin come amministratore in data 11 lug 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Alan Richard Williams come amministratore in data 11 lug 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMS, Alan Richard
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137582690004
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03480295
    191205550001
    BALL, Ute Suse
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    Segretario
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    British118371550001
    BOLLU, Pierre
    20 Lime Grove Avenue
    NG9 4AR Chilwell
    Nottinghamshire
    Segretario
    20 Lime Grove Avenue
    NG9 4AR Chilwell
    Nottinghamshire
    British92317380001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Segretario
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    158161020001
    SIMONS, John Barry
    28 Bromyard Terrace
    St Johns
    WR2 5BW Worcester
    Worcestershire
    Segretario
    28 Bromyard Terrace
    St Johns
    WR2 5BW Worcester
    Worcestershire
    British94492900001
    SIMONS, Pamela Helen
    12 Delville Avenue
    Keyworth
    NG12 5JA Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    12 Delville Avenue
    Keyworth
    NG12 5JA Nottingham
    Nottinghamshire
    British26705640001
    SMITH, Anthony Edward
    278 Heanor Road
    DE7 8TG Ilkeston
    Derbyshire
    Segretario
    278 Heanor Road
    DE7 8TG Ilkeston
    Derbyshire
    British36984820003
    BELL, Norman
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish106766000001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    EnglandBritish178011680002
    BURTON, Alan
    Beck House
    Hawthorn Close
    NG14 7HW Bleasby
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Beck House
    Hawthorn Close
    NG14 7HW Bleasby
    Nottinghamshire
    British79640650001
    CARTER, John Peter
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish46226920007
    COOPER, Geoffrey Ian
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish104472550001
    GREATOREX, Sue
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish177194840001
    GRIMASON, Deborah
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    EnglandBritish185755960002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish72135950007
    KAVANAGH, Carol
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish127248260001
    MEECH, Martin Richard
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    EnglandBritish108246880001
    MURRAY, John Roderick
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    Amministratore
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    United KingdomBritish145111310001
    OOSTEN, Jean-Jacques Michel Van
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBelgian177926250001
    PROCTOR, Robin David
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish117945650001
    SIMONS, John Barry
    28 Bromyard Terrace
    St Johns
    WR2 5BW Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    28 Bromyard Terrace
    St Johns
    WR2 5BW Worcester
    Worcestershire
    United KingdomBritish94492900001
    SIMPSON, Paul Anthony
    Field Farm Ember Lane
    Langham Road Langham
    LN13 9SL Mumby
    Lincolnshire
    Amministratore
    Field Farm Ember Lane
    Langham Road Langham
    LN13 9SL Mumby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish198094060001
    SKELTON, Steven Donald
    4 Conniston Close
    SL7 2RG Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    4 Conniston Close
    SL7 2RG Marlow
    Buckinghamshire
    British7330680001
    SLARK, Gavin
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    Amministratore
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    United KingdomBritish162972090001
    SMITH, Anthony Edward
    Bonita House
    11 Risborrow Close
    DE65 6HY Etwall
    Derbyshire
    Amministratore
    Bonita House
    11 Risborrow Close
    DE65 6HY Etwall
    Derbyshire
    United KingdomBritish36984820004
    SWANWICK, Paul
    59 Maple Avenue
    Beeston Rylands
    NG9 1PU Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    59 Maple Avenue
    Beeston Rylands
    NG9 1PU Nottingham
    Nottinghamshire
    British60218470001
    TALLENTIRE, Paul John
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lee Circle
    LE1 3QQ Leicester
    Fleet House
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish134335900002

    Chi sono le persone con controllo significativo di TP SHELFCO NO.3 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Travis Perkins Financing Company No.3 Limited
    Lodge Way
    Lodge Farm Industrial Estate
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    06 apr 2016
    Lodge Way
    Lodge Farm Industrial Estate
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione07180292
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TP SHELFCO NO.3 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 mag 2006
    Consegnato il 11 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 dic 2004
    Consegnato il 21 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a dg house, park lodge lane, giltbrook, nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 ott 2003
    Consegnato il 13 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property of the chargor situate in england and wales and all liens, charges, options, agreements, rights and interests in or over land or the proceeds of sale of land, and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on such property or land. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 ott 2003
    Consegnato il 11 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all other companies therein to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barry Simons
    Transazioni
    • 11 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ott 2003
    Consegnato il 11 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Unit 5 cossall industrial estate ilkeston derbyshire DE7 5UB.
    Persone aventi diritto
    • Barry Simons
    Transazioni
    • 11 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1997
    Consegnato il 13 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory premises at units 5 a, b, c & d cossall industrial estate coronation road cossall nottinghamshire t/n: NT287721.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 nov 1996
    Consegnato il 20 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 nov 1985
    Consegnato il 20 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 apr 1983
    Consegnato il 10 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at brand street nottingham title no nt 66141.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 gen 1980
    Consegnato il 09 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory premises at castle meadow rd nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 lug 1979
    Consegnato il 07 ago 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or needham and jackson LTD to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital with all buildings fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TP SHELFCO NO.3 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 set 2021Inizio della liquidazione
    09 dic 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon David Chandler
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0