GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED
Panoramica
Nome della società | GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01132901 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Christian Keen come amministratore in data 18 mag 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 7 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 apr 2022 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 26 mar 2021
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2020 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Marcus Hilger come amministratore in data 25 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Christian Keen come amministratore in data 25 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 set 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 set 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Marcus Hilger il 09 mar 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Marcus Hilger come amministratore in data 01 gen 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Hanns Martin Lipp come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2017 senza aggiornamenti | 2 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Hanns Martin Lipp come amministratore in data 21 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Thorsten Beer come amministratore in data 21 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGG, Nichola Louise | Segretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | 163214890001 | |||||||
HALL, Wendy Margaret | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | Solicitor | 172979860001 | ||||
BRIERLEY, Jennifer Anne | Segretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
BUCKELL, Stephen William | Segretario | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | 20341960001 | ||||||
DAVIES, John Richard Bridge | Segretario | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
HEATON, Janet Ruth | Segretario | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
NASH, Andrew | Segretario | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||
SADLER, John Michael | Segretario | 12 Cransley Grove B91 3ZA Solihull West Midland | British | 44018260001 | ||||||
SMERDON, Peter | Segretario | 40 Stoneton Crescent Balsall Common CV7 7QG Coventry Warwickshire | British | 16898700002 | ||||||
BEER, Thorsten | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | Cfo | 172030260001 | ||||
FELLOWS, Jonathan | Amministratore | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | Fin Dir | 118296490001 | ||||
HILGER, Marcus | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | Germany | German | Finance Director | 238936580003 | ||||
HOOD, John | Amministratore | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | Finance Director | 39644740002 | |||||
KEEN, Christian | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | Chief Finance Officer | 54544790004 | ||||
KERSHAW, Graham Anthony | Amministratore | Selsley House Westhorpe LE16 9UL Sibbertoft Leicestershire | United Kingdom | British | Director | 8991780003 | ||||
LIPP, Hanns Martin | Amministratore | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | Finance Director | 220582440001 | ||||
LLOYD, Allen John | Amministratore | Yew House Freasley B78 2EY Tamworth Staffordshire | British | Pharmacist | 2270630001 | |||||
LLOYD, Peter Edward | Amministratore | Southfield Coventry Road CV8 2FT Kenilworth Warwickshire | British | 35546210001 | ||||||
MCARDLE, John Joseph | Amministratore | 20 Egginton Road Hall Green B28 0LZ Birmingham West Midlands | British | Pharmacist | 72125670001 | |||||
MEISTER, Stefan Mario | Amministratore | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | Company Director | 43550520003 | |||||
MISCHKE, Gerhard Viktor | Amministratore | Whitehill Farmhouse Alderminster CV37 8BW Stratford Upon Avon Warwickshire | Germany | Chief Finance Officer | 62107000001 | |||||
SHEPHERD, William | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | Solicitor | 162873980001 | ||||
SMERDON, Peter | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | Company Secretary | 16898700002 | ||||
STEELE, Richard John | Amministratore | 10 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Derbyshire | England | British | Finance Director | 1415570001 | ||||
TURNER, Richard Gill | Amministratore | The Old Coach House Mill Lane Sheepy Parva CV9 3RL Atherstone Warwickshire | British | Commercial Director | 51796560002 | |||||
VIZARD, Ronald Charles, Harold | Amministratore | Fieldfare Pigeon Green, Snitterfield CV37 OLP Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | Chartered Accomntant | 122881190001 | |||||
WARD, Michael Ashley | Amministratore | Flat 603 Shad Thames SE1 2YL London | England | British | Group Finance Director | 114711020001 | ||||
WILLETTS, Andrew John | Amministratore | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | Chartered Accountant | 120451550002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lloyds Chemists Limited | 06 apr 2016 | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creato il 14 mar 1988 Consegnato il 25 mar 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a 2 mill street, congleton, cheshire. And the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 28 lug 1986 Consegnato il 31 lug 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a 339, ash bank road, werrrington, stoke on trent and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 18 lug 1986 Consegnato il 05 ago 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H - land & buildings fronting to trentham road, longton stoke on trent. And/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 26 giu 1986 Consegnato il 01 lug 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 130 werrington rd, bucknall, staffs (title no sf 213244) and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 30 mag 1986 Consegnato il 12 giu 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 89 stafford street, hanley, stoke on trent staffordshire. Title no. Sf 126660 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 30 apr 1984 Consegnato il 02 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H - 443 cannock road, hightown, hedensford, staffordshire title no sf 138380 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 26 gen 1983 Consegnato il 27 gen 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The pharmacy, 128 werrington road, bucknall stoke on trent. Title no sf 56195. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 04 mag 1982 Consegnato il 10 mag 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 128 warrington rd. Bucknall, stoke on trent title no:- sf 56195. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 apr 1982 Consegnato il 04 mag 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 441 cannock road, hednesford, staffordshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 gen 1982 Consegnato il 06 feb 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H shop and dwellinghouse at 8 bilbrook road, bilbrook tettenthall, staffordshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 feb 1978 Consegnato il 03 mar 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over the company's estate of interest with all f/h or l/h property all stocks shares or other securities all book and other debts assignment of goodwill floating charge over the undertaking and all other property and assets present and future (see doc M17). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0