GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED

GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01132901
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Christian Keen come amministratore in data 18 mag 2022

    1 pagineTM01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 apr 2022

    8 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 apr 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 26 mar 2021

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 23/03/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Marcus Hilger come amministratore in data 25 nov 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Christian Keen come amministratore in data 25 nov 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 set 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 set 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Marcus Hilger il 09 mar 2018

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Marcus Hilger come amministratore in data 01 gen 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Hanns Martin Lipp come amministratore in data 31 dic 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 set 2017 senza aggiornamenti

    2 pagineCS01

    Nomina di Hanns Martin Lipp come amministratore in data 21 dic 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thorsten Beer come amministratore in data 21 dic 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEGG, Nichola Louise
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    163214890001
    HALL, Wendy Margaret
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritishSolicitor172979860001
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Segretario
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Segretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Segretario
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Segretario
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    BEER, Thorsten
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGermanCfo172030260001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishFin Dir118296490001
    HILGER, Marcus
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    GermanyGermanFinance Director238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Amministratore
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    BritishFinance Director39644740002
    KEEN, Christian
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritishChief Finance Officer54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Amministratore
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector8991780003
    LIPP, Hanns Martin
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGermanFinance Director220582440001
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    BritishPharmacist2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    British35546210001
    MCARDLE, John Joseph
    20 Egginton Road
    Hall Green
    B28 0LZ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    20 Egginton Road
    Hall Green
    B28 0LZ Birmingham
    West Midlands
    BritishPharmacist72125670001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    SwissCompany Director43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    GermanyChief Finance Officer62107000001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritishSolicitor162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishCompany Secretary16898700002
    STEELE, Richard John
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    Amministratore
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    EnglandBritishFinance Director1415570001
    TURNER, Richard Gill
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    BritishCommercial Director51796560002
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    BritishChartered Accomntant122881190001
    WARD, Michael Ashley
    Flat 603 Shad Thames
    SE1 2YL London
    Amministratore
    Flat 603 Shad Thames
    SE1 2YL London
    EnglandBritishGroup Finance Director114711020001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritishChartered Accountant120451550002

    Chi sono le persone con controllo significativo di GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    06 apr 2016
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneGreat Britain
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1335858
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 14 mar 1988
    Consegnato il 25 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 2 mill street, congleton, cheshire. And the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 lug 1986
    Consegnato il 31 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 339, ash bank road, werrrington, stoke on trent and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 18 lug 1986
    Consegnato il 05 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - land & buildings fronting to trentham road, longton stoke on trent. And/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 giu 1986
    Consegnato il 01 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    130 werrington rd, bucknall, staffs (title no sf 213244) and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 mag 1986
    Consegnato il 12 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    89 stafford street, hanley, stoke on trent staffordshire. Title no. Sf 126660 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 apr 1984
    Consegnato il 02 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - 443 cannock road, hightown, hedensford, staffordshire title no sf 138380 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 gen 1983
    Consegnato il 27 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The pharmacy, 128 werrington road, bucknall stoke on trent. Title no sf 56195. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 mag 1982
    Consegnato il 10 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    128 warrington rd. Bucknall, stoke on trent title no:- sf 56195.
    Persone aventi diritto
    • K. E. Isaac
    • I. Isaac
    Transazioni
    • 10 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 26 apr 1982
    Consegnato il 04 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 441 cannock road, hednesford, staffordshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 gen 1982
    Consegnato il 06 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H shop and dwellinghouse at 8 bilbrook road, bilbrook tettenthall, staffordshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 feb 1978
    Consegnato il 03 mar 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate of interest with all f/h or l/h property all stocks shares or other securities all book and other debts assignment of goodwill floating charge over the undertaking and all other property and assets present and future (see doc M17).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GEORGE STAPLES (STOKE) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 apr 2021Inizio della liquidazione
    11 ago 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0