TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED

TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01134936
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED?

    • (6024) /
    • (6312) /

    Dove si trova TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOM GRANBY (COLDSTORES) LIMITED 19 set 197319 set 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Tarsem Singh Dhaliwal come amministratore in data 12 mar 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 mar 2011

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 set 2011

    Stato del capitale al 21 set 2011

    • Capitale: GBP 260,802
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher Donald Horne il 21 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Tarsem Singh Dhaliwal il 21 set 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr John Graham Berry come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jayne Burrell come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 26 mar 2010

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr Tarsem Singh Dhaliwal come amministratore

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Denmark House Parkway Welwyn Garden City Herts AL8 6JN in data 30 giu 2010

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Andrew Ramsden come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 mar 2009

    2 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    Chi sono gli amministratori di TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BERRY, John Graham
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    159126610001
    HORNE, Christopher Donald
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector42920330001
    AGGARWAL, Amit
    27 St Mary's Mansions
    St Mary's Terrace
    W2 1SQ London
    Segretario
    27 St Mary's Mansions
    St Mary's Terrace
    W2 1SQ London
    BritishDirector113667030001
    BURRELL, Jayne Katherine
    1 Moat Farm Court
    Pulford Lane Dodleston
    CH4 9NN Chester
    Cheshire
    Segretario
    1 Moat Farm Court
    Pulford Lane Dodleston
    CH4 9NN Chester
    Cheshire
    BritishSolicitor99547650001
    EGAN, John Raymond
    36 The Moorings
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Segretario
    36 The Moorings
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Irish17830940001
    ELSBY SMITH, Andrew Edward
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Segretario
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    BritishDirector114320980001
    HARRIS, Michael Joseph
    9 Moor Coppice
    Crosby
    L23 2XJ Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    9 Moor Coppice
    Crosby
    L23 2XJ Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Secretary49423350001
    HOWARTH, David
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    Segretario
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    British107155000001
    LAMBERT, Roy Jefferson
    5 West Common
    Lindfield
    RH16 2AJ Haywards Heath
    West Sussex
    Segretario
    5 West Common
    Lindfield
    RH16 2AJ Haywards Heath
    West Sussex
    British82996330001
    REDMOND, Paul Michael
    14 Trevor Road
    PR8 3PJ Southport
    Merseyside
    Segretario
    14 Trevor Road
    PR8 3PJ Southport
    Merseyside
    English66475060001
    DANZ, Freidhelm
    Swynnerton
    Brighton Road
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    Swynnerton
    Brighton Road
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    GermanDirector19886990002
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Albany Place
    Hyde Way
    AL7 3BT Welwyn Garden City
    1
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector151680990001
    EGAN, John Raymond
    36 The Moorings
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    36 The Moorings
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    IrishDirector17830940001
    ELSBY SMITH, Andrew Edward
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector114320980001
    HEAL, Stephen Alan
    The Paddocks Drove Road
    Gamlingay
    SG19 3NY Sandy
    Bedfordshire
    Amministratore
    The Paddocks Drove Road
    Gamlingay
    SG19 3NY Sandy
    Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector42087770001
    HYSLOP, Edward James
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritishDirector127371260001
    JAKOBSEN, Carsten Svejgaard
    Langley Grounds
    390 Birmingham Road
    CV37 0R Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Langley Grounds
    390 Birmingham Road
    CV37 0R Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandDanishDirector165874230001
    KIDD, Derek
    Yew Cottage
    OX15 6NG Shenington
    Oxfordshire
    Amministratore
    Yew Cottage
    OX15 6NG Shenington
    Oxfordshire
    BritishDirector57300690001
    RAMSDEN, Andrew Nicholas
    The Farmhouse
    Wood Lea Farm Shepley
    HD8 8ES Huddersfield
    Amministratore
    The Farmhouse
    Wood Lea Farm Shepley
    HD8 8ES Huddersfield
    EnglandBritishDirector122765080001
    REDMOND, Jacqueline Rita
    9 West Lane
    Freshfields
    L37 7AY Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    9 West Lane
    Freshfields
    L37 7AY Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director49423290001
    REDMOND, Michael Joseph
    9 West Lane
    Freshfields
    L37 7AY Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    9 West Lane
    Freshfields
    L37 7AY Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector41016180001
    WOODWARD, Jeremy Alan
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    Amministratore
    Troon House Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Clwyd
    United KingdomBritishDirector57016650004

    TOM GRANBY (LIVERPOOL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 05 set 2006
    Consegnato il 23 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 23 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 05 set 2006
    Consegnato il 23 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a land and buildings on the south west side of school lane, knowsley industrial park, knowsley, liverpool, merseyside t/no MS122055 a charge over all buildings, fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landsbanki Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 23 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 dic 1993
    Consegnato il 07 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at caddick road school lane knowsley industrial park liverpool. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 23 nov 1993
    Consegnato il 24 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 mag 1985
    Consegnato il 10 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & buildings on the south west side of school lane knowsley industrial estate, knowsley. Merseyside (title no ms 122055).
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 lug 1984
    Consegnato il 09 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & buildings on the south west side of school lane knowsley merseyside. Title no ms 122055.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 03 lug 1984
    Consegnato il 06 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book & other debts due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0