TIMBERBASE LIMITED
Panoramica
Nome della società | TIMBERBASE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01136241 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TIMBERBASE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova TIMBERBASE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Ground Floor, Boundary House 2 Wythall Green Way Wythall B47 6LW Birmingham United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TIMBERBASE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LATHAM TIMBER CENTRES (HOLDINGS) LIMITED | 27 gen 1982 | 27 gen 1982 |
JAMES LATHAM (MILTON KEYNES) LIMITED | 26 set 1973 | 26 set 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TIMBERBASE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per TIMBERBASE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da PO Box 1586, Gemini One, John Smith Drive Oxford Business Park South Oxford OX4 9JF a Ground Floor, Boundary House 2 Wythall Green Way Wythall Birmingham B47 6LW in data 15 mag 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Stato del capitale al 04 gen 2018
| 6 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Garrett Wilkinson il 01 ott 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Po Box 1224 Pelham House Canwick Road Lincoln LN5 5NH a Po Box 1586, Gemini One, John Smith Drive Oxford Business Park South Oxford OX4 9JF in data 13 ago 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin O’Donovan come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Garrett Wilkinson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Colm O'nuallain come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Colin O’Donovan come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TIMBERBASE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAFTON GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | c/o Grafton Group Plc Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate IRISH Dublin 18 Ireland | 97259990001 | |||||||
O'HARA, Brian | Amministratore | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | Accountant | 181212990001 | ||||
WILKINSON, Garrett | Amministratore | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | Accountant | 187427640007 | ||||
JONES, Peter Howard | Segretario | 152 Church Green Road Bletchley MK3 6DD Milton Keynes Buckinghamshire | British | 25572450001 | ||||||
LATHAM, Philippa Anne Joan | Segretario | 4 Chepstow Crescent W11 3EB London | British | Company Sec | 38437780003 | |||||
CHADWICK, Michael | Amministratore | 39 Serpentine Avenue Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Ireland | Irish | Director | 16417710002 | ||||
JONES, Peter Howard | Amministratore | 152 Church Green Road Bletchley MK3 6DD Milton Keynes Buckinghamshire | British | 25572450001 | ||||||
KEMP, Terence George | Amministratore | Lowerbreeds Breeds Road Great Waltham CM3 1EE Chelmsford Essex | British | Chartered Accountant | 11609520001 | |||||
LATHAM, Peter Douglas Langdon | Amministratore | High Acre Hilltop Lane Chinnor OX9 4BH Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 15588560001 | ||||
LATHAM, Philippa Anne Joan | Amministratore | 4 Chepstow Crescent W11 3EB London | Uk | British | Company Secretary | 38437780003 | ||||
LYALL, James | Amministratore | 44 Millway Duston NN5 6ES Northampton Northamptonshire | British | Company Director | 12417440001 | |||||
MARTIN, Leo James | Amministratore | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | Director | 144555840001 | ||||
MCCABE, Michael Francis | Amministratore | 31 East Field Close Headington OX3 7SH Oxford | England | Irish | Director | 87622560002 | ||||
MIDDLETON, Kevin Paul | Amministratore | Canwick Road LN5 5NH Lincoln PO BOX 1224 Pelham House | England | British | Director | 61374610002 | ||||
O'DONOVAN, Colin | Amministratore | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | Chartered Accountant | 164508820001 | ||||
O'NUALLAIN, Colm | Amministratore | Heron House Corrig Road Sandyford Industrial Estate C/O Grafton Group Plc Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | Director | 79602480001 | ||||
PARKINSON, Malcolm Ross | Amministratore | Claywood House Arnewood Bridge Road Sway SO41 6DA Lymington Hampshire | United Kingdom | British | Director | 36376230001 | ||||
SMITH, Christopher John | Amministratore | 5 Hammond Crescent Willen Park MK15 9DH Milton Keynes Buckinghamshire | British | Timber Manager | 25572430001 | |||||
SOWTON, Jonathon Paul | Amministratore | Wellbottom Cottage The Downs KT22 8JZ Leatherhead Surrey | England | British | Director | 151407670001 | ||||
TYLER, Maurice Henry | Amministratore | The Lawns Heath Road LU7 8AG Leighton Buzzard Bedfordshire | British | Company Director | 25572440001 | |||||
TYLER, Robert George | Amministratore | 70 Kirby Drive Barton Hills | British | Company Director | 25572420001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TIMBERBASE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grafton Group (Uk) Plc | 06 apr 2016 | 250-256 High Street RH4 1QT Dorking Oak Green House Surrey England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
TIMBERBASE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 26 mar 1997 Consegnato il 01 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brevi particolari Property being land and buildings on east and west sides of simpson road bletchley bucks t/no BM2021. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 mar 1997 Consegnato il 01 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brevi particolari Property being land and buildings on east and west sides of simpson road bletchley bucks t/no BM2021. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 mar 1997 Consegnato il 01 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brevi particolari The property being land and buildings on east and west sides of simpson road bletchley bucks t/no bm 2021 land and buildings on the south side of manor street braintree t/no ex 507592. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 31 mag 1994 Consegnato il 02 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings forming part of the former gas works at manor street braintree. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 nov 1993 Consegnato il 03 dic 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0