STOCKINGSTONE LIMITED

STOCKINGSTONE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTOCKINGSTONE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01141250
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STOCKINGSTONE LIMITED?

    • (4521) /

    Dove si trova STOCKINGSTONE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Eaton Court
    Maylands Avenue
    Hemel Hempstead
    Herts. Hp2 7tr
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STOCKINGSTONE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SIR ROBERT MCALPINE CONSTRUCTION MANAGEMENT LIMITED18 feb 198318 feb 1983
    SIR ROBERT MCALPINE PROJECT MANAGEMENT LIMITED24 ott 197324 ott 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di STOCKINGSTONE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per STOCKINGSTONE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 06 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 giu 2010

    Stato del capitale al 15 giu 2010

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    Cessazione della carica di Patrick Kelly come amministratore

    2 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Anthony William Barratt il 30 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Colin Bruce Weekley il 30 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Kevin John Pearson il 30 ott 2009

    3 pagineCH03

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Robert Peter Walker il 30 ott 2009

    3 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Vincent Corrigan il 30 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Patrick Benedict Kelly il 30 ott 2009

    3 pagineCH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed sir robert mcalpine construction management LIMITED\certificate issued on 27/09/09
    2 pagineCERTNM

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 ott 2008

    9 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 ott 2007

    9 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 ott 2006

    9 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di STOCKINGSTONE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PEARSON, Kevin John
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    Segretario
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    British106469170001
    WALKER, Robert Peter
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    Segretario
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    British11492400001
    BARRATT, Anthony William
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishArea Manager67877120001
    CORRIGAN, Vincent
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    United KingdomBritishQuantity Surveyor103205770001
    MCALPINE, Andrew William, Sir
    Tyne House
    23 Side
    NE1 3JL Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Tyne House
    23 Side
    NE1 3JL Newcastle Upon Tyne
    BritishCivil Engineering And Building Contractor92904640002
    MCALPINE, Cullum
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    Amministratore
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    BritishCivil Engineering And Building Contractor10866460001
    MCALPINE, David Malcolm, The Hon
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    Amministratore
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    United KingdomBritishCivil Engineering And Building Contractor9834560002
    MCALPINE, Hector George
    Bernard Street
    WC1N 1LG London
    40
    Amministratore
    Bernard Street
    WC1N 1LG London
    40
    EnglandBritishCompany Director137097930001
    MCALPINE, Ian Malcolm
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    Amministratore
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    EnglandBritishCivil Engineering And Building Contractor10866480001
    MCALPINE, Malcolm Hugh Dees
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    Amministratore
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    United KingdomBritishCivil Engineering And Building17907340002
    MCALPINE, Richard Hugh
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    Amministratore
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    BritishCompany Director9335550001
    MCALPINE, Robert Edward Thomas William
    Bernard Street
    WC1N 1LG London
    40
    Amministratore
    Bernard Street
    WC1N 1LG London
    40
    EnglandBritishCompany Director137097830001
    WEEKLEY, Colin Bruce
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    BritishEngineer41295200004
    COWEN, Brendon Raymond
    92 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    92 Eastmoor Park
    AL5 1BP Harpenden
    Hertfordshire
    British1234020001
    WALKER, Robert Peter
    30 The Copse
    Fields End
    HP1 2TA Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    30 The Copse
    Fields End
    HP1 2TA Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British11492400001
    BOYLE, David Millar
    14 Pencil View
    KA30 8JZ Largs
    Ayrshire
    Amministratore
    14 Pencil View
    KA30 8JZ Largs
    Ayrshire
    ScotlandBritishCivil Engineer19302510002
    CHRISTIE, Vincent William
    Penbury Burtons Lane
    HP8 4BB Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Penbury Burtons Lane
    HP8 4BB Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishCivil Engineer And Building Co10883860001
    COLLARD, Michael John
    Birds Oak
    Leatherhead Road
    KT22 0JJ Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Birds Oak
    Leatherhead Road
    KT22 0JJ Oxshott
    Surrey
    BritishCivil Engineer49634040001
    KELLY, Patrick Benedict
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maylands Avenue
    HP2 7TR Hemel Hempstead
    Eaton Court
    Hertfordshire
    BritishRegional Manager35359500002
    LEGGOTT, Paul Edward
    Oak House Grosvenor Close
    SK9 1QY Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Oak House Grosvenor Close
    SK9 1QY Wilmslow
    Cheshire
    BritishEngineer44269440001
    MCALPINE, Alistair, Lord
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    Amministratore
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    BritishCivil Engineering And Building Contractor59091900001
    MCALPINE, William Hepburn, Sir
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    Amministratore
    40 Bernard Street
    WC1N 1LG London
    United KingdomBritishCivil Engineering And Building Contractor267620004
    TURNBULL, Nigel James Cavers
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant1604580001
    WHITE, Alan Charles Harry
    44 Thames Crescent
    SL6 8EY Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    44 Thames Crescent
    SL6 8EY Maidenhead
    Berkshire
    BritishRegional Manager9335560001

    STOCKINGSTONE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set off agreement dated 03/11/95
    Creato il 22 ago 2002
    Consegnato il 04 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 17 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creato il 29 apr 1994
    Consegnato il 17 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    And amending a composite guarantee and debenture dated 30TH april 1993.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 17 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 apr 1993
    Consegnato il 06 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of "the facilities" (as defined) or this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 06 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Building contract
    Creato il 21 nov 1984
    Consegnato il 22 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the building contract
    Brevi particolari
    Each and every bond which the company may from time to time take after the 1ST september 1984 in respect of the due performance by any nominated sub-co ntractor or supplier of their obligations for the carrying out of any part of the works described in the said agreement dated 21ST november 1984.
    Persone aventi diritto
    • St. Martins Property Investments Limited
    Transazioni
    • 22 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 16 apr 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 17 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0