COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED
Panoramica
Nome della società | COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01141808 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Northern House Moor Knoll Lane WF3 2EE East Ardsley Wakefield |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
COPYSTATIC (MIDLANDS) LIMITED | 02 mar 1988 | 02 mar 1988 |
COPYSTATIC (EAST MIDLANDS) LIMITED | 26 ott 1973 | 26 ott 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Giles il 21 gen 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew Patrick Burton il 21 gen 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen George Nichols come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Suzanne Wren come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2008 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2007 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2006 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2005 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2004 | 5 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363s |
Chi sono gli amministratori di COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHOLS, Stephen George | Segretario | Northern House Moor Knoll Lane WF3 2EE East Ardsley Wakefield | 158737860001 | |||||||
BURTON, Matthew Patrick | Amministratore | Northern House Moor Knoll Lane WF3 2EE East Ardsley Wakefield | United Kingdom | British | Accountant | 4656460001 | ||||
GILES, Jonathan | Amministratore | Northern House Moor Knoll Lane WF3 2EE East Ardsley Wakefield | England | British | Accountant | 117293280001 | ||||
BRUMMITT, David | Segretario | 6 Bradley Grange Gardens Bradley HD2 1QX Huddersfield West Yorkshire | British | Company Secretary | 28255370001 | |||||
BRYANT-MOATE, Melanie | Segretario | Crossing Farm Asselby DN14 7HE Howden | British | 74198320001 | ||||||
BURTON, Matthew Patrick | Segretario | Red House Church Lane Hensall DN14 0QQ Goole North Humberside | British | Accountant | 4656460001 | |||||
HARPER, Christine Joy | Segretario | 11 The Strand Attenborough NG9 6GS Nottingham Nottinghamshire | British | 8383770001 | ||||||
WREN, Suzanne | Segretario | Inglewood Avenue Birkby HD2 2DS Huddersfield 32 West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 138145090001 | |||||
CHARSLEY, Richard | Amministratore | 132 Kenneth Road Thundersley SS7 3AN Benfleet Essex | British | Sales Director | 67106930001 | |||||
COOPER, Ronald Frederick | Amministratore | 25 Westmoor Crescent Pogmoor S75 2JY Barnsley South Yorkshire | British | Company Director | 71584550001 | |||||
GAY, Cyril | Amministratore | High Cliff 304 Barnsley Road WF2 6AX Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 1004750001 | ||||
HARPER, Douglas Charles | Amministratore | 11 The Strand Attenborough NG9 6AU Nottingham Nottinghamshire | England | British | Company Director | 8383780001 | ||||
LAX, Noel Geoffrey | Amministratore | 5 Haweswater Close LS22 6FG Wetherby West Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 51487610001 | ||||
SCOTT, Ann Pearce | Amministratore | Mill Paddocks Plainville Lane, Wiggington YO32 2RG York North Yorkshire | England | British | Company Director | 79614900001 | ||||
WILTON, Mark Robert | Amministratore | 40 West Hay Grove Kemble GL7 6BE Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | Managing Director | 63021350001 |
COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 10 giu 1993 Consegnato il 29 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 30 giu 1989 Consegnato il 17 lug 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 30 giu 1989 Consegnato il 12 lug 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to ricoh UK limited under the terms of a loan agreement d/d 30/6/89 as may be amended varied or novated | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 set 1984 Consegnato il 14 set 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0