COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED

COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOPYSTATIC MIDLANDS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01141808
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Northern House
    Moor Knoll Lane
    WF3 2EE East Ardsley
    Wakefield
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COPYSTATIC (MIDLANDS) LIMITED02 mar 198802 mar 1988
    COPYSTATIC (EAST MIDLANDS) LIMITED26 ott 197326 ott 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Giles il 21 gen 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew Patrick Burton il 21 gen 2013

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 feb 2012

    Stato del capitale al 22 feb 2012

    • Capitale: GBP 1,210,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Stephen George Nichols come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Suzanne Wren come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2005

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2004

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NICHOLS, Stephen George
    Northern House
    Moor Knoll Lane
    WF3 2EE East Ardsley
    Wakefield
    Segretario
    Northern House
    Moor Knoll Lane
    WF3 2EE East Ardsley
    Wakefield
    158737860001
    BURTON, Matthew Patrick
    Northern House
    Moor Knoll Lane
    WF3 2EE East Ardsley
    Wakefield
    Amministratore
    Northern House
    Moor Knoll Lane
    WF3 2EE East Ardsley
    Wakefield
    United KingdomBritishAccountant4656460001
    GILES, Jonathan
    Northern House
    Moor Knoll Lane
    WF3 2EE East Ardsley
    Wakefield
    Amministratore
    Northern House
    Moor Knoll Lane
    WF3 2EE East Ardsley
    Wakefield
    EnglandBritishAccountant117293280001
    BRUMMITT, David
    6 Bradley Grange Gardens
    Bradley
    HD2 1QX Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    6 Bradley Grange Gardens
    Bradley
    HD2 1QX Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary28255370001
    BRYANT-MOATE, Melanie
    Crossing Farm
    Asselby
    DN14 7HE Howden
    Segretario
    Crossing Farm
    Asselby
    DN14 7HE Howden
    British74198320001
    BURTON, Matthew Patrick
    Red House Church Lane
    Hensall
    DN14 0QQ Goole
    North Humberside
    Segretario
    Red House Church Lane
    Hensall
    DN14 0QQ Goole
    North Humberside
    BritishAccountant4656460001
    HARPER, Christine Joy
    11 The Strand
    Attenborough
    NG9 6GS Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    11 The Strand
    Attenborough
    NG9 6GS Nottingham
    Nottinghamshire
    British8383770001
    WREN, Suzanne
    Inglewood Avenue
    Birkby
    HD2 2DS Huddersfield
    32
    West Yorkshire
    Segretario
    Inglewood Avenue
    Birkby
    HD2 2DS Huddersfield
    32
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant138145090001
    CHARSLEY, Richard
    132 Kenneth Road
    Thundersley
    SS7 3AN Benfleet
    Essex
    Amministratore
    132 Kenneth Road
    Thundersley
    SS7 3AN Benfleet
    Essex
    BritishSales Director67106930001
    COOPER, Ronald Frederick
    25 Westmoor Crescent
    Pogmoor
    S75 2JY Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    25 Westmoor Crescent
    Pogmoor
    S75 2JY Barnsley
    South Yorkshire
    BritishCompany Director71584550001
    GAY, Cyril
    High Cliff 304 Barnsley Road
    WF2 6AX Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    High Cliff 304 Barnsley Road
    WF2 6AX Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector1004750001
    HARPER, Douglas Charles
    11 The Strand
    Attenborough
    NG9 6AU Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    11 The Strand
    Attenborough
    NG9 6AU Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director8383780001
    LAX, Noel Geoffrey
    5 Haweswater Close
    LS22 6FG Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Haweswater Close
    LS22 6FG Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant51487610001
    SCOTT, Ann Pearce
    Mill Paddocks
    Plainville Lane, Wiggington
    YO32 2RG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Mill Paddocks
    Plainville Lane, Wiggington
    YO32 2RG York
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director79614900001
    WILTON, Mark Robert
    40 West Hay Grove
    Kemble
    GL7 6BE Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    40 West Hay Grove
    Kemble
    GL7 6BE Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishManaging Director63021350001

    COPYSTATIC MIDLANDS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 giu 1993
    Consegnato il 29 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Copystatic Systems Limited
    Transazioni
    • 29 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 giu 1989
    Consegnato il 17 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 giu 1989
    Consegnato il 12 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to ricoh UK limited under the terms of a loan agreement d/d 30/6/89 as may be amended varied or novated
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ricoh UK LTD.
    Transazioni
    • 12 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 01 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 set 1984
    Consegnato il 14 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0