SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED

SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01142560
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HECHINUS LIMITED08 nov 199608 nov 1996
    ECCLE RIGGS MANOR HOTEL LIMITED 07 feb 199507 feb 1995
    HECHINUS LIMITED31 ott 197331 ott 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di John Anthony Waterworth come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 giu 2018

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Cessazione della carica di Ian Alan Bull come amministratore in data 29 giu 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 011425600015 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 dic 2017

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ a 2nd Floor One Gosforth Park Way Gosforth Business Park Newcastle upon Tyne NE12 8ET in data 15 dic 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    15 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 011425600015, creata il 01 giu 2017

    81 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 011425600014 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Michael Clark come amministratore in data 13 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    16 pagineAA

    Nomina di Mr Ian Alan Bull come amministratore in data 15 giu 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nigel David Brewster come amministratore in data 31 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di un amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARCHIBOLD, Judith Ann
    One Gosforth Park Way, Gosforth Business Park
    Salters Lane
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Second Floor
    United Kingdom
    Segretario
    One Gosforth Park Way, Gosforth Business Park
    Salters Lane
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Second Floor
    United Kingdom
    203544910001
    BELL, David
    210 Garstang Road
    Fulwood
    PR2 4RD Preston
    Lancashire
    Segretario
    210 Garstang Road
    Fulwood
    PR2 4RD Preston
    Lancashire
    British3374280001
    LEAKE, Valerie Roase
    1 Rose Cottage
    Soutergate
    LA17 7TN Kirkby In Furness
    Cumbria
    Segretario
    1 Rose Cottage
    Soutergate
    LA17 7TN Kirkby In Furness
    Cumbria
    BritishCompany Secretary48726680002
    MORPHET, John Charles
    Hallmore House
    Hale
    LA7 7BP Milnthorpe
    Cumbria
    Segretario
    Hallmore House
    Hale
    LA7 7BP Milnthorpe
    Cumbria
    BritishDirector77451570001
    ROSSITER, Paul
    14 Hazelmere Road
    Fulwood
    PR2 9UN Preston
    Lancashire
    Segretario
    14 Hazelmere Road
    Fulwood
    PR2 9UN Preston
    Lancashire
    BritishAccountant68174110001
    WETHERLEY, Emma Louise
    19 Winster Park
    LA1 5TH Lancaster
    Lancashire
    Segretario
    19 Winster Park
    LA1 5TH Lancaster
    Lancashire
    BritishPersonal Assistant45408720001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    T & H SECRETARIAL SERVICES (PARK RESORTS) LIMITED
    Bunhill Row
    EC1Y 8YZ London
    3
    United Kingdom
    Segretario
    Bunhill Row
    EC1Y 8YZ London
    3
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6061740
    182020110001
    BELL, David
    210 Garstang Road
    Fulwood
    PR2 4RD Preston
    Lancashire
    Amministratore
    210 Garstang Road
    Fulwood
    PR2 4RD Preston
    Lancashire
    BritishWine And Spirit Merchant3374280001
    BODEN, David
    Midland Road
    HP2 5GE Hemel Hempstead
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Midland Road
    HP2 5GE Hemel Hempstead
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishDirector26352200004
    BREWSTER, Nigel David
    Midland Road
    HP2 5GE Hemel Hempstead
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Midland Road
    HP2 5GE Hemel Hempstead
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishDirector108722900001
    BULL, Ian Alan
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    Amministratore
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    EnglandBritishDirector210299090001
    CASTLEDINE, Alan
    Midland Road
    HP2 5GE Hemel Hempstead
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Midland Road
    HP2 5GE Hemel Hempstead
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishDirector132713340001
    CLARK, Michael Barry
    Midland Road
    HP2 5GE Hemel Hempstead
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Midland Road
    HP2 5GE Hemel Hempstead
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritishDirector131024310002
    CROFT, Thomas William Starkie
    Tanyard
    Higher Road
    PR3 3TA Longridge
    Lancashire
    Amministratore
    Tanyard
    Higher Road
    PR3 3TA Longridge
    Lancashire
    EnglandBritishBuilder1552290001
    DIXON, Beverley Jayne
    Lynburn
    Lindale
    LA11 6LF Grange Over Sands
    Cumbria
    Amministratore
    Lynburn
    Lindale
    LA11 6LF Grange Over Sands
    Cumbria
    United KingdomBritishCompany Director113785890001
    GASKELL, Ian David
    Lewth Lane
    Catford
    PR4 0TE Preston
    Geytescales
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lewth Lane
    Catford
    PR4 0TE Preston
    Geytescales
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant98873720002
    HODGSON, Graham Robert
    5 Mount Avenue
    Bare
    LA4 6DJ Morecambe
    Lancashire
    Amministratore
    5 Mount Avenue
    Bare
    LA4 6DJ Morecambe
    Lancashire
    BritishChief Executive26693690002
    MORPHET, John Charles
    Hallmore House
    Hale
    LA7 7BP Milnthorpe
    Cumbria
    Amministratore
    Hallmore House
    Hale
    LA7 7BP Milnthorpe
    Cumbria
    EnglandBritishDirector77451570001
    STEVENSON, Andrew John
    Dalmore House
    Auchendinny
    EH26 0ND Penicuik
    Midlothian
    Amministratore
    Dalmore House
    Auchendinny
    EH26 0ND Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritishChief Executive62908840001
    VAUGHAN, David Frank
    Midland Road
    HP2 5GE Hemel Hempstead
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Midland Road
    HP2 5GE Hemel Hempstead
    Charter Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishDirector135506230001
    WATERWORTH, John Anthony
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    Amministratore
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    United KingdomBritishDirector203710900001
    WIMPENNY, Nigel Byron
    3 Hartington Road
    WA10 6AF St Helens
    Merseyside
    Amministratore
    3 Hartington Road
    WA10 6AF St Helens
    Merseyside
    EnglandBritishCompany Director292182860001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bunhill Row
    EC1Y 8YZ London
    3
    England
    06 apr 2016
    Bunhill Row
    EC1Y 8YZ London
    3
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02906868
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 giu 2017
    Consegnato il 06 giu 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 06 giu 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 nov 2015
    Consegnato il 16 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 16 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 set 2013
    Consegnato il 30 set 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The company, as continuing security for the payment, discharge and performance of all the secured obligations charges to the bank by way of separate fixed charges:. (I) by way of legal mortgage each property specified in schedule 2 which is set opposite its name; and. (Ii) by way of equitable mortgage its real property, other than the property or properties specified in schedule 2.. notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 19 giu 2006
    Consegnato il 29 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    59,740 ordinary shares of £1 each held by lake district leisure pursuits limited and all present and future right title and interest in and to the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transazioni
    • 29 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 17 mar 2006
    Consegnato il 03 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land investments plant and machinery credit balance insurances other contracts and intellectual property and by way of floating charge all assets not otherwise effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent) as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 03 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amendment deed
    Creato il 16 set 2004
    Consegnato il 28 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee, the agent and/or the security beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The facilities agreement entered into from time to time between the company and/or any other company or companies or any subsidiary or holding company of the company with any one or more of the agent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 nov 2002
    Consegnato il 03 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) for the liabilities of the security beneficiaries
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 feb 1994
    Consegnato il 23 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at sand gap farm broughton in furness cumbria. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 gen 1993
    Consegnato il 25 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 gen 1993
    Consegnato il 15 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Eccle riggs hotel, foxfield road, broughton in furness, cumbria together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property and the benefits of all rights licences and the goodwill in relation to the business.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 feb 1992
    Consegnato il 13 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 gen 1985
    Consegnato il 12 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land containing 28,741 acres or thereabouts situate at eccle riggs broughton in furness south lakeland cumbria tog with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878 tog with plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams and Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 dic 1983
    Consegnato il 16 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £18,311 and all monies due or to become due from the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise
    Brevi particolari
    Private hotel with the buildings and land k/a the eccle riggs private hotel broughton in furness.
    Persone aventi diritto
    • Scottish & Newcastle Breweries PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 26 giu 1992Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 12 mar 1980
    Consegnato il 13 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,520 and further advances from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/3/1980.
    Brevi particolari
    F/H land and buildings known as the eccle riggs hotel, foxfield road, broughton-in-furness, cumbria together with the adjoining parcels of land by way of a floating charge over the (see doc M23). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • English Tourist Board
    Transazioni
    • 13 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 11 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 mar 1974
    Consegnato il 19 mar 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Eccle riggs private hotel in the parish of broughton-in-furness, in the county of lancaster tog. With 2 pieces of land adj. The property. Tog. With all fixtures (see doc. 13).
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transazioni
    • 19 mar 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 21 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 giu 2018Inizio della liquidazione
    31 ago 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0