SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED
Panoramica
Nome della società | SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01142560 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 2nd Floor One Gosforth Park Way Gosforth Business Park NE12 8ET Newcastle Upon Tyne England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HECHINUS LIMITED | 08 nov 1996 | 08 nov 1996 |
ECCLE RIGGS MANOR HOTEL LIMITED | 07 feb 1995 | 07 feb 1995 |
HECHINUS LIMITED | 31 ott 1973 | 31 ott 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Anthony Waterworth come amministratore in data 31 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 4 pagine | 600 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Alan Bull come amministratore in data 29 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 011425600015 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 21 dic 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ a 2nd Floor One Gosforth Park Way Gosforth Business Park Newcastle upon Tyne NE12 8ET in data 15 dic 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 011425600015, creata il 01 giu 2017 | 81 pagine | MR01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 011425600014 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Clark come amministratore in data 13 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Ian Alan Bull come amministratore in data 15 giu 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nigel David Brewster come amministratore in data 31 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di un amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHIBOLD, Judith Ann | Segretario | One Gosforth Park Way, Gosforth Business Park Salters Lane NE12 8ET Newcastle Upon Tyne Second Floor United Kingdom | 203544910001 | |||||||||||
BELL, David | Segretario | 210 Garstang Road Fulwood PR2 4RD Preston Lancashire | British | 3374280001 | ||||||||||
LEAKE, Valerie Roase | Segretario | 1 Rose Cottage Soutergate LA17 7TN Kirkby In Furness Cumbria | British | Company Secretary | 48726680002 | |||||||||
MORPHET, John Charles | Segretario | Hallmore House Hale LA7 7BP Milnthorpe Cumbria | British | Director | 77451570001 | |||||||||
ROSSITER, Paul | Segretario | 14 Hazelmere Road Fulwood PR2 9UN Preston Lancashire | British | Accountant | 68174110001 | |||||||||
WETHERLEY, Emma Louise | Segretario | 19 Winster Park LA1 5TH Lancaster Lancashire | British | Personal Assistant | 45408720001 | |||||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
T & H SECRETARIAL SERVICES (PARK RESORTS) LIMITED | Segretario | Bunhill Row EC1Y 8YZ London 3 United Kingdom |
| 182020110001 | ||||||||||
BELL, David | Amministratore | 210 Garstang Road Fulwood PR2 4RD Preston Lancashire | British | Wine And Spirit Merchant | 3374280001 | |||||||||
BODEN, David | Amministratore | Midland Road HP2 5GE Hemel Hempstead Charter Court Hertfordshire England | England | British | Director | 26352200004 | ||||||||
BREWSTER, Nigel David | Amministratore | Midland Road HP2 5GE Hemel Hempstead Charter Court Hertfordshire England | England | British | Director | 108722900001 | ||||||||
BULL, Ian Alan | Amministratore | One Gosforth Park Way Gosforth Business Park NE12 8ET Newcastle Upon Tyne 2nd Floor England | England | British | Director | 210299090001 | ||||||||
CASTLEDINE, Alan | Amministratore | Midland Road HP2 5GE Hemel Hempstead Charter Court Hertfordshire England | England | British | Director | 132713340001 | ||||||||
CLARK, Michael Barry | Amministratore | Midland Road HP2 5GE Hemel Hempstead Charter Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | Director | 131024310002 | ||||||||
CROFT, Thomas William Starkie | Amministratore | Tanyard Higher Road PR3 3TA Longridge Lancashire | England | British | Builder | 1552290001 | ||||||||
DIXON, Beverley Jayne | Amministratore | Lynburn Lindale LA11 6LF Grange Over Sands Cumbria | United Kingdom | British | Company Director | 113785890001 | ||||||||
GASKELL, Ian David | Amministratore | Lewth Lane Catford PR4 0TE Preston Geytescales Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 98873720002 | ||||||||
HODGSON, Graham Robert | Amministratore | 5 Mount Avenue Bare LA4 6DJ Morecambe Lancashire | British | Chief Executive | 26693690002 | |||||||||
MORPHET, John Charles | Amministratore | Hallmore House Hale LA7 7BP Milnthorpe Cumbria | England | British | Director | 77451570001 | ||||||||
STEVENSON, Andrew John | Amministratore | Dalmore House Auchendinny EH26 0ND Penicuik Midlothian | Scotland | British | Chief Executive | 62908840001 | ||||||||
VAUGHAN, David Frank | Amministratore | Midland Road HP2 5GE Hemel Hempstead Charter Court Hertfordshire England | England | British | Director | 135506230001 | ||||||||
WATERWORTH, John Anthony | Amministratore | One Gosforth Park Way Gosforth Business Park NE12 8ET Newcastle Upon Tyne 2nd Floor England | United Kingdom | British | Director | 203710900001 | ||||||||
WIMPENNY, Nigel Byron | Amministratore | 3 Hartington Road WA10 6AF St Helens Merseyside | England | British | Company Director | 292182860001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Lakeland Parks Limited | 06 apr 2016 | Bunhill Row EC1Y 8YZ London 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 01 giu 2017 Consegnato il 06 giu 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 13 nov 2015 Consegnato il 16 nov 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 26 set 2013 Consegnato il 30 set 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione The company, as continuing security for the payment, discharge and performance of all the secured obligations charges to the bank by way of separate fixed charges:. (I) by way of legal mortgage each property specified in schedule 2 which is set opposite its name; and. (Ii) by way of equitable mortgage its real property, other than the property or properties specified in schedule 2.. notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession | Creato il 19 giu 2006 Consegnato il 29 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 59,740 ordinary shares of £1 each held by lake district leisure pursuits limited and all present and future right title and interest in and to the assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A security agreement | Creato il 17 mar 2006 Consegnato il 03 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land investments plant and machinery credit balance insurances other contracts and intellectual property and by way of floating charge all assets not otherwise effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Amendment deed | Creato il 16 set 2004 Consegnato il 28 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee, the agent and/or the security beneficiaries on any account whatsoever | |
Brevi particolari The facilities agreement entered into from time to time between the company and/or any other company or companies or any subsidiary or holding company of the company with any one or more of the agent. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 22 nov 2002 Consegnato il 03 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) for the liabilities of the security beneficiaries | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 19 feb 1994 Consegnato il 23 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at sand gap farm broughton in furness cumbria. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 16 gen 1993 Consegnato il 25 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 11 gen 1993 Consegnato il 15 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Eccle riggs hotel, foxfield road, broughton in furness, cumbria together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property and the benefits of all rights licences and the goodwill in relation to the business. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 feb 1992 Consegnato il 13 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 10 gen 1985 Consegnato il 12 gen 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land containing 28,741 acres or thereabouts situate at eccle riggs broughton in furness south lakeland cumbria tog with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878 tog with plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 dic 1983 Consegnato il 16 dic 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £18,311 and all monies due or to become due from the company to the chargee on account current or stated for goods supplied or otherwise | |
Brevi particolari Private hotel with the buildings and land k/a the eccle riggs private hotel broughton in furness. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 mar 1980 Consegnato il 13 mar 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £3,520 and further advances from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/3/1980. | |
Brevi particolari F/H land and buildings known as the eccle riggs hotel, foxfield road, broughton-in-furness, cumbria together with the adjoining parcels of land by way of a floating charge over the (see doc M23). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 mar 1974 Consegnato il 19 mar 1974 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Eccle riggs private hotel in the parish of broughton-in-furness, in the county of lancaster tog. With 2 pieces of land adj. The property. Tog. With all fixtures (see doc. 13). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
SOUTH LAKELAND HOLIDAYS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0