HYTORK INTERNATIONAL LTD
Panoramica
| Nome della società | HYTORK INTERNATIONAL LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01143260 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HYTORK INTERNATIONAL LTD?
- fabbricazione di compressori (28132) / Industrie manifatturiere
Dove si trova HYTORK INTERNATIONAL LTD?
| Indirizzo della sede legale | c/o EMERSON Accurist House 44 Baker Street W1U 7AL London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HYTORK INTERNATIONAL LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HYTORK PLC | 29 apr 1997 | 29 apr 1997 |
| HYTEK INTERNATIONAL PLC | 16 mag 1996 | 16 mag 1996 |
| HYTEK TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED | 01 mag 1992 | 01 mag 1992 |
| HYTORK CONTROLS LIMITED | 17 apr 1991 | 17 apr 1991 |
| HYTORK ACTUATORS LIMITED | 10 apr 1984 | 10 apr 1984 |
| VALVE CONVERSIONS LIMITED | 02 nov 1973 | 02 nov 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HYTORK INTERNATIONAL LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per HYTORK INTERNATIONAL LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 16 giu 2021
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Alastair James Prain come amministratore in data 27 gen 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Teresa Field come segretario in data 30 set 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2015 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ryan Lee Schrick come amministratore in data 30 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Christopher David Burley come amministratore in data 30 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2014 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di HYTORK INTERNATIONAL LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Victoria Jane | Segretario | c/o Emerson 44 Baker Street W1U 7AL London Accurist House United Kingdom | 148912620001 | |||||||
| PRAIN, Alastair James | Amministratore | c/o Emerson 44 Baker Street W1U 7AL London Accurist House | United Kingdom | British | 215867880001 | |||||
| ROWLEY, Jeremy | Amministratore | c/o Emerson 44 Baker Street W1U 7AL London Accurist House United Kingdom | England | British | 83374470001 | |||||
| AUSTEN, Margaret Dorothy | Segretario | 28 Imperial Square GL50 1RH Cheltenham Gloucestershire | British | 54690900001 | ||||||
| BURLEY, Christopher David | Segretario | 5 The Spinney The Camp GL6 7HP Stroud Gloucestershire | British | 27439320002 | ||||||
| FIELD, Teresa | Segretario | c/o Emerson Floor Accurist House 44 Baker Street W1U 7AL London 2nd | 148883090001 | |||||||
| BRADSHAW, John Andrew | Amministratore | Underleaf Upleaden GL18 Newent Glos | British | 31322070001 | ||||||
| BURLEY, Christopher David | Amministratore | 5 The Spinney The Camp GL6 7HP Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 27439320002 | |||||
| BUTTON, Daniel | Amministratore | c/o Emerson 44 Baker Street W1U 7AL London Accurist House United Kingdom | Usa | American | 80217230001 | |||||
| CHURCH, Anthony | Amministratore | 381 Painswick Road Matson GL4 4DD Gloucester Gloucestershire | British | 69258420001 | ||||||
| DUNCAN, Rodney Alexander | Amministratore | High Ridings Mill Lane Strensham WR8 9LB Worcester Worcestershire | British | 8556850001 | ||||||
| FILOSI, Vincent Raymond | Amministratore | 6409 Queensway Drive South Temple Terrace Florida 33617 United States Of America | American | 27803370001 | ||||||
| KELLY, Joseph Kevin Christopher | Amministratore | 17 Grovebury SO31 6PL Locks Heath Hampshire | England | British | 164085470002 | |||||
| KRENEK, Wilfred | Amministratore | 7903 Scherzo Lane Houston Texas 77040 Usa | American | 69382720002 | ||||||
| MCCLUSKEY, Frederick Anthony | Amministratore | 12 Alpine Way SR3 1TN Sunderland Tyne & Wear | England | British | 104802100001 | |||||
| MCGINNIS, Brian Paul | Amministratore | c/o Emerson 44 Baker Street W1U 7AL London Accurist House United Kingdom | Usa | United States | 141136680001 | |||||
| MCLEAN, Keith Gordon Fraser | Amministratore | 212 Woodhall Drive Mulberry Florida 33860 United States Of America | Canadian | 27803380001 | ||||||
| NESBITT, William Warren | Amministratore | 5225 Imperial Lake Boulevard E 55 Mulberry Florida America | American | 27338770001 | ||||||
| REED, Ian Arthur | Amministratore | Low Coppice Farm Coppice Lane, Cropton YO18 8HF Pickering North Yorkshire | England | British | 3302900003 | |||||
| SAUSSAYE, Eric | Amministratore | c/o Emerson 44 Baker Street W1U 7AL London Accurist House United Kingdom | France | French | 178619520001 | |||||
| SCHRICK, Ryan Lee | Amministratore | c/o Emerson 44 Baker Street W1U 7AL London Accurist House United Kingdom | Usa | American | 171439980001 | |||||
| SHAW, Ralph Vincent | Amministratore | 104 Hunters Hill Alexandria Kentucky 41001 Usa | American | 72475510001 | ||||||
| STEER, Barry | Amministratore | 7 Grieve Close Winthrop Perth 6150 Australia | British | 58524260001 | ||||||
| STEWART, Duncan Ross | Amministratore | The Old Vicarage Gloucester Road, Upleadon GL18 1EJ Newent | England | British | 94476640001 | |||||
| STEWART, Roy | Amministratore | 12 High Cross Avenue FY6 8BY Poulton Le Fylde Lancashire | British | 8556870001 | ||||||
| TIDWELL, James Martin | Amministratore | 142 Plantation Houston Texas 770221 FOREIGN Usa | American | 59512730001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HYTORK INTERNATIONAL LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerson Electric Co. | 06 apr 2016 | West Florissant Avenue 63136 St. Louis 8000 Mo United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HYTORK INTERNATIONAL LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 24 ago 1998 Consegnato il 29 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £200,000 and interest due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 12 dic 1997 Consegnato il 13 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £19,200.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 1 x jaguar 4.0 litre registration no.H17 ork chassis no 724793. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 06 lug 1993 Consegnato il 13 lug 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £61,417.10 | |
Brevi particolari All right title and interest in all sums payable under the insurance. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A credit agreement | Creato il 18 mag 1992 Consegnato il 30 mag 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £54147.30 under the agreement | |
Brevi particolari All right title and interest and sums payable under the insurances see form 395 for full details ref:269. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 01 mag 1992 Consegnato il 15 mag 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See form 395 ref M622C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 nov 1991 Consegnato il 04 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 1, venture business park, madleaze road, gloucestershire as comprised in a lease dated 18.11.91. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 07 ago 1987 Consegnato il 17 ago 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Property at eastern avenue gloucester gloucestershire T.N. gr 67362. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 set 1982 Consegnato il 16 set 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that piece of land situate fronting to eastern avenue gloucester containing in area 1.12 acres or thereabouts and having on the southern boundary a depth from eastern avenue of 288' 5" together with the factory premises. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 05 apr 1982 Consegnato il 15 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or hytork actuators limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0