HYTORK INTERNATIONAL LTD

HYTORK INTERNATIONAL LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHYTORK INTERNATIONAL LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01143260
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HYTORK INTERNATIONAL LTD?

    • fabbricazione di compressori (28132) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova HYTORK INTERNATIONAL LTD?

    Indirizzo della sede legale
    c/o EMERSON
    Accurist House
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HYTORK INTERNATIONAL LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HYTORK PLC29 apr 199729 apr 1997
    HYTEK INTERNATIONAL PLC16 mag 199616 mag 1996
    HYTEK TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED01 mag 199201 mag 1992
    HYTORK CONTROLS LIMITED17 apr 199117 apr 1991
    HYTORK ACTUATORS LIMITED10 apr 198410 apr 1984
    VALVE CONVERSIONS LIMITED02 nov 197302 nov 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di HYTORK INTERNATIONAL LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per HYTORK INTERNATIONAL LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 16 giu 2021

    • Capitale: GBP 0.25
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem and capital redemption reserve 07/06/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Alastair James Prain come amministratore in data 27 gen 2021

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2016

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Teresa Field come segretario in data 30 set 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 mag 2016

    Stato del capitale al 23 mag 2016

    • Capitale: GBP 743,022.75
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2015

    19 pagineAA

    Cessazione della carica di Ryan Lee Schrick come amministratore in data 30 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher David Burley come amministratore in data 30 set 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mag 2015

    Stato del capitale al 20 mag 2015

    • Capitale: GBP 743,022.75
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2014

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mag 2014

    Stato del capitale al 13 mag 2014

    • Capitale: GBP 743,022.75
    SH01

    Chi sono gli amministratori di HYTORK INTERNATIONAL LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Victoria Jane
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    148912620001
    PRAIN, Alastair James
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    Amministratore
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United KingdomBritish215867880001
    ROWLEY, Jeremy
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    EnglandBritish83374470001
    AUSTEN, Margaret Dorothy
    28 Imperial Square
    GL50 1RH Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    28 Imperial Square
    GL50 1RH Cheltenham
    Gloucestershire
    British54690900001
    BURLEY, Christopher David
    5 The Spinney
    The Camp
    GL6 7HP Stroud
    Gloucestershire
    Segretario
    5 The Spinney
    The Camp
    GL6 7HP Stroud
    Gloucestershire
    British27439320002
    FIELD, Teresa
    c/o Emerson
    Floor Accurist House
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    2nd
    Segretario
    c/o Emerson
    Floor Accurist House
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    2nd
    148883090001
    BRADSHAW, John Andrew
    Underleaf
    Upleaden
    GL18 Newent
    Glos
    Amministratore
    Underleaf
    Upleaden
    GL18 Newent
    Glos
    British31322070001
    BURLEY, Christopher David
    5 The Spinney
    The Camp
    GL6 7HP Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    5 The Spinney
    The Camp
    GL6 7HP Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish27439320002
    BUTTON, Daniel
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    UsaAmerican80217230001
    CHURCH, Anthony
    381 Painswick Road
    Matson
    GL4 4DD Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    381 Painswick Road
    Matson
    GL4 4DD Gloucester
    Gloucestershire
    British69258420001
    DUNCAN, Rodney Alexander
    High Ridings Mill Lane
    Strensham
    WR8 9LB Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    High Ridings Mill Lane
    Strensham
    WR8 9LB Worcester
    Worcestershire
    British8556850001
    FILOSI, Vincent Raymond
    6409 Queensway Drive South
    Temple Terrace
    Florida 33617
    United States Of America
    Amministratore
    6409 Queensway Drive South
    Temple Terrace
    Florida 33617
    United States Of America
    American27803370001
    KELLY, Joseph Kevin Christopher
    17 Grovebury
    SO31 6PL Locks Heath
    Hampshire
    Amministratore
    17 Grovebury
    SO31 6PL Locks Heath
    Hampshire
    EnglandBritish164085470002
    KRENEK, Wilfred
    7903 Scherzo Lane
    Houston
    Texas
    77040
    Usa
    Amministratore
    7903 Scherzo Lane
    Houston
    Texas
    77040
    Usa
    American69382720002
    MCCLUSKEY, Frederick Anthony
    12 Alpine Way
    SR3 1TN Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    12 Alpine Way
    SR3 1TN Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish104802100001
    MCGINNIS, Brian Paul
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    UsaUnited States141136680001
    MCLEAN, Keith Gordon Fraser
    212 Woodhall Drive
    Mulberry
    Florida 33860
    United States Of America
    Amministratore
    212 Woodhall Drive
    Mulberry
    Florida 33860
    United States Of America
    Canadian27803380001
    NESBITT, William Warren
    5225 Imperial Lake Boulevard E 55
    Mulberry
    Florida
    America
    Amministratore
    5225 Imperial Lake Boulevard E 55
    Mulberry
    Florida
    America
    American27338770001
    REED, Ian Arthur
    Low Coppice Farm
    Coppice Lane, Cropton
    YO18 8HF Pickering
    North Yorkshire
    Amministratore
    Low Coppice Farm
    Coppice Lane, Cropton
    YO18 8HF Pickering
    North Yorkshire
    EnglandBritish3302900003
    SAUSSAYE, Eric
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    FranceFrench178619520001
    SCHRICK, Ryan Lee
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Emerson
    44 Baker Street
    W1U 7AL London
    Accurist House
    United Kingdom
    UsaAmerican171439980001
    SHAW, Ralph Vincent
    104 Hunters Hill
    Alexandria
    Kentucky 41001
    Usa
    Amministratore
    104 Hunters Hill
    Alexandria
    Kentucky 41001
    Usa
    American72475510001
    STEER, Barry
    7 Grieve Close
    Winthrop
    Perth 6150
    Australia
    Amministratore
    7 Grieve Close
    Winthrop
    Perth 6150
    Australia
    British58524260001
    STEWART, Duncan Ross
    The Old Vicarage
    Gloucester Road, Upleadon
    GL18 1EJ Newent
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Gloucester Road, Upleadon
    GL18 1EJ Newent
    EnglandBritish94476640001
    STEWART, Roy
    12 High Cross Avenue
    FY6 8BY Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Amministratore
    12 High Cross Avenue
    FY6 8BY Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British8556870001
    TIDWELL, James Martin
    142 Plantation
    Houston Texas 770221
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    142 Plantation
    Houston Texas 770221
    FOREIGN Usa
    American59512730001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HYTORK INTERNATIONAL LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Emerson Electric Co.
    West Florissant Avenue
    63136 St. Louis
    8000
    Mo
    United States
    06 apr 2016
    West Florissant Avenue
    63136 St. Louis
    8000
    Mo
    United States
    No
    Forma giuridicaCorporation
    Paese di registrazioneUsa (Missouri)
    Autorità legaleLaws Of The State Of Missouri, Usa
    Luogo di registrazioneSecretary Of State Of Missouri, Usa
    Numero di registrazione005170
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HYTORK INTERNATIONAL LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 ago 1998
    Consegnato il 29 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 and interest due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Rodney Alexander Duncan(The Trustees of the Hytork Controls LTD Directors Retirement Benefit Scheme)
    • Duncan Ross Stewart
    • M W Trustees Limited
    Transazioni
    • 29 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 12 dic 1997
    Consegnato il 13 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £19,200.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1 x jaguar 4.0 litre registration no.H17 ork chassis no 724793.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 13 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 06 lug 1993
    Consegnato il 13 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £61,417.10
    Brevi particolari
    All right title and interest in all sums payable under the insurance.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 13 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement
    Creato il 18 mag 1992
    Consegnato il 30 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £54147.30 under the agreement
    Brevi particolari
    All right title and interest and sums payable under the insurances see form 395 for full details ref:269.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 30 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 mag 1992
    Consegnato il 15 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref M622C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 nov 1991
    Consegnato il 04 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1, venture business park, madleaze road, gloucestershire as comprised in a lease dated 18.11.91.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 ago 1987
    Consegnato il 17 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at eastern avenue gloucester gloucestershire T.N. gr 67362.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 set 1982
    Consegnato il 16 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that piece of land situate fronting to eastern avenue gloucester containing in area 1.12 acres or thereabouts and having on the southern boundary a depth from eastern avenue of 288' 5" together with the factory premises.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 05 apr 1982
    Consegnato il 15 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or hytork actuators limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 23 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0