EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED
Panoramica
Nome della società | EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01144062 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Greater London House Hampstead Road NW1 7EJ London United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
METRO RADIO GROUP LIMITED | 25 nov 1988 | 25 nov 1988 |
NORTH EAST BROADCASTING CO. PLC | 07 nov 1973 | 07 nov 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Emily Henrietta Gestetner come amministratore in data 29 giu 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di John Keith Gulliver come amministratore in data 11 giu 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Duncan Anthony Painter il 02 apr 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG04 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Duncan Anthony Painter come amministratore in data 22 dic 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Martyn John Hindley come amministratore in data 22 dic 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Varie Section 519 | 1 pagine | MISC | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 15 dic 2010
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 30 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Martyn John Hindley il 30 set 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Shanny Looi il 01 mar 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Martyn John Hindley il 01 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Emily Henrietta Gestetner il 01 mar 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Helen Frances Hay come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOI, Shanny | Segretario | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | British | 129906110001 | ||||||
GULLIVER, John Keith | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 170112360001 | ||||
PAINTER, Duncan Anthony | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | Company Director | 132649960001 | ||||
ELSDON, Kate | Segretario | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | Company Secretary | 107227940002 | |||||
GILES, Nicholas David Martin | Segretario | 8 Pyms Gardens Abbotsley PE19 6UR St Neots Cambs | British | 85529870001 | ||||||
HAY, Helen Frances | Segretario | MK43 7BB Odell The Old Stable Yard Beds | 146425180001 | |||||||
HENSON, Mark Richard | Segretario | 5 Hazeland Steading PE10 0PW Morton Lincolnshire | British | 104630800001 | ||||||
HOGG, Marianne Lisa | Segretario | 43b Norroy Road Putney SW15 1PQ London | British | 101383970001 | ||||||
LAWRENCE, Eric Alexander | Segretario | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | 4250810002 | ||||||
NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Segretario | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | Company Secretary | 120147010002 | |||||
WALMSLEY, Derek Kerr | Segretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
AITCHISON, Sally Fiona | Amministratore | Redplains 118 Darlington Road, Hartburn TS18 5EZ Stockton Cleveland | United Kingdom | British | Sales Director | 152260030001 | ||||
BHAKTA-JONES, Nilema | Amministratore | 7b Wolseley Road N8 8RR London | United Kingdom | British | Lawyer | 124888590001 | ||||
BROWN, James | Amministratore | 25 Trinity Courtyard St Peters Marina NE6 1TS Newcastle Upon Tyne | British | Programme Director | 50345140001 | |||||
CHAPMAN, Elizabeth Mary | Amministratore | Stonehaven Coatham House Farm DL1 3NJ Darlington County Durham | England | British | Sales Director | 109560890001 | ||||
CHARLTON, John, Sir | Amministratore | Cairn Lodge Dalton Ponteland NE18 0AB Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | Retired | 30542180002 | ||||
CHRISTOPHER, Martin Graham | Amministratore | Rose Villa Bridgend Carlton MK43 7LP Bedford | England | British | Professor | 4387050001 | ||||
COLE, Christopher Michael | Amministratore | Lucas Avenue HA2 9JU Harrow 30 Middlesex England | United Kingdom | British | Accountant | 133510510001 | ||||
DOBSON, Maurice John | Amministratore | 14 Haughton Terrace NE24 2HA Blyth Northumberland | United Kingdom | British | Sales Director | 47946730001 | ||||
DUNNE, George Henry | Amministratore | 27 The Bridle Woodham Village DL5 4TH Newton Aycliffe County Durham | British | Managing Director | 72942820001 | |||||
ELLINGTON, Catherine | Amministratore | 2 The Woodlands Milbank Road DL3 9UB Darlington County Durham | British | Director | 40793460002 | |||||
ELSDON, Kate | Amministratore | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | Company Secretary | 107227940002 | |||||
EMBLEY, Deborah Jayne | Amministratore | Flat 1 64 Cromwell Avenue Highgate N6 5HQ London | England | British | Finance Director | 75933680001 | ||||
EYRE, Richard Anthony | Amministratore | 31 Croham Park Avenue CR2 7HN South Croydon Surrey | British | Managing Director Capital Radi | 5219910001 | |||||
EYRE TANNER, Peter Giles | Amministratore | The Old Vicarage The Village NE65 9BL Acklington Morpeth Northumberland | British | Programme Director | 50344640001 | |||||
GESTETNER, Emily Henrietta | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | Accountant | 138386390001 | ||||
GRIGSON, David John | Amministratore | Bainton Farmhouse Tallington Road, Bainton PE9 3AF Stamford Lincolnshire | British | Accountant | 71511500001 | |||||
HINDLEY, Martyn John | Amministratore | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | Finance Director | 134332760002 | ||||
HUNTER, Neil | Amministratore | 1 Kempton Close DH8 0UB Consett County Durham | England | British | Managing Director | 69380910001 | ||||
HUNTINGFORD, Richard Norman Legh | Amministratore | 39 Amerland Road SW18 1QA London | British | Chartered Accountant | 3297910001 | |||||
JOHNSON, Michael | Amministratore | 144 Edge Hill Ponteland NE20 9JN Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Programme Director | 23322950001 | |||||
JOSEPHS, John Irving | Amministratore | 22 Osbaldeston Gardens NE3 4JE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | Chartered Accountant/Finance Director | 3830990001 | ||||
LAVELLI, John Stephen | Amministratore | 2 Nathans Close AL6 9QB Welwyn Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 56438160001 | |||||
LAWRENCE, Eric Alexander | Amministratore | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | Chartered Accountant | 4250810002 | |||||
LEDGER, Graham Arthur | Amministratore | 37 Brendon Grove Sober Hall Ingleby Barwick TS17 0PH Stockton On Tees Cleveland | British | Programme Director | 50345060001 |
EMAP RADIO (NORTH EAST) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 28 feb 1992 Consegnato il 13 mar 1992 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee.pursuant to an agreement dated 9 august 1991. | |
Brevi particolari Land k/a zone I teesdale and greater teesdale thornaby,cleveland. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 17 nov 1986 Consegnato il 04 dic 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 23 giu 1975 Consegnato il 01 lug 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 23 giu 1975 Consegnato il 01 lug 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Hannington works, swapwell, newcastle upon tyne together with all fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0