NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED

NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01148045
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor Mander House
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRESS COMPUTER SYSTEMS LIMITED28 nov 197328 nov 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al09 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma23 mag 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al09 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio redatto al 30 dic 2023

    29 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2024 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Change of company name 28/03/2024
    RES13

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed press computer systems LIMITED\certificate issued on 07/04/24
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name07 apr 2024

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 28 mar 2024

    RES15

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 17/01/2024
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    13 pagineMA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Indirizzo della sede legale modificato da 51-53 Queen Street Wolverhampton West Midlands WV1 1ES a 8th Floor Mander House Mander Centre Wolverhampton WV1 3NH in data 20 dic 2023

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Sheree Olivia Manning come amministratore in data 09 nov 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Douglas Easton come segretario in data 29 set 2023

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Simon Dale Weare come amministratore in data 29 set 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew James Whiles come amministratore in data 29 set 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew James Whiles come segretario in data 29 set 2023

    1 pagineTM02

    Notifica di National World Publishing Limited come persona con controllo significativo il 29 set 2023

    2 paginePSC02

    Cessazione di Claverley Group Limited come persona con controllo significativo il 29 set 2023

    1 paginePSC07

    Nomina di Mr Mark Thomas Hollinshead come amministratore in data 29 set 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David John Montgomery come amministratore in data 29 set 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Edward Alexander Graham come amministratore in data 29 set 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gareth Haydn Williams come amministratore in data 29 set 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Phillip Anthony Inman come amministratore in data 29 set 2023

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2022

    28 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Graeme Peter Clifford come amministratore in data 31 dic 2022

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Edward Alexander Graham il 01 dic 2022

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EASTON, Douglas
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    Segretario
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    314489440001
    HOLLINSHEAD, Mark Thomas
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    Amministratore
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    ScotlandBritishDirector178356860001
    MANNING, Sheree Olivia
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    Amministratore
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    EnglandBritish,AustralianChief Financial Officer315878060001
    MONTGOMERY, David John
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    Amministratore
    Mander Centre
    WV1 3NH Wolverhampton
    8th Floor Mander House
    England
    EnglandBritishDirector72116200002
    CROSS, Robert Maurice
    Hall End Lane
    Pattingham
    WV6 7BL Wolverhampton
    17
    West Midlands
    Great Britain
    Segretario
    Hall End Lane
    Pattingham
    WV6 7BL Wolverhampton
    17
    West Midlands
    Great Britain
    BritishDirector132289330001
    WARD, Michael Arnold Charles
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    Segretario
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    British32360190001
    WHILES, Matthew James
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Segretario
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    255298040001
    WILLIAMS, Gareth Haydn
    WV16
    Segretario
    WV16
    199102940001
    ALLATT, John David
    Lerida
    Haughton Lane
    TF11 8HW Shifnal
    Shropshire
    Amministratore
    Lerida
    Haughton Lane
    TF11 8HW Shifnal
    Shropshire
    BritishCompany Director1518610001
    BRIGGS, Sean Francis
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishNon Executive Director200011590002
    BROWN, Steven John
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishGroup Ceo154185360001
    CLIFFORD, Graeme Peter
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishManaging Director86723850002
    COWARD, Christopher Vincent
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishManagement Consultant67532460003
    CROSS, Robert Maurice
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishGroup Finance Director132289330001
    DZIUBA, Stanislaw
    10 Lindy Close
    Kinoulton
    NG12 3RD Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    10 Lindy Close
    Kinoulton
    NG12 3RD Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director141766580001
    EVERS, Graham William
    Bluntington
    Chaddesley Corbett
    DY10 4QL Kidderminster
    The Pound Cottage
    Worcestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bluntington
    Chaddesley Corbett
    DY10 4QL Kidderminster
    The Pound Cottage
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector1518570006
    GRAHAM, Edward Alexander
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    EnglandBritishNew Media Executive174816060004
    GRAHAM, Eric Alan
    Le Formentor
    Avenue Princess Grace
    MONACO Monte Carlo
    Monaco
    Amministratore
    Le Formentor
    Avenue Princess Grace
    MONACO Monte Carlo
    Monaco
    FranceBritishCompany Director1625250001
    HEDGES, Jeremy John Russell
    135 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SJ Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    135 Hyperion Road
    Stourton
    DY7 6SJ Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director28691210001
    HILL, Lawrence John
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishCommercial Director45659290001
    INMAN, Phillip Anthony
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishGroup Chief Executive245426860001
    LINES, Robert Andrew
    41 Hall End Lane
    Pattingham
    WV6 7BN Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    41 Hall End Lane
    Pattingham
    WV6 7BN Wolverhampton
    West Midlands
    BritishDirector45844110002
    LLOYD, Hannah Jane Madge
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishMarketing Director254149010001
    MEIER, Paul Stryker
    Eastham Park Farm
    Eastham
    WR15 8NN Tenbury Wells
    Worcestershire
    Amministratore
    Eastham Park Farm
    Eastham
    WR15 8NN Tenbury Wells
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director14112590002
    MILLER, David Jenkin
    Madehurst Road
    Madehurst
    BN18 0NU Arundel
    Court Cottage
    West Sussex
    England
    Amministratore
    Madehurst Road
    Madehurst
    BN18 0NU Arundel
    Court Cottage
    West Sussex
    England
    United KingdomBritishDirector105300820003
    MUNFORD, Margaret
    Rivendell
    Lower Penkridge Road, Acton Trussell
    ST17 0RJ Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    Rivendell
    Lower Penkridge Road, Acton Trussell
    ST17 0RJ Stafford
    Staffordshire
    BritishCompany Director32866370002
    READ, Mark
    Greystoke Drive
    DY6 8DX Kingswinford
    1
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Greystoke Drive
    DY6 8DX Kingswinford
    1
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishSales Director127443910001
    SMITH, Iain Mcfarlan
    Plantation View
    Silsoe
    MK45 4GG Bedford
    18
    England
    Amministratore
    Plantation View
    Silsoe
    MK45 4GG Bedford
    18
    England
    BritainBritishSales Director194887680002
    WALKER, Philip
    Stafford Road
    TF10 7LZ Newport
    23
    Salop
    United Kingdom
    Amministratore
    Stafford Road
    TF10 7LZ Newport
    23
    Salop
    United Kingdom
    United KingdomBritishTechnical Director101833800001
    WARD, Michael Arnold Charles
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    18 Queens Road
    WS5 3NF Walsall
    West Midlands
    BritishDirector32360190001
    WEARE, Simon Dale
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    United KingdomBritishDevelopment Director254132730001
    WHILES, Matthew James
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishOperations Director251451970001
    WILLIAMS, Gareth Haydn
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    Amministratore
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    West Midlands
    EnglandBritishOperations Director196992700002

    Chi sono le persone con controllo significativo di NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    National World Publishing Limited
    Joseph's Well
    Hanover Walk
    LS3 1AB Leeds
    Suite E3
    United Kingdom
    29 set 2023
    Joseph's Well
    Hanover Walk
    LS3 1AB Leeds
    Suite E3
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies For England And Wales
    Numero di registrazione11499982
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Claverley Group Limited
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    England
    06 apr 2016
    Queen Street
    WV1 1ES Wolverhampton
    51-53
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUk Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Register Of Companies For England And Wales
    Numero di registrazione05213110
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    NATIONAL WORLD SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 giu 2019
    Consegnato il 25 giu 2019
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 dic 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 mag 2019
    Consegnato il 16 mag 2019
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 dic 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 04 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 feb 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Limited debenture
    Creato il 31 ago 2007
    Consegnato il 12 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Star Group Pension Scheme and Includes the Trustees Thereof for the Timebeing
    Transazioni
    • 12 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Limited debenture
    Creato il 31 ago 2007
    Consegnato il 12 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Star Executive Pension Scheme and Includes the Trustees Thereof for Thetime Being
    Transazioni
    • 12 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ago 2007
    Consegnato il 06 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 27 apr 1992
    Consegnato il 06 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £800,000 and all other moneys due or to brcome due from the company to midland news association limited under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Freehold property situate and known as roman house ,newport road, albrighton ,shropshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland News Association Limited
    Transazioni
    • 06 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0