STOREY CARPETS LIMITED

STOREY CARPETS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTOREY CARPETS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01148245
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di STOREY CARPETS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova STOREY CARPETS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Arrow Valley
    Claybrook Drive
    B98 0FY Redditch
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STOREY CARPETS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STOREY & CO. (CARPETS) LIMITED28 nov 197328 nov 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di STOREY CARPETS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2023
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2024
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per STOREY CARPETS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al31 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per STOREY CARPETS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Ordine del tribunale di liquidazione

    3 pagineCOCOMP

    Modifica dei dettagli di Carpetright Limited come persona con controllo significativo il 30 lug 2024

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Indigo Corporate Secretary Limited come segretario in data 30 lug 2024

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Nestware House Purfleet Bypass Purfleet Essex RM19 1TT England a Arrow Valley Claybrook Drive Redditch B98 0FY in data 07 ago 2024

    1 pagineAD01

    Nomina di Indigo Corporate Secretary Limited come segretario in data 29 mag 2024

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Lydia Obaye come segretario in data 29 mag 2024

    1 pagineTM02

    Nomina di Lydia Obaye come segretario in data 12 apr 2024

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Peter James Harvey come amministratore in data 20 mar 2024

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Parminder Singh Khaira come amministratore in data 11 ago 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Peter James Harvey come amministratore in data 11 ago 2023

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Parminder Singh Khaira come amministratore in data 06 apr 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Patrick Stirling-Howe come amministratore in data 14 mar 2023

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Kevin Richard Barrett come amministratore in data 11 apr 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Wilfred Thomas Walsh come amministratore in data 11 apr 2022

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2020

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Purfleet by Pass Purfleet Essex RM19 1TT a Nestware House Purfleet Bypass Purfleet Essex RM19 1TT in data 08 nov 2021

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ott 2021 al 31 dic 2021

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Wilfred Thomas Walsh come amministratore in data 15 set 2020

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di STOREY CARPETS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARRETT, Kevin Richard
    Claybrook Drive
    B98 0FY Redditch
    Arrow Valley
    England
    Amministratore
    Claybrook Drive
    B98 0FY Redditch
    Arrow Valley
    England
    EnglandBritishChief Executive202060240001
    CATTELL, John
    95 Village Court
    NE26 3QB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Segretario
    95 Village Court
    NE26 3QB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British12956120002
    DREGENT, Patricia Ann Taylor
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    Segretario
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    British6369240002
    HERGA, Robert David
    Harris House, Purfleet Bypass
    Purfleet
    RM19 1TT Essex
    Segretario
    Harris House, Purfleet Bypass
    Purfleet
    RM19 1TT Essex
    British147120860001
    OBAYE, Lydia
    Purfleet Bypass
    RM19 1TT Purfleet
    Nestware House
    Essex
    England
    Segretario
    Purfleet Bypass
    RM19 1TT Purfleet
    Nestware House
    Essex
    England
    321768280001
    WATSON, David Alexander
    25 St Marys Grove
    Tudhoe Village
    DL16 6LR Spennymoor
    County Durham
    Segretario
    25 St Marys Grove
    Tudhoe Village
    DL16 6LR Spennymoor
    County Durham
    British13620760001
    INDIGO CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh-On-Sea
    Monometer House
    England
    Segretario
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh-On-Sea
    Monometer House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione13253973
    281695990002
    CATTELL, John
    95 Village Court
    NE26 3QB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    95 Village Court
    NE26 3QB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishAccountant12956120002
    COOMBS, Charles Jonathon
    47 Seafields
    SR6 8PQ Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    47 Seafields
    SR6 8PQ Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishBuyer48822340002
    GRAHAM, Margaret
    9 Ravine Terrace
    Roker
    SR6 9LZ Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    9 Ravine Terrace
    Roker
    SR6 9LZ Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishHousewife13620780001
    GRAHAM, Vincent
    9 Ravine Terrace
    Roker
    SR6 9LZ Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    9 Ravine Terrace
    Roker
    SR6 9LZ Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishRetailer13620770001
    HARRIS, Martin James
    Harris House, Purfleet Bypass
    Purfleet
    RM19 1TT Essex
    Amministratore
    Harris House, Purfleet Bypass
    Purfleet
    RM19 1TT Essex
    United KingdomBritishDirector51164080004
    HARRIS OF PECKHAM, Philip Charles, Lord
    Harris House, Purfleet Bypass
    Purfleet
    RM19 1TT Essex
    Amministratore
    Harris House, Purfleet Bypass
    Purfleet
    RM19 1TT Essex
    EnglandBritishDirector84835510005
    HARVEY, Peter James
    Purfleet Bypass
    RM19 1TT Purfleet
    Nestware House
    Essex
    England
    Amministratore
    Purfleet Bypass
    RM19 1TT Purfleet
    Nestware House
    Essex
    England
    EnglandBritishFinance Director283549720001
    HEPTINSTALL, Dennis
    19 Meadowfield Drive
    Cleadon
    SR6 7QW Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    19 Meadowfield Drive
    Cleadon
    SR6 7QW Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishRetailer13620790001
    HEPTINSTALL, Simon
    Baltal
    Whitesmocks
    DH1 4LQ Durham
    Amministratore
    Baltal
    Whitesmocks
    DH1 4LQ Durham
    BritishRetailer13620810003
    HEPTINSTALL, Violet
    19 Meadowfield Drive
    Cleadon
    SR6 7QW Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    19 Meadowfield Drive
    Cleadon
    SR6 7QW Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishHousewife13620800001
    KENYON, Ian Peter
    Staddlestones
    44 Warren Road
    GU1 2HE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Staddlestones
    44 Warren Road
    GU1 2HE Guildford
    Surrey
    EnglandBritishAccountant107735600001
    KHAIRA, Parminder Singh
    Purfleet Bypass
    RM19 1TT Purfleet
    Nestware House
    Essex
    England
    Amministratore
    Purfleet Bypass
    RM19 1TT Purfleet
    Nestware House
    Essex
    England
    EnglandBritishAccountant308017420001
    KITCHING, John
    Overys Oast
    Dunsters Mill Lane
    TN5 7HR Ticehurst
    Sussex
    Amministratore
    Overys Oast
    Dunsters Mill Lane
    TN5 7HR Ticehurst
    Sussex
    EnglandBritishDirector23322260003
    PAGE, Neil Lloyd
    Purfleet By Pass
    RM19 1TT Purfleet
    Essex
    Amministratore
    Purfleet By Pass
    RM19 1TT Purfleet
    Essex
    EnglandBritishAccountant60044610001
    PARLETT, Harold
    11 Holmelands Park North
    SR2 7SE Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    11 Holmelands Park North
    SR2 7SE Sunderland
    Tyne And Wear
    BritishRetailer58691580001
    PARLETT, Jean
    11 Holmlands Park North
    SR2 7SE Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    11 Holmlands Park North
    SR2 7SE Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishHousewife13620830001
    SAMPSON, Jeremy Andrew
    Purfleet By Pass
    RM19 1TT Purfleet
    Essex
    Amministratore
    Purfleet By Pass
    RM19 1TT Purfleet
    Essex
    EnglandBritishSolicitor176965130001
    SHAPLAND, Darren Mark
    Harris House, Purfleet Bypass
    Purfleet
    RM19 1TT Essex
    Amministratore
    Harris House, Purfleet Bypass
    Purfleet
    RM19 1TT Essex
    EnglandBritishCompany Director163098430001
    SIMPSON, Jeremy John Cobbett
    Purfleet By Pass
    RM19 1TT Purfleet
    Essex
    Amministratore
    Purfleet By Pass
    RM19 1TT Purfleet
    Essex
    EnglandBritishCompany Director255733780001
    STIRLING-HOWE, Patrick
    Purfleet Bypass
    RM19 1TT Purfleet
    Nestware House
    Essex
    England
    Amministratore
    Purfleet Bypass
    RM19 1TT Purfleet
    Nestware House
    Essex
    England
    EnglandBritishAccountant258228350001
    WALSH, Wilfred Thomas
    Purfleet Bypass
    RM19 1TT Purfleet
    Nestware House
    Essex
    England
    Amministratore
    Purfleet Bypass
    RM19 1TT Purfleet
    Nestware House
    Essex
    England
    EnglandBritishChief Executive63955050005
    WATSON, David Alexander
    25 St Marys Grove
    Tudhoe Village
    DL16 6LR Spennymoor
    County Durham
    Amministratore
    25 St Marys Grove
    Tudhoe Village
    DL16 6LR Spennymoor
    County Durham
    BritishAccountant13620760001
    WATSON, Susan
    25 St Marys Grove
    Tudhoe Village
    DL16 6LR Spennymoor
    County Durham
    Amministratore
    25 St Marys Grove
    Tudhoe Village
    DL16 6LR Spennymoor
    County Durham
    BritishHousewife13620840001

    Chi sono le persone con controllo significativo di STOREY CARPETS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    West Yorkshire
    England
    06 apr 2016
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    West Yorkshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2294875
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    STOREY CARPETS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 lug 2024Data della petizione
    28 ago 2024Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Brighton
    Suite 2a City Gate 185 Dyke Road
    BN3 1TL Hove
    East Sussex
    Praticante
    Suite 2a City Gate 185 Dyke Road
    BN3 1TL Hove
    East Sussex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0