PARKMAN CONSULTING ENGINEERS
Panoramica
| Nome della società | PARKMAN CONSULTING ENGINEERS |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
| Numero di società | 01148668 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PARKMAN CONSULTING ENGINEERS?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova PARKMAN CONSULTING ENGINEERS?
| Indirizzo della sede legale | Tempsford Hall Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire Great Britain |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PARKMAN CONSULTING ENGINEERS?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WARD,ASHCROFT AND PARKMAN | 30 nov 1973 | 30 nov 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PARKMAN CONSULTING ENGINEERS?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2006 |
Quali sono le ultime deposizioni per PARKMAN CONSULTING ENGINEERS?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 10 mag 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Bethan Melges il 08 dic 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anoop Kang come amministratore in data 21 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Thomas Lee Foreman come amministratore in data 21 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Giles Stewart Pearson come amministratore in data 26 feb 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Bethan Melges come amministratore in data 26 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Anoop Kang come amministratore in data 26 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Export House Cawsey Way Woking Surrey GU21 6QX a Tempsford Hall Tempsford Hall Sandy Bedfordshire SG19 2BD in data 16 ott 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Adrian Rayner come amministratore in data 08 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Paul England come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Giles Stewart Pearson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Amanda Massie come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Amanda Massie come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Adrian Rayner come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PARKMAN CONSULTING ENGINEERS?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREMAN, Thomas Lee | Amministratore | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | 221070030001 | |||||
| MELGES, Bethan Anne Elizabeth | Amministratore | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | 199583330002 | |||||
| ENGMANN, Catherine | Segretario | 11 Tudor Way SL4 5LT Windsor Berkshire | British | 92722710004 | ||||||
| HAMES, Victoria Elizabeth | Segretario | Flat 5 70 Elmbourne Road SW17 8JJ London | British | 102613150001 | ||||||
| LEE, Kelly | Segretario | Friars Stile Place TW10 6NL Richmond 6 Surrey United Kingdom | British | 138708240001 | ||||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Segretario | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | British | 36957420004 | ||||||
| PREECE, Richard Alec | Segretario | 3 Moorings Close Parkgate CH64 6TL South Wirral | British | 7353920001 | ||||||
| SHAW, Christine | Segretario | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | 164623930001 | |||||||
| SJOGREN, Carl | Segretario | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | 153647840001 | |||||||
| BOND, Eric | Amministratore | Henfold 120 Henfold Road Astley M29 7EX Manchester Lancashire | British | 11646690001 | ||||||
| CLEVERLY, Graham | Amministratore | Claremont 68 Tarvin Road CH3 7DF Chester Cheshire | United Kingdom | British | 86693320001 | |||||
| EAKIN, William Robert George | Amministratore | Stainton Firs Tower Road North Heswall L60 6RS Wirral Merseyside | British | 76548530001 | ||||||
| ENGLAND, Paul David | Amministratore | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | England | British | 153205540001 | |||||
| HANDLEY, John | Amministratore | Brook Cottage Brinsea Batch, Congresbury BS49 5JP Bristol | British | 97439420001 | ||||||
| HAYES, Brian | Amministratore | 1 Woodbank Hall Cottage Shotwick Lane CH1 6HY Woodbank Chester | British | 36639460001 | ||||||
| KANG, Anoop | Amministratore | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | 198683900001 | |||||
| KILNER, Robert Graham | Amministratore | 11 The Limes Culcheth WA3 4HE Warrington Cheshire | British | 11487410002 | ||||||
| LLOYD, Michael John | Amministratore | 45 Hough Green CH4 8JW Chester | British | 12243520001 | ||||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Amministratore | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | United Kingdom | British | 36957420004 | |||||
| NOTT, Nigel Alfred | Amministratore | 19 Shoscombe BA2 8LS Bath | England | British | 11646680001 | |||||
| OGDEN, David William | Amministratore | 16 Elm Drive Greasby CH49 3NP Wirral Merseyside | British | 30192420001 | ||||||
| PARKMAN, Hugh Charles | Amministratore | 38 East Saint Helen Street OX14 5EB Abingdon Oxfordshire | British | 11486420002 | ||||||
| PEARSON, Giles Stewart | Amministratore | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | United Kingdom | British | 180473890001 | |||||
| PREECE, Richard Alec | Amministratore | 20 Mereworth Caldy CH48 1QT Wirral | British | 7353920002 | ||||||
| RAYNER, Paul Adrian | Amministratore | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| TALLIS, John Amos | Amministratore | Foye Cottage School Bank Norley WA6 8NP Warrington Cheshire | British | 16563370001 | ||||||
| TOMLINSON, David | Amministratore | Arden 33 Cambridge Road BS21 7DN Clevedon North Somerset | England | British | 31228190001 | |||||
| YOUNG, Kevin Andrew | Amministratore | 35 Dean Close GU22 8NX Pyrford Surrey | England | British | 102706960001 |
PARKMAN CONSULTING ENGINEERS ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Further guarantee and debenture | Creato il 14 ago 1981 Consegnato il 25 ago 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property, undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 12 ago 1980 Consegnato il 18 ago 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the parkman holdings limited to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the goodwill, bookdebts buildings, fixtures, fixed plant and machinery (sec doc M17). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Further guarantee & debenture | Creato il 09 mag 1979 Consegnato il 21 mag 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking assets charged by the principal deed & further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 ago 1977 Consegnato il 22 ago 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 49 wilson patten street, warrington, cheshire. Title no. Ch 111456. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Further guarantee & debenture | Creato il 17 dic 1975 Consegnato il 06 gen 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other company named therein. To the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 13 nov 1975 Consegnato il 24 nov 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or parkman holdings limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari First fixed and floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. (See doc 12). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0