R J REALISATIONS LIMITED

R J REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàR J REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01149262
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di R J REALISATIONS LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. (25990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova R J REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di R J REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    REDHALL JEX LIMITED01 ott 201201 ott 2012
    JEX ENGINEERING COMPANY LIMITED01 ott 199301 ott 1993
    JEX PLUMBING CO. LIMITED04 dic 197304 dic 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di R J REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per R J REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Simon Philip Comer come amministratore in data 01 ago 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Philip Comer come segretario in data 01 ago 2022

    2 pagineTM02

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    25 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    26 pagineAM10

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB a 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB in data 15 nov 2021

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    27 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    26 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    28 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    14 pagineAM02

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    50 pagineAM03

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name01 lug 2019

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 27 giu 2019

    RES15

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Redhall Group Plc Unit 3 Calder Close Wakefield West Yorkshire WF4 3BA England a C/O Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB in data 20 giu 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 011492620009, creata il 24 gen 2019

    46 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 011492620008, creata il 24 gen 2019

    45 pagineMR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Russell David Haworth il 10 gen 2019

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Wayne Pearson come amministratore in data 03 nov 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Russell David Haworth come amministratore in data 03 nov 2018

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Philip Comer il 09 ago 2018

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di R J REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAWORTH, Russell David
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    Amministratore
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    EnglandBritishDirector201533400002
    COMER, Simon Philip
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    Segretario
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    248200980001
    JEX, James Antony
    Roberts Farm
    Third Lane, Ashby Cum Fenby
    DN37 0QU Grimsby
    North East Lincolnshire
    Segretario
    Roberts Farm
    Third Lane, Ashby Cum Fenby
    DN37 0QU Grimsby
    North East Lincolnshire
    British9160850002
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    187672280001
    LEWIS JONES, Christopher
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    Segretario
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    BritishDirector94645950001
    BIRD, Matthew James
    1 Red Hall Court
    Wakefield
    WF1 2UN West Yorkshire
    Amministratore
    1 Red Hall Court
    Wakefield
    WF1 2UN West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector150866650001
    BRIERLEY, Philip
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishChief Executive54808010002
    COMER, Simon Philip
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    Amministratore
    Landmark St Peter's Square
    1 Oxford St
    M1 4PB Manchester
    11th Floor
    EnglandBritishDirector206088760003
    FOSTER, Robert Simon
    Aish,
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford,
    Devon
    England
    Amministratore
    Aish,
    TQ10 9JG South Brent
    Stamford,
    Devon
    England
    EnglandBritishDirector134973970001
    JACKSON, David James
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector62867720010
    JESTER, Tony
    1 Red Hall Court
    Wakefield
    WF1 2UN West Yorkshire
    Amministratore
    1 Red Hall Court
    Wakefield
    WF1 2UN West Yorkshire
    EnglandBritishOperations Director107694130001
    JEX, James Antony
    Roberts Farm
    Third Lane, Ashby Cum Fenby
    DN37 0QU Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Roberts Farm
    Third Lane, Ashby Cum Fenby
    DN37 0QU Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishDirector9160850002
    JEX, Lee
    35 Cheltenham Way
    DN35 0UG Cleethorpes
    South Humberside
    Amministratore
    35 Cheltenham Way
    DN35 0UG Cleethorpes
    South Humberside
    United KingdomBritishDirector122339520001
    JEX, Pamela
    Roberts Farm
    Third Lane, Ashby Cum Fenby
    DN37 0QU Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Roberts Farm
    Third Lane, Ashby Cum Fenby
    DN37 0QU Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishDirector9160860002
    KELLY, Christopher John
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishGroup Finance Director188444350001
    LEWIS JONES, Christopher
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Smithy
    Monks Lane Acton
    CW5 8LE Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishDirector94645950001
    O'KANE, John Peter
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    Amministratore
    Station Lane
    Burton Leonard
    HG3 3RU Harrogate
    Holly Cottage
    North Yorkshire
    United KingdomIrishDirector106172200001
    OLIVER, Malcolm William
    12c Burtree Lane
    DL3 0XQ Darlington
    County Durham
    Amministratore
    12c Burtree Lane
    DL3 0XQ Darlington
    County Durham
    EnglandBritishManaging Director143300760001
    PEARSON, Wayne
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    c/o C/O Redhall Group Plc
    Calder Close
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector212154420001
    SHUTTLEWORTH, Richard Peter
    1 Red Hall Court
    Wakefield
    WF1 2UN West Yorkshire
    Amministratore
    1 Red Hall Court
    Wakefield
    WF1 2UN West Yorkshire
    EnglandBritishDirector58727820002
    SMITH, Andrew
    14 Millbrook Road
    Stover Trading Estate Yate
    BS37 5JW Bristol
    Redhall House
    England
    Amministratore
    14 Millbrook Road
    Stover Trading Estate Yate
    BS37 5JW Bristol
    Redhall House
    England
    United KingdomBritishDirector156474970001
    WILSON, Paul Andrew
    The Paddock Lodge
    Old Main Road
    DN37 9BE Barnoldby Le Beck
    N E Lincs
    Amministratore
    The Paddock Lodge
    Old Main Road
    DN37 9BE Barnoldby Le Beck
    N E Lincs
    United KingdomBritishDirector124973890001

    Chi sono le persone con controllo significativo di R J REALISATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Redhall Group Plc
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    06 apr 2016
    Calder Close
    Durkar
    WF4 3BA Wakefield
    Unit 3
    England
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione263995
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    R J REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 gen 2019
    Consegnato il 29 gen 2019
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Downing LLP (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 gen 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 gen 2019
    Consegnato il 29 gen 2019
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • (1) 1798 Volantis Fund Limited and (2) 1798 Volantis Catalyst Fund Limited
    Transazioni
    • 29 gen 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 dic 2015
    Consegnato il 02 gen 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alphagen Volantis Catalyst Fund Limited
    • Alphagen Volantis Fund Limited
    Transazioni
    • 02 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 21 gen 2011
    Consegnato il 28 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 06 giu 2007
    Consegnato il 07 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    For details of properties charged please refer to form 395,. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 10 dic 1985
    Consegnato il 18 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises adam smith st, grimsby humberside. T.no- hs 81070 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 07 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 27 giu 1985
    Consegnato il 03 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 18/8/77
    Brevi particolari
    A specific charge over the benefit of all bookdebts and other debts now and from time to time due or owing to the company (see doc m 21 for details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 07 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 ott 1981
    Consegnato il 16 nov 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 1/4, ayscough street, grimsby, humberside. Title no- hs 58115. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 ago 1977
    Consegnato il 05 set 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the companys estate or interest in any f/hold or l/hold properties all stocks shares and other securities all bookdebts and other debts assignment of goodwill floating charge over undertaking and all other property and assets present and future approx 32.7 sq yds of property situate at rear of perseverance terrace & thrinscoe road cleethorpes humberside with buildings & erections (see m 16 & schedule):.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 05 set 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 07 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    R J REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 giu 2019Inizio dell'amministrazione
    14 giu 2022Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sarah O'Toole
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Praticante
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Christopher Petts
    2nd Floor Rotterdam House 116 Quayside
    NE1 3DY Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    2nd Floor Rotterdam House 116 Quayside
    NE1 3DY Newcastle Upon Tyne

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0