BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED

BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01150202
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Rachel Elizabeth Robertson come amministratore in data 09 ott 2018

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 set 2017 al 29 set 2017

    1 pagineAA01

    Notifica di London & Birmingham Hotels Limited come persona con controllo significativo il 28 set 2017

    2 paginePSC02

    Cessazione di Metropole Hotels (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 28 set 2017

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Norman Alan Smith come amministratore in data 24 ott 2017

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edward Oded Wojakovski come segretario in data 02 ago 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Arthur Matyas come amministratore in data 02 ago 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edward Oded Wojakovski come amministratore in data 02 ago 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 mar 2016

    Stato del capitale al 29 mar 2016

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Norman Alan Smith il 01 mar 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Rachel Elizabeth Robertson il 01 mar 2016

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Arthur Matyas il 01 mar 2016

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 mar 2015

    Stato del capitale al 23 mar 2015

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2014 al 30 set 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 giu 2014

    Stato del capitale al 13 giu 2014

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tricor Suite 7Th Floor 52-54 Gracechurch Street London EC3V 0EH

    1 pagineAD02

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOOTH, James William
    27 Avenue Road
    CV37 6UN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Segretario
    27 Avenue Road
    CV37 6UN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British58028160001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Segretario
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Segretario
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    WOJAKOVSKI, Edward Oded, Dr
    3 Park Place
    St. James`S
    SW1A 1LP London
    Segretario
    3 Park Place
    St. James`S
    SW1A 1LP London
    British114629300001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    BOLLAND, Martin Keith
    11 Fairways
    1240 Warwick Road Copt Heath
    B93 9LL Solihull
    Warwickshire
    Amministratore
    11 Fairways
    1240 Warwick Road Copt Heath
    B93 9LL Solihull
    Warwickshire
    British4848800001
    BOOTH, James William
    27 Avenue Road
    CV37 6UN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    27 Avenue Road
    CV37 6UN Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British58028160001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    East Barn
    Glory Hill Farm
    HP9 1XE Beaconsfield
    Bucks
    Amministratore
    East Barn
    Glory Hill Farm
    HP9 1XE Beaconsfield
    Bucks
    British111188430001
    BRADLEY, Adrian Paul
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish90379240002
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Amministratore
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    DUNLOP, Robert Fergus
    42 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Amministratore
    42 Woodsford Square
    W14 8DP London
    British4848780001
    FRIEDMAN, Howard
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Usa106914780001
    HUMPHREYS, Stephen
    1 Victoria Yard
    Fairclough Street
    E1 1PP London
    Amministratore
    1 Victoria Yard
    Fairclough Street
    E1 1PP London
    British71438830002
    JAMES, Paul Frederick
    53 Lonsdale Drive
    Oakwood
    EN2 7LR Enfield
    Amministratore
    53 Lonsdale Drive
    Oakwood
    EN2 7LR Enfield
    British48791500001
    LEE, Jonathan Francis
    Bucket Lock Cottage
    Yarningale Lane
    CV35 8HW Yarningale Common
    Warwickshire
    Amministratore
    Bucket Lock Cottage
    Yarningale Lane
    CV35 8HW Yarningale Common
    Warwickshire
    EnglandBritish125160200001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Amministratore
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    MATYAS, Arthur
    3 Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    Amministratore
    3 Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    United KingdomBritish,36810610001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    ROBERTSON, Rachel Elizabeth
    3 Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    Amministratore
    3 Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    EnglandBritish96527400001
    ROWLAND, Roland Walter
    Hedsor Wharf
    SL8 5JN Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hedsor Wharf
    SL8 5JN Bourne End
    Buckinghamshire
    British34590730001
    SMITH, Norman Alan
    3 Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    Amministratore
    3 Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    ScotlandBritish156114890001
    SPICER, Paul George Bullen
    22 Ovington Gardens
    SW3 London
    Amministratore
    22 Ovington Gardens
    SW3 London
    British4848790001
    TARSH, Philip Maurice
    26 The Ridgeway
    KT22 9AZ Fetcham
    Surrey
    Amministratore
    26 The Ridgeway
    KT22 9AZ Fetcham
    Surrey
    British33106400001
    THOMSON, Jonathan David
    79 Hamlet Gardens
    Hammersmith
    W6 0SX London
    Amministratore
    79 Hamlet Gardens
    Hammersmith
    W6 0SX London
    British117323980001
    WAY, Mark Jonathan
    Princess Diana Drive
    AL4 0DY St. Albans
    15
    Hertfordshire
    Amministratore
    Princess Diana Drive
    AL4 0DY St. Albans
    15
    Hertfordshire
    United KingdomBritish143355690001
    WOJAKOVSKI, Edward Oded, Dr
    3 Park Place
    St. James`S
    SW1A 1LP London
    Amministratore
    3 Park Place
    St. James`S
    SW1A 1LP London
    EnglandBritish114629300001
    LADBROKE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    62360460001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Park Place
    St James'
    SW1A 1LP London
    3
    England
    28 set 2017
    Park Place
    St James'
    SW1A 1LP London
    3
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione08933786
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    England
    06 apr 2016
    Park Place
    St James's
    SW1A 1LP London
    3
    England
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione465603
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    BIRMINGHAM METROPOLE HOTELS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 28 nov 2006
    Consegnato il 07 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tonstate metropole hotels limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land k/a land lying to the west of pendigo way bickenhill t/no WM644010 and all that l/h land k/a land on the west side of pendigo way bickenhill t/no 422365 all that l/h land k/a part land lying to the west of pendigo way bickenhill t/no WM496382 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tonstate Ten Limited
    Transazioni
    • 07 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 nov 2006
    Consegnato il 05 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second supplemental mortgage.
    Creato il 24 set 1984
    Consegnato il 25 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from A.V.P. industries to the chargee under the terms of the principal agreement as amended by the second supplemental agreement.
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property 7 chelmsley lane, masten green, and 76 shirley rd, acocksgreen leasehold land t/n WM144434 goodwill, book debts both present and fixtures for further details see doc 31.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston Lloyds Bank P&B. Bank of Montreal
    Transazioni
    • 25 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental agreement.
    Creato il 07 ago 1981
    Consegnato il 11 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from A.V.P. industries limited to the chargee not exceeding £4,000,000 supplemental to the loan agreement dated 15.7.80.
    Brevi particolari
    L/H and comprised in title no wm 144434. with all buildings & fixtures all f/h & l/h property of the company with all buildings, fixtures, goodwill, uncalled capital, uncalled capital, bookdebts (see doc for full details). Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston.
    Transazioni
    • 11 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 15 lug 1980
    Consegnato il 22 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H metropole and warwick hotels, national exhibition centre, bickenhill. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including, goodwill, book-debts, uncalled capital. Stock-in-trade, work-in-progress, prepayments. Except the properties known as 7, chennsley lane marston green, & 76 shirley road, acock & green.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston
    Transazioni
    • 22 lug 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0