PCE HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PCE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01151001 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PCE HOLDINGS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova PCE HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Tempsford Hall Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire Great Britain |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PCE HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PARKMAN LIMITED | 04 ago 1989 | 04 ago 1989 |
| PARKMAN GROUP LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| PARKMAN HOLDINGS LIMITED | 13 dic 1973 | 13 dic 1973 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PCE HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per PCE HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 07 giu 2017
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Bethan Melges il 08 dic 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anoop Kang come amministratore in data 22 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Thomas Lee Foreman come amministratore in data 22 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Giles Stewart Pearson come amministratore in data 26 feb 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Bethan Melges come amministratore in data 26 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Anoop Kang come amministratore in data 26 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Export House Cawsey Way Woking Surrey GU21 6QX a Tempsford Hall Tempsford Hall Sandy Bedfordshire SG19 2BD in data 16 ott 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Adrian Rayner come amministratore in data 08 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicky Cobden come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Giles Stewart Pearson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PCE HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOREMAN, Thomas Lee | Amministratore | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | 221070030001 | |||||
| MELGES, Bethan Anne Elizabeth | Amministratore | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | 199583330002 | |||||
| COBDEN, Nicky | Segretario | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | 169439560001 | |||||||
| ENGMANN, Catherine | Segretario | 11 Tudor Way SL4 5LT Windsor Berkshire | British | 92722710004 | ||||||
| HAMES, Victoria Elizabeth | Segretario | Flat 5 70 Elmbourne Road SW17 8JJ London | British | 102613150001 | ||||||
| LEE, Kelly | Segretario | Friars Stile Place TW10 6NL Richmond 6 Surrey United Kingdom | British | 138708240001 | ||||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Segretario | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | British | 36957420004 | ||||||
| PREECE, Richard Alec | Segretario | 3 Moorings Close Parkgate CH64 6TL South Wirral | British | 7353920001 | ||||||
| SHAW, Christine Ann | Segretario | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | 161046620001 | |||||||
| SJOGREN, Carl | Segretario | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | 153648920001 | |||||||
| BOYD, Reginald | Amministratore | 4 Elms Way West Wittering PO20 8LS Chichester West Sussex | British | 12692900001 | ||||||
| COACKLEY, Richard James | Amministratore | The Laurels 71tarvin Road Littleton CH3 7DD Cheser Cheshire | England | British | 184140330001 | |||||
| EAKIN, William Robert George | Amministratore | Stainton Firs Tower Road North Heswall L60 6RS Wirral Merseyside | British | 76548530001 | ||||||
| ENGLAND, Paul David | Amministratore | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | England | British | 153205540001 | |||||
| HANDLEY, John | Amministratore | Brook Cottage Brinsea Batch, Congresbury BS49 5JP Bristol | British | 97439420001 | ||||||
| HARRIS, Rodney Hewer | Amministratore | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 104017460001 | |||||
| HOWITT, Ian Howard | Amministratore | The Spinney Mill Lane Rainhill L35 6NG Prescot Merseyside | England | British | 43712120001 | |||||
| KANG, Anoop | Amministratore | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | England | British | 198683900001 | |||||
| MASSIE, Amanda Jane Emilia | Amministratore | Bradlow Sandy Lane GU3 1HF Guildford Surrey | United Kingdom | British | 36957420004 | |||||
| PARKMAN, Hugh Charles | Amministratore | 38 East Saint Helen Street OX14 5EB Abingdon Oxfordshire | British | 11486420002 | ||||||
| PEARSON, Giles Stewart | Amministratore | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire Great Britain | United Kingdom | British | 180473890001 | |||||
| PREECE, Richard Alec | Amministratore | 20 Mereworth Caldy CH48 1QT Wirral | British | 7353920002 | ||||||
| PUDDEPHATT, George Ernest | Amministratore | Upper Lodge Switchback Lane Rowledge GU10 4DS Farnham Surrey | British | 11486450002 | ||||||
| RAYNER, Paul Adrian | Amministratore | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| TILSTON, David Frank | Amministratore | Cawsey Way GU21 6QX Woking Export House Surrey United Kingdom | England | British | 157476100001 | |||||
| YOUNG, Kevin Andrew | Amministratore | 35 Dean Close GU22 8NX Pyrford Surrey | England | British | 102706960001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PCE HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kier Parkman Gb Limited | 06 apr 2016 | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PCE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creato il 13 mag 1988 Consegnato il 20 mag 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 204 rowan house, greycoat street london and parking space 204 t/no ngl 604187. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Further guarantee & debenture | Creato il 14 ago 1981 Consegnato il 25 ago 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 12 ago 1980 Consegnato il 18 ago 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari (See doc M18). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Further guarantee & debenture | Creato il 09 mag 1979 Consegnato il 21 mag 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Further guarantee & debenture | Creato il 17 dic 1975 Consegnato il 06 gen 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee debenture | Creato il 13 nov 1975 Consegnato il 24 nov 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from the company and/or ward ashcroft & parkman to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari First fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. (See doc. 15). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0