SUNSITES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUNSITES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01152708
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUNSITES LIMITED?

    • (9305) /

    Dove si trova SUNSITES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hartford Manor
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUNSITES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SUNSITES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2011 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 set 2011

    Stato del capitale al 07 set 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Stato del capitale al 25 mar 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    12 pagineAA

    Nomina di Mr Neil Irvine Bright come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Baddeley come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Gregory Baddeley il 31 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy William May il 31 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Alexandra Dilys Williamson il 31 ago 2010

    2 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Gregory Baddeley il 08 giu 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Gregory Baddeley il 15 gen 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    20 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine403a

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    12 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di SUNSITES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMSON, Alexandra Dilys
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    British100325220002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director180993450001
    MAY, Timothy William
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant27408660003
    MAY, Timothy William
    16 Dukes Walk
    Hale
    WA15 8WB Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    16 Dukes Walk
    Hale
    WA15 8WB Altrincham
    Cheshire
    British27408660003
    ALLEN, Jeremy
    63 Brunswick Road
    WA14 1LP Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    63 Brunswick Road
    WA14 1LP Altrincham
    Cheshire
    BritishOperations Director41216000001
    ANGOVE, Morwenna Michelle
    108 Bold Street
    WA14 2EH Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    108 Bold Street
    WA14 2EH Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishMarketing Director157060590001
    ATKINSON, Richard Westaway
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Smithy Lane Farm
    Rainow
    SK10 5UP Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director111861370001
    BADDELEY, Robert Gregory
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenbank Lane
    CW8 1HW Northwich
    Hartford Manor
    Cheshire
    United Kingdom
    Great BritainBritishChartered Accountant28024220020
    CREW, James Robert
    123 Hale Road
    Hale
    WA15 9HQ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    123 Hale Road
    Hale
    WA15 9HQ Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector Of Services & Operati15842470001
    HARMAN, Gordon
    Withinlee Cottage
    Within Lee Road Mottram
    SK10 4QE St Andrew
    Cheshire
    Amministratore
    Withinlee Cottage
    Within Lee Road Mottram
    SK10 4QE St Andrew
    Cheshire
    BritishFinance Director102037580001
    LEPPARD, Martin Neal
    Claverdon Manor
    Manor Lane
    CV35 8NH Claverdon
    Warwickshire
    Amministratore
    Claverdon Manor
    Manor Lane
    CV35 8NH Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritishEuropean Marketing Director155863600001
    OAKLEY, Robert
    37 Sharston Crescent
    WA16 8AF Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    37 Sharston Crescent
    WA16 8AF Knutsford
    Cheshire
    BritishDirector66242980002
    RAWEL, Julian Stephen
    The White House Chapel Road
    SK9 7DU Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    The White House Chapel Road
    SK9 7DU Alderley Edge
    Cheshire
    BritishSales & Marketing Director57071710002
    SAUNDERS, Christopher Hugh
    Beccas Well 9 Dinghouse Wood
    Drury
    CH7 3DH Buckley
    Clwyd
    Amministratore
    Beccas Well 9 Dinghouse Wood
    Drury
    CH7 3DH Buckley
    Clwyd
    BritishAgency Sales Manager32389210001

    SUNSITES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 01 ago 2000
    Consegnato il 16 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (or any of them) under the banking documents to which such charging company is a party
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 feb 1995
    Consegnato il 15 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of any of the facility agreements, the facility documents or otherwise (as defined in the deed)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 lug 1993
    Consegnato il 23 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture.
    Creato il 02 ago 1991
    Consegnato il 22 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See form 395. ref M384F for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 ago 1991
    Consegnato il 06 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Invesment Bank Limited
    Transazioni
    • 06 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 nov 1988
    Consegnato il 09 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as trusteee on behalf of the bengiciaries as defined in the deed on any account whatsoever wider the facility documents and the senior facilities as defined in the deed.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 26 nov 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    15 3/4% secured loan note 1987
    Creato il 08 mag 1986
    Consegnato il 15 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £300,000 all monies due or to become due from powerspot limited to the noteholder as defined
    Brevi particolari
    Book debts present & future due or owing to the company negotiatable instruments, legal and equitable charges, reservation of proprietory rights, rights of tracing & vendors liens & similar & associated rights. All property & assets both prresent & future (see doc 21 for further details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transazioni
    • 15 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 10 mag 1983
    Consegnato il 17 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 24 nov 1980
    Consegnato il 11 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0