DAVIN OPTRONICS LIMITED

DAVIN OPTRONICS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDAVIN OPTRONICS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01152753
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DAVIN OPTRONICS LIMITED?

    • fabbricazione di strumenti ottici di precisione (26701) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova DAVIN OPTRONICS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    White Maund
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DAVIN OPTRONICS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DAVIN OPTICAL LIMITED20 dic 197320 dic 1973

    Quali sono gli ultimi bilanci di DAVIN OPTRONICS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per DAVIN OPTRONICS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Avviso di termine automatico dell'amministrazione

    15 pagine2.30B

    Risultato della riunione dei creditori

    1 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    30 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    8 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da Instrument House Greycaine Road Watford Hertfordshire WD24 7GW a White Maund 44-46 Old Steine Brighton East Sussex BN1 1NH in data 30 ott 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 apr 2014

    Stato del capitale al 02 apr 2014

    • Capitale: GBP 3,506,400
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 011527530015

    21 pagineMR01
    Note
    DataNota
    17 gen 2014This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    14 pagineMG01

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    16 pagineMG04

    legacy

    16 pagineMG04

    legacy

    13 pagineMG02

    legacy

    4 pagineMG04

    legacy

    6 pagineMG01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di DAVIN OPTRONICS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOOD, Thomas William
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    White Maund
    East Sussex
    Segretario
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    White Maund
    East Sussex
    156423710001
    GOOD, Thomas William
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    White Maund
    East Sussex
    Amministratore
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    White Maund
    East Sussex
    United KingdomBritishAccountant21310620010
    PARSONS, Robert Michael Featherstonehaugh
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    White Maund
    East Sussex
    Amministratore
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    White Maund
    East Sussex
    United KingdomBritishOperations Director51846740001
    CAMPBELL, Colin David
    All Saints House Lydalls Close
    OX11 7LA Didcot
    Oxfordshire
    Segretario
    All Saints House Lydalls Close
    OX11 7LA Didcot
    Oxfordshire
    British62046750001
    COWIN, Ian Harold
    39 The Elms
    SG13 7UY Hertford
    Hertfordshire
    Segretario
    39 The Elms
    SG13 7UY Hertford
    Hertfordshire
    BritishAccountant64879500001
    MILSOM, David
    21 Wycombe Road
    Holmer Green
    HP15 6RX Buckinghamshire
    Segretario
    21 Wycombe Road
    Holmer Green
    HP15 6RX Buckinghamshire
    British88306300001
    ROWLAND, Martin Andrew
    Saxons
    New Road Ridgewood
    TN22 5TG Uckfield
    East Sussex
    Segretario
    Saxons
    New Road Ridgewood
    TN22 5TG Uckfield
    East Sussex
    BritishAccountant33410820001
    ROWLAND, Martin Andrew
    Saxons
    New Road Ridgewood
    TN22 5TG Uckfield
    East Sussex
    Segretario
    Saxons
    New Road Ridgewood
    TN22 5TG Uckfield
    East Sussex
    British33410820001
    ROZARIO, Adrian Philip
    The Old Corner House
    Church Lane
    SL3 6LB Wexham
    Berkshire
    Segretario
    The Old Corner House
    Church Lane
    SL3 6LB Wexham
    Berkshire
    BritishAccountant80669880001
    ADAWAY, William George Leslie
    Coronation Road
    Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Little Cellini
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Coronation Road
    Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Little Cellini
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector23477250004
    BROCK, Ian
    67 Elm Park Road
    Finchley
    N3 1EG London
    Amministratore
    67 Elm Park Road
    Finchley
    N3 1EG London
    BritishCommercial Director55862480001
    CARR, John Henry
    43 Hambling Drive
    Molescroft
    HU17 9GD Beverley
    East Riding Of Yorkshire
    Amministratore
    43 Hambling Drive
    Molescroft
    HU17 9GD Beverley
    East Riding Of Yorkshire
    BritishDirector33288200002
    CHILTON, Robert Grosvenor
    88 Norman Crescent
    HA5 3QL Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    88 Norman Crescent
    HA5 3QL Pinner
    Middlesex
    BritishSales Marketing64850770002
    COWIN, Ian Harold
    39 The Elms
    SG13 7UY Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    39 The Elms
    SG13 7UY Hertford
    Hertfordshire
    Great BritainBritishAccountant64879500001
    FRANKS, John William
    38 Savay Close
    UB9 5NG Denham
    Middlesex
    Amministratore
    38 Savay Close
    UB9 5NG Denham
    Middlesex
    BritishCompany Director51368600001
    GOOD, Thomas William
    Instrument House Greycaine Road
    Watford
    WD24 7GW Hertfordshire
    Amministratore
    Instrument House Greycaine Road
    Watford
    WD24 7GW Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector21310620009
    HARRISON, Alfred Joseph
    107 Wilson Avenue
    ME1 2SJ Rochester
    Kent
    Amministratore
    107 Wilson Avenue
    ME1 2SJ Rochester
    Kent
    BritishRetired4903290001
    HEDGES, Andrew Colin
    333 St Albans Road West
    AL10 9RN Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    333 St Albans Road West
    AL10 9RN Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritishProduction50288140001
    HOLLAND, David John James
    42 The Squirrels
    HA5 3BD Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    42 The Squirrels
    HA5 3BD Pinner
    Middlesex
    BritishDirector24867350001
    JINKS, Nigel George
    4 Beech Drive
    Thurlaston
    CV23 9JT Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    4 Beech Drive
    Thurlaston
    CV23 9JT Rugby
    Warwickshire
    BritishDirector9052970001
    JUDD, Edward James
    21 Fishery Road
    HP1 1NB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    21 Fishery Road
    HP1 1NB Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishDirector4903280001
    KNOWLES, John
    Oakhouse
    Norton
    SN16 0JW Malmesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Oakhouse
    Norton
    SN16 0JW Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector54539110001
    PARSONS, Robert Michael Featherstonehaugh
    Instrument House Greycaine Road
    Watford
    WD24 7GW Hertfordshire
    Amministratore
    Instrument House Greycaine Road
    Watford
    WD24 7GW Hertfordshire
    United KingdomBritishOperations Director51846740001
    ROWLAND, Martin Andrew
    Saxons
    New Road Ridgewood
    TN22 5TG Uckfield
    East Sussex
    Amministratore
    Saxons
    New Road Ridgewood
    TN22 5TG Uckfield
    East Sussex
    EnglandBritishAccountant33410820001
    ROZARIO, Adrian Philip
    The Old Corner House
    Church Lane
    SL3 6LB Wexham
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Corner House
    Church Lane
    SL3 6LB Wexham
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant80669880001
    SKILLETER, Cindy Gray
    22 St Peters Avenue
    SG15 6UR Arlesey
    Bedfordshire
    Amministratore
    22 St Peters Avenue
    SG15 6UR Arlesey
    Bedfordshire
    BritishAccounting50288160001

    DAVIN OPTRONICS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 dic 2013
    Consegnato il 17 gen 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Robert Michael Parsons
    • Thomas William Good
    Transazioni
    • 17 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    All assets debenture
    Creato il 13 nov 2012
    Consegnato il 16 nov 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the factor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 16 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 31 lug 2012
    Consegnato il 09 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Sme Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 09 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 27 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 15 dic 2010
    Consegnato il 30 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of security the benefits arising under the policies; and any contracts relating to or benefiting the plant and machinery:. Matsuura h plus 300 PC11 pallet horizontal cnc. Serial no. 15801. year 2004. with matsuura g tech 16I control, 120 atc, swarf coneyor, coolant filtration, FX4000 filter mist,. 15,000 rpm tooling. (For details of further chattels charged, please refer to the MGO1 document) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 30 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 15 dic 2010
    Consegnato il 30 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 30 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 07 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 dic 2010
    Consegnato il 20 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The goodwill business undertaking property book debts assets revenue rights and uncalled capital belonging to company or to which the company is or may become entitled or in which the company may have an interest.
    Persone aventi diritto
    • William George Leslie Adaway
    Transazioni
    • 20 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Chattel mortgage
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its plant and machinery being meddings 6-spindle in-line pillar drill manual feed drill heads, 2 tapping attachments with related equipment plant n/o W68, vanco model no.1 1" vertical belt linishing machine mounted on dust collecting cabinet s/n 16286 and hardinge hand feed horizontal milling machine' 40 international taper with arbor supports and related equipment for details of further equipment charged please refer to form 395, by way of floating charge all of the undertaking, property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 24 mag 2001
    Consegnato il 30 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any financing agreement (as defined in the all asset debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 30 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 mar 2000
    Consegnato il 24 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transazioni
    • 24 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 mar 1997
    Consegnato il 04 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 31 gen 1994
    Consegnato il 04 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed and floating charge dated 29 march 1990
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 mar 1990
    Consegnato il 11 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Book debts debenture
    Creato il 29 mar 1990
    Consegnato il 06 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book & other debts (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Causeway Invoice Discounting Company Limited
    Transazioni
    • 06 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 apr 1987
    Consegnato il 07 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 15 lug 1976
    Consegnato il 22 lug 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge (see doc M8). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DAVIN OPTRONICS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 ott 2014Inizio dell'amministrazione
    12 ott 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher James Latos
    White Maund 44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    Praticante
    White Maund 44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    Susan Agnes Maund
    White Maund Llp
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex
    Praticante
    White Maund Llp
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0