HARWORTH POWER LIMITED

HARWORTH POWER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARWORTH POWER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01156905
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HARWORTH POWER LIMITED?

    • Produzione di energia elettrica (35110) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

    Dove si trova HARWORTH POWER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HARWORTH POWER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FILTRACITE LIMITED15 gen 197415 gen 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARWORTH POWER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per HARWORTH POWER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    23 pagineLIQ14

    Morte di un liquidatore

    3 pagineLIQ09

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2020

    19 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2019

    13 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2018

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2017

    16 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5RU a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 19 apr 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2016

    11 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    9 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2015

    18 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 lug 2014

    15 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * Harworth Park Blyth Road Harworth Doncaster South Yorkshire DN11 8DB* in data 18 lug 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Martin Terence Alan Purvis come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Harworth Secretariat Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Dettagli del segretario cambiati per Uk Coal Secretariat Services Limited il 17 apr 2013

    1 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2013

    Stato del capitale al 08 apr 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Chi sono gli amministratori di HARWORTH POWER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PURVIS, Martin Terence Alan
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Segretario
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    177796090001
    HUTCHINSON, Stephen John
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    United KingdomBritishFinance Director174502100001
    REED, Colin Frederick
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishNone174641750001
    BELLAMY, Valerie
    Granary Cottage
    Clayworth
    DN22 9AD Retford
    Notts
    Segretario
    Granary Cottage
    Clayworth
    DN22 9AD Retford
    Notts
    BritishAccountant33796010001
    COLE, Richard Andrew
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    Segretario
    Lodge Farm
    Eakring Road, Wellow
    NG22 0EG Newark
    Nottinghamshire
    British58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Segretario
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director18761260001
    RHODES, Jeremy
    Harworth Park
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Harworth Park
    Blyth Road
    DN11 8DB Harworth Doncaster
    South Yorkshire
    British169990670001
    SHAW, Mary Teresa
    5 Lanark Drive
    S64 0QY Mexborough
    South Yorkshire
    Segretario
    5 Lanark Drive
    S64 0QY Mexborough
    South Yorkshire
    British6780940001
    HARWORTH SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8223049
    172322000002
    BREHENY, Thomas
    Hye Bern Clyro Place
    Sutton Cum Lound
    DN22 8PE Retford
    Amministratore
    Hye Bern Clyro Place
    Sutton Cum Lound
    DN22 8PE Retford
    United KingdomBritishCompany Director126526650001
    BROCKSOM, David Graham
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    7 York Road
    HG1 2QA Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant96416100003
    BUDGE, Richard John
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Wiseton Hall
    Wiseton
    DN10 5AE Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director27948060002
    COLE, Richard Andrew
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    Amministratore
    Eakring Road
    Wellow
    NG22 0EG Newark
    Lodge Farm
    EnglandBritishCompany Secretary58361870002
    GARNESS, Melvin
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    11 The Drive
    DN22 6SD Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director18761260001
    HAGUE, Jeremy Richard
    Park Crescent
    DN22 6UF Retford
    5
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Park Crescent
    DN22 6UF Retford
    5
    Nottinghamshire
    EnglandBritishAccountant115747040001
    JARRETT, George William
    Wenvoe 51 Woodhill Road
    Collingham
    NG23 7NR Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Wenvoe 51 Woodhill Road
    Collingham
    NG23 7NR Newark
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director30751750001
    LANDON, David
    Thorpe House
    Headon
    DN22 0RD Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Thorpe House
    Headon
    DN22 0RD Retford
    Nottinghamshire
    BritishAssistant Group Director39068820003
    LLOYD, Jonathan Simon
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    Amministratore
    Orchard House
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QY York
    United KingdomBritishChartered Surveyor95211330002
    LONGDEN, John Charles Henry
    Stonebank Potter Lane
    Wellow
    NG22 0EB Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Stonebank Potter Lane
    Wellow
    NG22 0EB Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishGroup Director15825610001
    MARSHALL, Dennis
    Avebury House 7 Dunniwood Reach
    Bessacarr
    DN4 7AS Doncaster
    South Yorks
    Amministratore
    Avebury House 7 Dunniwood Reach
    Bessacarr
    DN4 7AS Doncaster
    South Yorks
    BritishAccountant6780950001
    MAWE, Christopher
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    5 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    North Yorkshire
    BritishFinance Director99084660001
    MCPHIE, Gordon Allister
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    Amministratore
    Wigley Green Farmhouse
    S42 7JJ Old Brampton
    Derbyshire
    BritishCompany Director35904020001
    MICHAELSON, Richard Owen
    Ebford
    EX3 0PA Exeter
    Four Winds
    Devon
    Amministratore
    Ebford
    EX3 0PA Exeter
    Four Winds
    Devon
    EnglandBritishCompany Director174637950001
    O'BRIEN, Patrick Sampson
    The Pantiles Main Street
    Hayton
    DN22 9LH Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Pantiles Main Street
    Hayton
    DN22 9LH Retford
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director52186290001
    OLDHAM, David Raymond
    2 Lake Farm Road
    Rainworth
    NG21 0ED Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    2 Lake Farm Road
    Rainworth
    NG21 0ED Mansfield
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishEngineereing Manager30622580001
    PARKER, Susan Patricia
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    South Humberside
    Amministratore
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    South Humberside
    BritishPurchasing Manager29758680001
    PARKIN, Stephen John
    87 Sparken Hill
    S80 3AJ Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    87 Sparken Hill
    S80 3AJ Worksop
    Nottinghamshire
    BritishColliery Manager39068910002
    PENNELL, Christopher Hedley
    6 Alms Hill Road
    S11 9RS Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    6 Alms Hill Road
    S11 9RS Sheffield
    South Yorkshire
    BritishPurchasing Manager31270970001
    ROBERTS, Nicholas Andrew
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Blyth Road
    Harworth
    DN11 8DB Doncaster
    Harworth Park
    South Yorkshire
    England
    United KingdomBritishNone174640290001
    ROWELL, William
    6 Bracken Lane
    DN22 7EU Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    6 Bracken Lane
    DN22 7EU Retford
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director35205460002
    SHAW, Mary Teresa
    5 Lanark Drive
    S64 0QY Mexborough
    South Yorkshire
    Amministratore
    5 Lanark Drive
    S64 0QY Mexborough
    South Yorkshire
    BritishAccountant6780940001
    SPINDLER, Garold Ralph
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    Amministratore
    Manor House
    Westhaugh Tumbling Hill Carleton
    WF8 2RP Pontefract
    AmericanMining Engineer101195530002
    WRIGHT, Brian Charles
    Oaklands
    17 Heath Avenue
    NG18 3EU Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Oaklands
    17 Heath Avenue
    NG18 3EU Mansfield
    Nottinghamshire
    BritishGroup Director40551720001

    HARWORTH POWER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 26 apr 2012
    Consegnato il 03 mag 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the further company and the existing companies or any of them to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Its credit balances. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage
    Creato il 10 ott 2008
    Consegnato il 17 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,400,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The items listed on the schedule being - kellingley colliery, york chiller unit 1, serial number 24190 D.O.M. 2002; york chiller unit 2, serial number 24195, D.O.M. 2002; hoval farrar limited water separator, serial number 55084, D.O.M. 1991, for details of further goods charged please refer to form 395, together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge over chattels
    Creato il 03 gen 2007
    Consegnato il 04 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 ge jenbacher 420 series containerised spark ignition gas engine generators rating - 1415KWE 415V 50HZ 0.8PF fuel - methane/mines gas/natural gas generators are complete units with gas train contral system synchronising breaker cooling water radiators lube oil system exhaust silencer serial numbers engine 1 3318911 engine 2 3398281. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transazioni
    • 04 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 23/06/1999 and
    Creato il 01 mar 2006
    Consegnato il 14 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 09 mar 2004
    Consegnato il 25 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all moneys standing to the credit of any account of the company all benefits due or arising to the company in respect of any and all contracts and policies of insurance taken out by or on behalf of the company or in which the company has an interest all of the companys book trade and other debts the companys goodwill by way of floating charge all of the companys assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 25 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2004
    Consegnato il 17 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all moneys standing to the credit of any account, all benefits in respect of the insurances, all of the chargors' book, trade and other debts, all of the chargors' stock and inventory their goodwill and the benefit of all authorisations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Leasing Limited
    Transazioni
    • 17 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 ott 1999
    Consegnato il 19 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever to any finance party under each finance document to which that chargor is a party except for any obligation which if it were so included would result in this deed contravening section 151 of the companies act 1985 and to the ancillary bank under the ancillary facility in any capacity whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys standing to the credit of any account all benefits in respect of the insurances all book trade and other debts all stocks and inventory the goodwill and the benefit of all authorisations.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia (As Agent)
    Transazioni
    • 19 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HARWORTH POWER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 dic 2021Data prevista di scioglimento
    29 lug 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Bates
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Edward Terence Kerr
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire
    Praticante
    Pannell House 159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Leicestershire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0