C LIFE PENSIONS LIMITED

C LIFE PENSIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàC LIFE PENSIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01166185
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di C LIFE PENSIONS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CROWN LIFE PENSIONS LIMITED09 apr 197409 apr 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da * Windsor House Telford Centre Telford Shropshire TF3 4NB* in data 29 ago 2013

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 apr 2013

    Stato del capitale al 22 apr 2013

    • Capitale: GBP 28,900,000
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    3 pagineMR04

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Roger Craine come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Michael Charles Woodcock come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di C LIFE PENSIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHAKESPEARE, Paul
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Segretario
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    British135096740002
    WOODCOCK, Michael Charles
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Amministratore
    c/o Grant Thornton Uk Llp
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish102653720001
    COLLOFF, Lyn Carol
    4 Redwood Drive
    BH22 9UH Ferndown
    Dorset
    Segretario
    4 Redwood Drive
    BH22 9UH Ferndown
    Dorset
    British3771140003
    GEIRINGER, Bruno Marcel David
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    Segretario
    83 Westbury Road
    KT3 5AL New Malden
    Surrey
    British35563990001
    LEWIS, Sarah
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Segretario
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    British113431840001
    OSBORNE, Gregory David
    Blackthorn House
    The Drive
    RH14 0TD Ifold Billinghurst
    West Sussex
    Segretario
    Blackthorn House
    The Drive
    RH14 0TD Ifold Billinghurst
    West Sussex
    British30589910001
    SHAKESPEARE, Paul
    Guttery Close
    Wem
    SY4 5YG Shrewsbury
    2
    Shropshire
    Segretario
    Guttery Close
    Wem
    SY4 5YG Shrewsbury
    2
    Shropshire
    British135096740001
    BANHAM, Stephen Howard
    Kanungo Lodge
    Friars Rise,Ashwood Road
    GU22 7JL Woking
    Surrey
    Amministratore
    Kanungo Lodge
    Friars Rise,Ashwood Road
    GU22 7JL Woking
    Surrey
    British34027830001
    BEILES, Herbert Noel
    28 Hanover House
    NW8 7DY London
    Amministratore
    28 Hanover House
    NW8 7DY London
    Canadian7595230001
    BERRYMAN, Malcolm Leonard
    Pilgrims, Clease Way, Compton
    SO21 2AL Winchester
    Amministratore
    Pilgrims, Clease Way, Compton
    SO21 2AL Winchester
    British114331270001
    BURTON, Geoffrey Michael
    6 Stratfield Park Close
    Vicars Moor Lane
    N21 1BU Winchmore Hill
    London
    Amministratore
    6 Stratfield Park Close
    Vicars Moor Lane
    N21 1BU Winchmore Hill
    London
    British56942980001
    CRAINE, Roger
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    Amministratore
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    United KingdomBritish89585440001
    EDGINGTON, James Figg
    1 Windle Hill
    SY6 7AP Church Stretton
    Shropshire
    Amministratore
    1 Windle Hill
    SY6 7AP Church Stretton
    Shropshire
    British28278640001
    GREENWOOD, Nicholas John
    Pebblecombe Oatlands Mere
    KT13 9PD Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Pebblecombe Oatlands Mere
    KT13 9PD Weybridge
    Surrey
    British1428560001
    HEFER, Andre Viljoen
    54 Beacon Street
    WS13 7AJ Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    54 Beacon Street
    WS13 7AJ Lichfield
    Staffordshire
    South African31916230002
    JOHNSON, Brian Arthur
    3726 Currie Bay
    Regina
    S4S 7C7 Saskatchewan
    Canada
    Amministratore
    3726 Currie Bay
    Regina
    S4S 7C7 Saskatchewan
    Canada
    Canadian37319720001
    KIDNER, John Michael
    22 Chantry Hurst
    Woodcote
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Amministratore
    22 Chantry Hurst
    Woodcote
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    British37311990001
    NELSON, Peter
    Sid House Sid Road
    EX10 9AH Sidmouth
    Devon
    Amministratore
    Sid House Sid Road
    EX10 9AH Sidmouth
    Devon
    British27490720001
    REID, Norman Haydn
    27 Silhill Hall Road
    B91 1JX Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    27 Silhill Hall Road
    B91 1JX Solihull
    West Midlands
    British3771150001
    ROWE, Alan Macdonald
    209-2275 Mcintyre Street
    Regina
    S4P 251 Saskatchewan
    Canada
    Amministratore
    209-2275 Mcintyre Street
    Regina
    S4P 251 Saskatchewan
    Canada
    Canadian37319920001
    SCOTT, Brian
    High Bank House
    Fron Bank Cil-Cewydd Forden
    SY21 8RY Welshpool
    Powys
    Amministratore
    High Bank House
    Fron Bank Cil-Cewydd Forden
    SY21 8RY Welshpool
    Powys
    British77838030001
    WITHEY, Andrew John
    Birchwood Cottage Headley Hill Road
    Headley
    GU35 8DS Bordon
    Hampshire
    Amministratore
    Birchwood Cottage Headley Hill Road
    Headley
    GU35 8DS Bordon
    Hampshire
    British7613090001
    WYBREW, John Leonard
    Hill Farm House
    CW6 0JD Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Hill Farm House
    CW6 0JD Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish35286500002
    YATES, Jonathan James
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Amministratore
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    British51117310003

    C LIFE PENSIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 02 lug 1991
    Consegnato il 18 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property situate and k/a unit 6 batford mill lower luton road harpenden hertfordshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 02 lug 1991
    Consegnato il 18 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 7 batford mill lower luton road harpenden herts and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 02 lug 1991
    Consegnato il 18 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 7 batford mill lower luton road harpenden hertfordshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 22 mag 1991
    Consegnato il 08 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or r a twist and/or s j allan (as trustees) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/a property k/a 3/8 hale road widnes cheshire t/no:- ch 305411.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 12 dic 1990
    Consegnato il 21 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £225,000 & all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    1 mentmore terrace london E8 t/n egl 205093 goodwill of the business floating charge over undertaking and all property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Exeter Trust Limited
    Transazioni
    • 21 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 lug 1989
    Consegnato il 03 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    529C and 529D finchley road hampstead london.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 11 mag 1989
    Consegnato il 12 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 3 river view walnut tree close guildford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 20 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mag 1988
    Consegnato il 01 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that piece of land together with building erected thereon & the parking area adjacent thereto numbered units 2 & 3 st andrews court, st andrews road,droitwich hereford & worcester together with all buildings & fixtures assigns goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 13 apr 1988
    Consegnato il 29 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 65000 and all other monies due or to become due from the company and/or allen albert strange and elizabeth anne strange (as trustees)
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 5 the townsend centre, blackburn road, houghton regis bedfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Stor Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 29 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 10 ago 1987
    Consegnato il 11 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 280000 and all other moneys due or to become due from the company as trustees of the superline tapes co limited directors pensions plan to the chargee under the terms of a facility letter dated 10/2/87 and/or this charge
    Brevi particolari
    Units 6 and 7 batford mill lower luton road harpenden herts. And all buildings erections fixtures fittings fixed plant & machinery & all other items in the nature of landlords fixtures & fittings and all improvements & additions.
    Persone aventi diritto
    • Hfc Trust & Savings Limited
    Transazioni
    • 11 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 set 1986
    Consegnato il 07 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 75000 and all other moneys due or to become due from the company and/or red/grey limited and/or andrew george millns and/or maurice brian linke to the chargee
    Brevi particolari
    F/Hold property k/as 32 englands lane and 25A elizabeths mews hampstead in the london borough of camden title no ngl 427545.
    Persone aventi diritto
    • Norwich General Trust Limited
    Transazioni
    • 07 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 11 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 26 giu 1984
    Consegnato il 12 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or denis evans and/or michael stewart slade as trustees of the epp pension fund
    Brevi particolari
    168 cheltenham road, bristol. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks Limited
    Transazioni
    • 12 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 28 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 1982
    Consegnato il 21 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 40000
    Brevi particolari
    2ND and mezzanine floors of the building known as 17/19 neal street, london WC2.
    Persone aventi diritto
    • B J E Spicer
    • S M J Spicer
    Transazioni
    • 21 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 17 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Equitable charge
    Creato il 13 nov 1981
    Consegnato il 01 dic 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 25000
    Brevi particolari
    F/Hold 529C and 529D finchley road, london NW3.
    Persone aventi diritto
    • Interphone Limited
    Transazioni
    • 01 dic 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    C LIFE PENSIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 ago 2013Inizio della liquidazione
    11 lug 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Richard Graham White
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0