IMPACT MARCOM LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIMPACT MARCOM LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01166286
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IMPACT MARCOM LTD?

    • Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova IMPACT MARCOM LTD?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IMPACT MARCOM LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAR-COM SYSTEMS LIMITED03 mag 198503 mag 1985
    VISUAL MAR-COM SYSTEMS LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    COPYWRITE METHODS LIMITED09 apr 197409 apr 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di IMPACT MARCOM LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per IMPACT MARCOM LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 mag 2019

    11 pagineLIQ03

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Europe House 170 Windmill Road West Sunbury on Thames Middlesex TW16 7HB a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 22 ago 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 02 ago 2018

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 giu 2018

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 011662860009 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 giu 2017

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 set 2015

    Stato del capitale al 17 set 2015

    • Capitale: GBP 667,000
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 011662860009, creata il 24 mar 2015

    55 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 set 2014

    Stato del capitale al 19 set 2014

    • Capitale: GBP 667,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di IMPACT MARCOM LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALLEN, John
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish182527790001
    COOK, Edward Charles Peregrine Phelps
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish52906920005
    KENNEDY, Ewan Campbell
    Flat 11 Crawley Rise
    18 Portsmouth Road
    GU15 1JX Camberley
    Surrey
    Segretario
    Flat 11 Crawley Rise
    18 Portsmouth Road
    GU15 1JX Camberley
    Surrey
    British33639840003
    PORTER, Simon Neil
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Segretario
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    British174403180001
    SEYMOUR, Barry James
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    Segretario
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    British1306660001
    STEWARD, Charles David
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    Segretario
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    British103109350002
    ALLIN, John Leslie
    5 Elmbrook Vale
    RG11 Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    5 Elmbrook Vale
    RG11 Wokingham
    Berkshire
    British16272300001
    AZAM, Mohammed
    Jenner Way
    KT19 7LJ Epsom
    3
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Jenner Way
    KT19 7LJ Epsom
    3
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish135689290001
    BRAY, Myles Edward James
    Woodmancott
    SO21 3BN Winchester
    Woodmancott House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Woodmancott
    SO21 3BN Winchester
    Woodmancott House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish135690640001
    CAUSEVIC, Fredd
    Bekkestua 9a
    Bekkestua
    N-1357
    Norway
    Amministratore
    Bekkestua 9a
    Bekkestua
    N-1357
    Norway
    NorwayNorwegian75177110001
    DEMPSTER, Brian Leigh Harding
    14 Nutfield Gardens
    UB5 6LT Northolt
    Middlesex
    Amministratore
    14 Nutfield Gardens
    UB5 6LT Northolt
    Middlesex
    British16272310001
    ELLIS, Kenneth Leonard
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Amministratore
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandBritish149204440001
    GORTON, Robert David
    55 Redhill Wood
    New Ash Green
    DA3 8QP Longfield
    Kent
    Amministratore
    55 Redhill Wood
    New Ash Green
    DA3 8QP Longfield
    Kent
    EnglandBritish28341780002
    HUDSON, Mark Alan
    Crawshay Drive
    Emmer Green
    RG4 8SY Reading
    58
    England
    Amministratore
    Crawshay Drive
    Emmer Green
    RG4 8SY Reading
    58
    England
    EnglandBritish180576890001
    JEWITT, Anthony John
    13 Pelling Hill
    Old Windsor
    SL4 2LL Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    13 Pelling Hill
    Old Windsor
    SL4 2LL Windsor
    Berkshire
    British785310001
    KENNEDY, Ewan Campbell
    Braybourne House
    Crawley Ridge
    GU15 2AD Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Braybourne House
    Crawley Ridge
    GU15 2AD Camberley
    Surrey
    British33639840004
    MORAN, Michael Owen
    Australind The Street
    West Clandon
    GU4 7TE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Australind The Street
    West Clandon
    GU4 7TE Guildford
    Surrey
    British1306650001
    PHILLIPS, Julian Brian
    Oakwood
    15 Oxted Green, Milford
    GU8 5D Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Oakwood
    15 Oxted Green, Milford
    GU8 5D Godalming
    Surrey
    EnglandBritish122795570002
    PORTER, Simon Neil
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    Amministratore
    Europe House
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury On Thames
    Middlesex
    EnglandUnited Kingdom55262300006
    RAWLINGS, Timothy Paul
    11 Lulworth Road
    DA16 3LQ Welling
    Kent
    Amministratore
    11 Lulworth Road
    DA16 3LQ Welling
    Kent
    British20665210002
    ROBINSON, Mark Laurence
    43 Worminghall Road
    Ickford
    HP18 9JB Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    43 Worminghall Road
    Ickford
    HP18 9JB Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish43184090002
    SEYMOUR, Barry James
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    Amministratore
    9 Fort Street
    GU1 3TB Guildford
    Surrey
    EnglandBritish1306660001
    SMITH, John
    Allenwood
    161 London Road
    CM7 8PT Braintree
    Essex
    Amministratore
    Allenwood
    161 London Road
    CM7 8PT Braintree
    Essex
    British66391760001
    STEWARD, Charles David
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    Amministratore
    17 Windrush Close
    Bramley
    GU5 0BB Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish103109350002
    TITLER, Alec
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    Amministratore
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    EnglandBritish48506930001
    TITLER, Alec
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    Amministratore
    11 Greenways
    Malt Hill
    TW20 9PA Egham
    Surrey
    EnglandBritish48506930001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IMPACT MARCOM LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    England
    06 apr 2016
    170 Windmill Road West
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02468436
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    IMPACT MARCOM LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 mar 2015
    Consegnato il 28 mar 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 28 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental deed to a debenture
    Creato il 03 dic 2012
    Consegnato il 10 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Indigo Capital V Sarl
    Transazioni
    • 10 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 dic 2012
    Consegnato il 08 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 apr 2010
    Consegnato il 11 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed & floating charge
    Creato il 03 mar 2008
    Consegnato il 08 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 08 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 ago 2007
    Consegnato il 24 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage pursuant to an order of court dated 16/7/91
    Creato il 26 set 1990
    Consegnato il 18 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 12 capitol park pearce way gloucester.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 ott 1981
    Consegnato il 12 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book detbs uncalled captial, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 giu 1980
    Consegnato il 09 giu 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1980Registrazione di un'ipoteca

    IMPACT MARCOM LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 ago 2019Data prevista di scioglimento
    02 ago 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0