IMPACT MARCOM LTD
Panoramica
| Nome della società | IMPACT MARCOM LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01166286 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IMPACT MARCOM LTD?
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova IMPACT MARCOM LTD?
| Indirizzo della sede legale | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IMPACT MARCOM LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MAR-COM SYSTEMS LIMITED | 03 mag 1985 | 03 mag 1985 |
| VISUAL MAR-COM SYSTEMS LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
| COPYWRITE METHODS LIMITED | 09 apr 1974 | 09 apr 1974 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IMPACT MARCOM LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per IMPACT MARCOM LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 mag 2019 | 11 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Europe House 170 Windmill Road West Sunbury on Thames Middlesex TW16 7HB a 55 Baker Street London W1U 7EU in data 22 ago 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 25 giu 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 011662860009 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2017 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2016 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 011662860009, creata il 24 mar 2015 | 55 pagine | MR01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2014 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di IMPACT MARCOM LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEN, John | Amministratore | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 182527790001 | |||||
| COOK, Edward Charles Peregrine Phelps | Amministratore | Baker Street W1U 7EU London 55 | England | British | 52906920005 | |||||
| KENNEDY, Ewan Campbell | Segretario | Flat 11 Crawley Rise 18 Portsmouth Road GU15 1JX Camberley Surrey | British | 33639840003 | ||||||
| PORTER, Simon Neil | Segretario | Europe House 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury On Thames Middlesex | British | 174403180001 | ||||||
| SEYMOUR, Barry James | Segretario | 9 Fort Street GU1 3TB Guildford Surrey | British | 1306660001 | ||||||
| STEWARD, Charles David | Segretario | 17 Windrush Close Bramley GU5 0BB Guildford Surrey | British | 103109350002 | ||||||
| ALLIN, John Leslie | Amministratore | 5 Elmbrook Vale RG11 Wokingham Berkshire | British | 16272300001 | ||||||
| AZAM, Mohammed | Amministratore | Jenner Way KT19 7LJ Epsom 3 Surrey United Kingdom | England | British | 135689290001 | |||||
| BRAY, Myles Edward James | Amministratore | Woodmancott SO21 3BN Winchester Woodmancott House Hampshire United Kingdom | England | British | 135690640001 | |||||
| CAUSEVIC, Fredd | Amministratore | Bekkestua 9a Bekkestua N-1357 Norway | Norway | Norwegian | 75177110001 | |||||
| DEMPSTER, Brian Leigh Harding | Amministratore | 14 Nutfield Gardens UB5 6LT Northolt Middlesex | British | 16272310001 | ||||||
| ELLIS, Kenneth Leonard | Amministratore | Europe House 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury On Thames Middlesex | England | British | 149204440001 | |||||
| GORTON, Robert David | Amministratore | 55 Redhill Wood New Ash Green DA3 8QP Longfield Kent | England | British | 28341780002 | |||||
| HUDSON, Mark Alan | Amministratore | Crawshay Drive Emmer Green RG4 8SY Reading 58 England | England | British | 180576890001 | |||||
| JEWITT, Anthony John | Amministratore | 13 Pelling Hill Old Windsor SL4 2LL Windsor Berkshire | British | 785310001 | ||||||
| KENNEDY, Ewan Campbell | Amministratore | Braybourne House Crawley Ridge GU15 2AD Camberley Surrey | British | 33639840004 | ||||||
| MORAN, Michael Owen | Amministratore | Australind The Street West Clandon GU4 7TE Guildford Surrey | British | 1306650001 | ||||||
| PHILLIPS, Julian Brian | Amministratore | Oakwood 15 Oxted Green, Milford GU8 5D Godalming Surrey | England | British | 122795570002 | |||||
| PORTER, Simon Neil | Amministratore | Europe House 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury On Thames Middlesex | England | United Kingdom | 55262300006 | |||||
| RAWLINGS, Timothy Paul | Amministratore | 11 Lulworth Road DA16 3LQ Welling Kent | British | 20665210002 | ||||||
| ROBINSON, Mark Laurence | Amministratore | 43 Worminghall Road Ickford HP18 9JB Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 43184090002 | |||||
| SEYMOUR, Barry James | Amministratore | 9 Fort Street GU1 3TB Guildford Surrey | England | British | 1306660001 | |||||
| SMITH, John | Amministratore | Allenwood 161 London Road CM7 8PT Braintree Essex | British | 66391760001 | ||||||
| STEWARD, Charles David | Amministratore | 17 Windrush Close Bramley GU5 0BB Guildford Surrey | United Kingdom | British | 103109350002 | |||||
| TITLER, Alec | Amministratore | 11 Greenways Malt Hill TW20 9PA Egham Surrey | England | British | 48506930001 | |||||
| TITLER, Alec | Amministratore | 11 Greenways Malt Hill TW20 9PA Egham Surrey | England | British | 48506930001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IMPACT MARCOM LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avm Impact Ltd | 06 apr 2016 | 170 Windmill Road West TW16 7HB Sunbury-On-Thames Europe House Middlesex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
IMPACT MARCOM LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 24 mar 2015 Consegnato il 28 mar 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A supplemental deed to a debenture | Creato il 03 dic 2012 Consegnato il 10 dic 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 dic 2012 Consegnato il 08 dic 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 apr 2010 Consegnato il 11 mag 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed & floating charge | Creato il 03 mar 2008 Consegnato il 08 mar 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 ago 2007 Consegnato il 24 ago 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage pursuant to an order of court dated 16/7/91 | Creato il 26 set 1990 Consegnato il 18 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 12 capitol park pearce way gloucester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 06 ott 1981 Consegnato il 12 ott 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book detbs uncalled captial, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 02 giu 1980 Consegnato il 09 giu 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
IMPACT MARCOM LTD ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0