MICHCO 210 LIMITED
Panoramica
Nome della società | MICHCO 210 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01167328 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MICHCO 210 LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MICHCO 210 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Tempsford Hall SG19 2BD Sandy Bedfordshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MICHCO 210 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
T J BRENT LIMITED | 17 giu 1994 | 17 giu 1994 |
T.J. (BRENT) LIMITED | 19 apr 1974 | 19 apr 1974 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MICHCO 210 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per MICHCO 210 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 09 giu 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Bethan Melges il 08 dic 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anoop Kang come amministratore in data 21 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Thomas Lee Foreman come amministratore in data 21 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di David Neville Benson come amministratore in data 09 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Anoop Kang come amministratore in data 07 gen 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Bethan Melges come segretario in data 16 lug 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Armitage come amministratore in data 16 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Bethan Melges come amministratore in data 16 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Armitage come segretario in data 16 giu 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Hugh Edward Earle Raven come amministratore in data 16 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Haydn Jonathan Mursell come amministratore in data 16 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Matthew Armitage come amministratore in data 16 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MICHCO 210 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELGES, Bethan | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 199621880001 | |||||||
FOREMAN, Thomas Lee | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | Director | 221070030001 | ||||
MELGES, Bethan Anne Elizabeth | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | Chartered Secretary | 199583330002 | ||||
ABLETT, Allyson Mary Teresa | Segretario | High Leys Danesbower Lane, Blofield NR13 4LP Norwich Norfolk | British | 85809510002 | ||||||
ARMITAGE, Matthew | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | 193685910001 | |||||||
BROWNE, Robert Ernest Patrick | Segretario | White Lodge 9 Postwick Lane Brundall NR13 5RD Norwich Norfolk | British | Director Finance | 9060830002 | |||||
HAMILTON, Deborah Pamela | Segretario | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | 179700980001 | |||||||
HOWELL, Simon John | Segretario | NR14 8SZ Norwich Trowse Norfolk | British | 135677310001 | ||||||
MILLIGAN, Robert Colin | Segretario | 3 The Orchard Sandy Lane Brampford Speke EX5 5HW Exeter Devon | British | 2292480001 | ||||||
READ, Timothy Mark | Segretario | 3 Aspen Close EX2 5RZ Exeter Devon | British | Director | 46801260003 | |||||
WOODIER, Kenneth David | Segretario | The Lawns West Hill Road West Hill EX11 1UZ Ottery St Mary Devon | British | 57386960001 | ||||||
ALLATT, Jonathan | Amministratore | 33 Partition Street BS1 5QJ Bristol | United Kingdom | British | Director | 165674160002 | ||||
ARMITAGE, Matthew | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 192052540001 | ||||
ASKEW, Peter John | Amministratore | Lower Trewonnard Treneglos PL15 8UJ Launceston Cornwall | British | Chartered Civil Engineer | 38666840003 | |||||
BENSON, David Neville | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Group Financial Controller | 268612760001 | ||||
BIRDSEY, Robert Michael | Amministratore | 133 Brooklands Road M33 3GJ Sale Cheshire | England | British | Director | 74118900001 | ||||
BLEAKLEY, Douglas | Amministratore | 4 Roseneath Bramhall SK7 3LP Stockport Cheshire | England | British | Director | 60486120001 | ||||
BROWNE, Robert Ernest Patrick | Amministratore | White Lodge 9 Postwick Lane Brundall NR13 5RD Norwich Norfolk | British | Finance Director | 9060830002 | |||||
COOK, Christopher John | Amministratore | Westbury 27 West Avenue Pennsylvania EX4 4SD Exeter Devon | British | Operations Director | 56816080001 | |||||
DRUMMOND, Colin Irwin John Hamilton | Amministratore | Harpford Mill Langford Budville TA21 0EF Wellington Somerset | England | British | Chief Executive Viridor Ltd | 35692660002 | ||||
DUNN, Michael Edward | Amministratore | 5 Castelins Way Mulbarton NR14 8GH Norwich Norfolk | British | Finance Director | 78835300002 | |||||
FELLOWES-PRYNNE, Philip Windover | Amministratore | NR14 8SZ Norwich Trowse Norfolk | United Kingdom | British | Director | 179193160001 | ||||
FROUD, Michael John | Amministratore | Shortswood House Shortswood Cranbrook Road TN27 8DW Biddenden Kent | British | Company Director | 73378750001 | |||||
HARVEY, Peter George | Amministratore | Rockfield House Ash Road EX33 2EF Braunton Devon | United Kingdom | British | Utilities Director | 52473510003 | ||||
HAZLEWOOD, Mark Antony | Amministratore | NR14 8SZ Norwich Trowse Norfolk | United Kingdom | British | Director | 263679050001 | ||||
KANG, Anoop | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire | England | British | Director | 198683900001 | ||||
MACDIARMID, Donald William | Amministratore | NR14 8SZ Norwich Trowse Norfolk | United Kingdom | British | Director | 64347580002 | ||||
MURSELL, Haydn Jonathan | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 179634960001 | ||||
NICKS, Leslie Arthur | Amministratore | Crofton 116 Honiton Road EX1 3EW Exeter Devon | England | British | Company Director | 85603750001 | ||||
RAVEN, Hugh Edward Earle | Amministratore | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire United Kingdom | England | British | General Counsel | 287037230001 | ||||
READ, Timothy Mark | Amministratore | 3 Aspen Close EX2 5RZ Exeter Devon | British | Company Director | 46801260003 | |||||
STERRY, David William Edmund | Amministratore | 9 Eastgate Scotton DN21 3QP Gainsborough Lincolnshire | United Kingdom | British | Civil Engineer | 50971630001 | ||||
STEVENS, Matthew | Amministratore | NR14 8SZ Norwich Trowse Norfolk | United Kingdom | British | Director | 147841500002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MICHCO 210 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T J Brent Limited | 06 apr 2016 | SG19 2BD Sandy Tempsford Hall Bedfordshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MICHCO 210 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 15 dic 2000 Consegnato il 29 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 dic 2000 Consegnato il 29 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property under t/no cl 44542. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 dic 2000 Consegnato il 29 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property under t/no cl 119138. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 dic 2000 Consegnato il 29 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property under t/no CL71161. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 dic 2000 Consegnato il 29 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property under t/no cl 54525. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 15 dic 2000 Consegnato il 29 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold property under t/no cl 140350. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Single debenture | Creato il 23 gen 1987 Consegnato il 29 gen 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Tregrylls, barn park bodmin cornwall. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of deposit | Creato il 14 mag 1982 Consegnato il 18 mag 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Tregrylls barn park bodmin. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 02 feb 1982 Consegnato il 15 feb 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital fixed and moveable plant and machinery fixtures (including trade fixtures) implements. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of deposit | Creato il 28 mar 1981 Consegnato il 31 mar 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Plots 9, 13 and 15 homefield park bodmin cornwall. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0