MICHCO 210 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMICHCO 210 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01167328
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MICHCO 210 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MICHCO 210 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tempsford Hall
    SG19 2BD Sandy
    Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MICHCO 210 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    T J BRENT LIMITED17 giu 199417 giu 1994
    T.J. (BRENT) LIMITED19 apr 197419 apr 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di MICHCO 210 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per MICHCO 210 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 09 giu 2017

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium a/c cancelled 23/05/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Bethan Melges il 08 dic 2016

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Anoop Kang come amministratore in data 21 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Thomas Lee Foreman come amministratore in data 21 dic 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mag 2016

    Stato del capitale al 26 mag 2016

    • Capitale: GBP 5,153,200
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2015

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di David Neville Benson come amministratore in data 09 ott 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Anoop Kang come amministratore in data 07 gen 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Bethan Melges come segretario in data 16 lug 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Matthew Armitage come amministratore in data 16 lug 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Bethan Melges come amministratore in data 16 lug 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew Armitage come segretario in data 16 giu 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mag 2015

    Stato del capitale al 21 mag 2015

    • Capitale: GBP 5,153,200
    SH01

    Cessazione della carica di Hugh Edward Earle Raven come amministratore in data 16 apr 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Haydn Jonathan Mursell come amministratore in data 16 apr 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Matthew Armitage come amministratore in data 16 apr 2015

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MICHCO 210 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MELGES, Bethan
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Segretario
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    199621880001
    FOREMAN, Thomas Lee
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Amministratore
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector221070030001
    MELGES, Bethan Anne Elizabeth
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Amministratore
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    EnglandBritishChartered Secretary199583330002
    ABLETT, Allyson Mary Teresa
    High Leys
    Danesbower Lane, Blofield
    NR13 4LP Norwich
    Norfolk
    Segretario
    High Leys
    Danesbower Lane, Blofield
    NR13 4LP Norwich
    Norfolk
    British85809510002
    ARMITAGE, Matthew
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Segretario
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    193685910001
    BROWNE, Robert Ernest Patrick
    White Lodge 9 Postwick Lane
    Brundall
    NR13 5RD Norwich
    Norfolk
    Segretario
    White Lodge 9 Postwick Lane
    Brundall
    NR13 5RD Norwich
    Norfolk
    BritishDirector Finance9060830002
    HAMILTON, Deborah Pamela
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    179700980001
    HOWELL, Simon John
    NR14 8SZ Norwich
    Trowse
    Norfolk
    Segretario
    NR14 8SZ Norwich
    Trowse
    Norfolk
    British135677310001
    MILLIGAN, Robert Colin
    3 The Orchard
    Sandy Lane Brampford Speke
    EX5 5HW Exeter
    Devon
    Segretario
    3 The Orchard
    Sandy Lane Brampford Speke
    EX5 5HW Exeter
    Devon
    British2292480001
    READ, Timothy Mark
    3 Aspen Close
    EX2 5RZ Exeter
    Devon
    Segretario
    3 Aspen Close
    EX2 5RZ Exeter
    Devon
    BritishDirector46801260003
    WOODIER, Kenneth David
    The Lawns
    West Hill Road West Hill
    EX11 1UZ Ottery St Mary
    Devon
    Segretario
    The Lawns
    West Hill Road West Hill
    EX11 1UZ Ottery St Mary
    Devon
    British57386960001
    ALLATT, Jonathan
    33 Partition Street
    BS1 5QJ Bristol
    Amministratore
    33 Partition Street
    BS1 5QJ Bristol
    United KingdomBritishDirector165674160002
    ARMITAGE, Matthew
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Amministratore
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United KingdomBritishChartered Secretary192052540001
    ASKEW, Peter John
    Lower Trewonnard
    Treneglos
    PL15 8UJ Launceston
    Cornwall
    Amministratore
    Lower Trewonnard
    Treneglos
    PL15 8UJ Launceston
    Cornwall
    BritishChartered Civil Engineer38666840003
    BENSON, David Neville
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Financial Controller268612760001
    BIRDSEY, Robert Michael
    133 Brooklands Road
    M33 3GJ Sale
    Cheshire
    Amministratore
    133 Brooklands Road
    M33 3GJ Sale
    Cheshire
    EnglandBritishDirector74118900001
    BLEAKLEY, Douglas
    4 Roseneath
    Bramhall
    SK7 3LP Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    4 Roseneath
    Bramhall
    SK7 3LP Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector60486120001
    BROWNE, Robert Ernest Patrick
    White Lodge 9 Postwick Lane
    Brundall
    NR13 5RD Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    White Lodge 9 Postwick Lane
    Brundall
    NR13 5RD Norwich
    Norfolk
    BritishFinance Director9060830002
    COOK, Christopher John
    Westbury 27 West Avenue
    Pennsylvania
    EX4 4SD Exeter
    Devon
    Amministratore
    Westbury 27 West Avenue
    Pennsylvania
    EX4 4SD Exeter
    Devon
    BritishOperations Director56816080001
    DRUMMOND, Colin Irwin John Hamilton
    Harpford Mill
    Langford Budville
    TA21 0EF Wellington
    Somerset
    Amministratore
    Harpford Mill
    Langford Budville
    TA21 0EF Wellington
    Somerset
    EnglandBritishChief Executive Viridor Ltd35692660002
    DUNN, Michael Edward
    5 Castelins Way
    Mulbarton
    NR14 8GH Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    5 Castelins Way
    Mulbarton
    NR14 8GH Norwich
    Norfolk
    BritishFinance Director78835300002
    FELLOWES-PRYNNE, Philip Windover
    NR14 8SZ Norwich
    Trowse
    Norfolk
    Amministratore
    NR14 8SZ Norwich
    Trowse
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector179193160001
    FROUD, Michael John
    Shortswood House Shortswood
    Cranbrook Road
    TN27 8DW Biddenden
    Kent
    Amministratore
    Shortswood House Shortswood
    Cranbrook Road
    TN27 8DW Biddenden
    Kent
    BritishCompany Director73378750001
    HARVEY, Peter George
    Rockfield House
    Ash Road
    EX33 2EF Braunton
    Devon
    Amministratore
    Rockfield House
    Ash Road
    EX33 2EF Braunton
    Devon
    United KingdomBritishUtilities Director52473510003
    HAZLEWOOD, Mark Antony
    NR14 8SZ Norwich
    Trowse
    Norfolk
    Amministratore
    NR14 8SZ Norwich
    Trowse
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector263679050001
    KANG, Anoop
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    Amministratore
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector198683900001
    MACDIARMID, Donald William
    NR14 8SZ Norwich
    Trowse
    Norfolk
    Amministratore
    NR14 8SZ Norwich
    Trowse
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector64347580002
    MURSELL, Haydn Jonathan
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director179634960001
    NICKS, Leslie Arthur
    Crofton 116 Honiton Road
    EX1 3EW Exeter
    Devon
    Amministratore
    Crofton 116 Honiton Road
    EX1 3EW Exeter
    Devon
    EnglandBritishCompany Director85603750001
    RAVEN, Hugh Edward Earle
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishGeneral Counsel287037230001
    READ, Timothy Mark
    3 Aspen Close
    EX2 5RZ Exeter
    Devon
    Amministratore
    3 Aspen Close
    EX2 5RZ Exeter
    Devon
    BritishCompany Director46801260003
    STERRY, David William Edmund
    9 Eastgate
    Scotton
    DN21 3QP Gainsborough
    Lincolnshire
    Amministratore
    9 Eastgate
    Scotton
    DN21 3QP Gainsborough
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCivil Engineer50971630001
    STEVENS, Matthew
    NR14 8SZ Norwich
    Trowse
    Norfolk
    Amministratore
    NR14 8SZ Norwich
    Trowse
    Norfolk
    United KingdomBritishDirector147841500002

    Chi sono le persone con controllo significativo di MICHCO 210 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    England
    06 apr 2016
    SG19 2BD Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom
    Numero di registrazione4039121
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    MICHCO 210 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 15 dic 2000
    Consegnato il 29 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 dic 2000
    Consegnato il 29 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property under t/no cl 44542.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 dic 2000
    Consegnato il 29 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property under t/no cl 119138.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 dic 2000
    Consegnato il 29 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property under t/no CL71161.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 dic 2000
    Consegnato il 29 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property under t/no cl 54525.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 dic 2000
    Consegnato il 29 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations due or to become due from the company (formerly known as t j brent limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property under t/no cl 140350.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 23 gen 1987
    Consegnato il 29 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Tregrylls, barn park bodmin cornwall. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 06 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creato il 14 mag 1982
    Consegnato il 18 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Tregrylls barn park bodmin.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 18 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 02 feb 1982
    Consegnato il 15 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital fixed and moveable plant and machinery fixtures (including trade fixtures) implements.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 15 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    Memorandum of deposit
    Creato il 28 mar 1981
    Consegnato il 31 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plots 9, 13 and 15 homefield park bodmin cornwall.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Ireland
    Transazioni
    • 31 mar 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0