VILTON CARS LIMITED

VILTON CARS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVILTON CARS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01167862
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VILTON CARS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova VILTON CARS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Waters Retail
    Lyon Way
    AL4 0LQ St Albans
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VILTON CARS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    J.P. VILTON (CARS) LIMITED24 apr 197424 apr 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di VILTON CARS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per VILTON CARS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 nov 2010

    Stato del capitale al 09 nov 2010

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Mr John Robert Hannah il 17 set 2010

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Darren Payne come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Robert Hannah il 17 set 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    2 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    2 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di VILTON CARS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HANNAH, John Robert
    Lyon Way
    AL4 0LQ St Albans
    Waters Retail
    Hertfordshire
    Segretario
    Lyon Way
    AL4 0LQ St Albans
    Waters Retail
    Hertfordshire
    BritishDirector138883780001
    HANNAH, John Robert
    Lyon Way
    AL4 0LQ St Albans
    Waters Retail
    Hertfordshire
    Amministratore
    Lyon Way
    AL4 0LQ St Albans
    Waters Retail
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector138883780001
    COOK, Roger Daniel
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    BritishCompany Director141282680001
    VARNEY, Peter Reginald
    Thornemill House
    Ninfield Road Lunsford Cross
    TN39 5JR Bexhill On Sea
    East Sussex
    Segretario
    Thornemill House
    Ninfield Road Lunsford Cross
    TN39 5JR Bexhill On Sea
    East Sussex
    British68629570001
    VILTON, Aileen
    4 Langton Court The Ridgeway
    EN2 8PD Enfield
    Middlesex
    Segretario
    4 Langton Court The Ridgeway
    EN2 8PD Enfield
    Middlesex
    British17532160002
    COMBER, David Cyril
    45 Mill Road
    Sharnbrook
    MK44 1NX Bedford
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    45 Mill Road
    Sharnbrook
    MK44 1NX Bedford
    Bedfordshire
    England
    BritishVehicle Aftersales Manager60898610001
    COOK, Roger Daniel
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    Bell House
    29 Church Road Totternhoe
    LU6 1RE Dunstable
    Bedfordshire
    BritishCompany Director141282680001
    DE TURRIS, Audrey
    Ash Place Ashwells Farm
    Chesham Lane
    HP8 4AS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ash Place Ashwells Farm
    Chesham Lane
    HP8 4AS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishDirector17532170002
    DE TURRIS, Frederico
    Ash Place Ashwells Farm
    Chesham Lane
    HP8 4AS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ash Place Ashwells Farm
    Chesham Lane
    HP8 4AS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    ItalianMotor Trader3888530002
    HESLOP, David Christopher
    Burford Lodge
    Church Road
    TN6 1BL Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    Burford Lodge
    Church Road
    TN6 1BL Crowborough
    East Sussex
    United KingdomBritishDirector18365540002
    ISHIKAWA, Masashi
    2 Julians Way
    TN13 2PE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    2 Julians Way
    TN13 2PE Sevenoaks
    Kent
    JapaneseDirector74123760005
    KATANO, Tomio
    7 Arran Mews
    W5 3PY London
    Amministratore
    7 Arran Mews
    W5 3PY London
    JapaneseDirector103307300002
    MURAI, Kenji
    Oakhill Road
    TN13 1AB Sevenoaks
    3 Birch Place
    Kent
    Amministratore
    Oakhill Road
    TN13 1AB Sevenoaks
    3 Birch Place
    Kent
    JapaneseDirector117074780002
    OFSTEDAHL, Darryl Bryan
    37 High Road
    Shillington
    SG5 3LL Hitchin
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    37 High Road
    Shillington
    SG5 3LL Hitchin
    Hertfordshire
    England
    CanadianAccountant60898890001
    PAYNE, Darren
    Ledborough Gate
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Wakehurst Lodge
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ledborough Gate
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Wakehurst Lodge
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChief Operating Officer138883790002
    SHIBATA, Ichiro
    17 The Dene
    TN13 1PB Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    17 The Dene
    TN13 1PB Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector103307260001
    SPURR, David Anthony George
    40 Moorlands
    AL7 4PP Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    40 Moorlands
    AL7 4PP Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishCompany Director5200730001
    VILTON, Aileen
    4 Langton Court The Ridgeway
    EN2 8PD Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    4 Langton Court The Ridgeway
    EN2 8PD Enfield
    Middlesex
    BritishDirector17532160002
    VILTON, John Philip
    Carrigans
    16 New Road
    AL6 0AG Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Carrigans
    16 New Road
    AL6 0AG Welwyn
    Hertfordshire
    BritishMotor Trader17532180003

    VILTON CARS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 feb 1994
    Consegnato il 07 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 19 nov 1992
    Consegnato il 24 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All interest in any used cars to which h m customs & excise notice no 711 & unused vehicles (for full details refer to doc M395 ref M13).
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited
    Transazioni
    • 24 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 giu 1989
    Consegnato il 27 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 mar 1988
    Consegnato il 23 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 19 ott 1987
    Consegnato il 22 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and all other moneys due or to become due under the terms of a consignment argeement dated 19.10.87
    Brevi particolari
    All the chargor's interest in any vehicle delivered to it under the terms of the said consignment agreement and any mones received.
    Persone aventi diritto
    • Psa Wholesale Limited.
    Transazioni
    • 22 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 14 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 nov 1982
    Consegnato il 07 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property lying at the rear of 32,34 36,38,40,42 and 44 cannon hill,southgate l/b of enfield together with the garages buildings offices and workshops. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1982Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0