DATONG LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDATONG LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01169448
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DATONG LIMITED?

    • fabbricazione di apparecchiature di comunicazione diverse da quelle telegrafiche e telefoniche (26309) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova DATONG LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 3 Cliffe Park Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DATONG LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DATONG PLC11 ott 200711 ott 2007
    DATONG ELECTRONICS PLC08 set 200508 set 2005
    DATONG ELECTRONICS LIMITED08 mag 197408 mag 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di DATONG LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per DATONG LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Low Hall Business Park Low Hall Road Horsforth Leeds West Yorkshire LS18 4EG a Unit 3 Cliffe Park Bruntcliffe Road Morley Leeds LS27 0RY in data 02 nov 2022

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 set 2021 al 29 set 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Gavin Newport come amministratore in data 26 mar 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Roland Barzegar come amministratore in data 12 mar 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael John Howarth come amministratore in data 30 nov 2020

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 011694480009, creata il 23 nov 2020

    44 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 011694480008, creata il 23 nov 2020

    43 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 011694480007, creata il 06 lug 2020

    57 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 011694480005 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 011694480006 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di David Anderson come amministratore in data 21 apr 2020

    1 pagineTM01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 4

    2 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Michael John Howarth come amministratore in data 22 gen 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Roland Barzegar come amministratore in data 22 gen 2020

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DATONG LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEWPORT, Gavin
    Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Unit 3 Cliffe Park
    England
    Amministratore
    Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Unit 3 Cliffe Park
    England
    EnglandBritish281339300001
    AYRES, Stephen George
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    British116077650002
    COOKE, James
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    Segretario
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    British63463180003
    DAVIES-RATCLIFF, Grant Ashley
    18 Priory Street
    BN7 1HH Lewes
    East Sussex
    Segretario
    18 Priory Street
    BN7 1HH Lewes
    East Sussex
    British68762490001
    GLASS, Colin
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    Segretario
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    British17429220001
    HARRINGTON, Christopher James Malcolm
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    Segretario
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    British61880310003
    MILLER, David
    23 Tillotson Close
    RH10 7WQ Maidenbower
    West Sussex
    Segretario
    23 Tillotson Close
    RH10 7WQ Maidenbower
    West Sussex
    British88052290001
    THOMAS, Kerry Anne Abigail
    65 St Martins Lane
    Langley Park
    BR3 3XU Beckenham
    Kent
    Segretario
    65 St Martins Lane
    Langley Park
    BR3 3XU Beckenham
    Kent
    British61457700003
    TONG, Gillian Kathleen
    6 Arncliffe Road
    LS16 5JE Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    6 Arncliffe Road
    LS16 5JE Leeds
    West Yorkshire
    British3020110001
    ANDERSON, David
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Northern IrelandBritish90445740004
    ASHLEY, Grant
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    UsaUsa113819040002
    AYRES, Stephen George
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish116077650002
    BARZEGAR, Roland
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish266377570001
    BLOOD, Dean
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish139902390001
    BREARLEY, Richard Gregg
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    UkBritish288217710001
    COHEN, Robert Victor
    12a Ellington Road
    Muswell Hill
    N10 3DG London
    Amministratore
    12a Ellington Road
    Muswell Hill
    N10 3DG London
    EnglandBritish63085200002
    COOK, Mark Andrew
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish165905790001
    COOKE, James
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    Amministratore
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    EnglandBritish63463180003
    COOKE, James
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    Amministratore
    Flat 705 City View House
    463 Bethnal Green Road
    E2 9QY London
    EnglandBritish63463180003
    GLASS, Colin
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    EnglandBritish17429220001
    HALL, Brian Leslie
    40 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9BQ Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    40 Leeds Road
    Bramhope
    LS16 9BQ Leeds
    Yorkshire
    British34547780001
    HARRINGTON, Christopher James Malcolm
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish61880310003
    HARRINGTON, Christopher James Malcolm
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    31 Marston Way
    LS22 6XZ Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish61880310003
    HARRIS, Jocelin Montague St John
    21 Pembroke Square
    W8 6PB London
    Amministratore
    21 Pembroke Square
    W8 6PB London
    United KingdomBritish3078360002
    HOHLER, Frederick Christopher Gerald
    The Court Lodge
    TN15 7PG Stansted
    Kent
    Amministratore
    The Court Lodge
    TN15 7PG Stansted
    Kent
    United KingdomBritish4771470001
    HOWARTH, Michael John
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish280942220001
    HUDSON, Nicholas John
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish202126040001
    JONES, Teresa Mary
    Dale End House Crayke Road
    Brandsby
    YO6 4RP York
    Yorkshire
    Amministratore
    Dale End House Crayke Road
    Brandsby
    YO6 4RP York
    Yorkshire
    British53825740001
    KIRTLAND, John Philip
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish86087080001
    LEVER, Paul Ronald Scott
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish106971650001
    ROUGHTON, Neil
    39 Abbeydale Oval
    LS5 3RF Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    39 Abbeydale Oval
    LS5 3RF Leeds
    Yorkshire
    British64915580001
    SHIVTIEL, Dar
    4 St James Terrace
    Horsforth
    LS18 5QT Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 St James Terrace
    Horsforth
    LS18 5QT Leeds
    West Yorkshire
    British53494920001
    SMITH, Brian Mcqueen
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Low Hall Business Park Low
    Hall Road Horsforth
    LS18 4EG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish62283490005
    SMITH, Stuart Charles James
    12 Hilton Grange
    Bramhope
    LS16 9LE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Hilton Grange
    Bramhope
    LS16 9LE Leeds
    West Yorkshire
    British57784910002
    TONG, David Arthur
    6 Arncliffe Road
    LS16 5JE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Arncliffe Road
    LS16 5JE Leeds
    West Yorkshire
    British17429210001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DATONG LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr David Anderson
    Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Unit 3 Cliffe Park
    England
    01 apr 2017
    Bruntcliffe Road
    Morley
    LS27 0RY Leeds
    Unit 3 Cliffe Park
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Northern Ireland
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DATONG LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 nov 2020
    Consegnato il 14 dic 2020
    In corso
    Breve descrizione
    Nil.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • NI Growth Loan Fund LP
    Transazioni
    • 14 dic 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 23 nov 2020
    Consegnato il 25 nov 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Yfm Private Equity Limited
    Transazioni
    • 25 nov 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 lug 2020
    Consegnato il 08 lug 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 21 ott 2013
    Consegnato il 08 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited T/a Danske Bank
    Transazioni
    • 08 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 ott 2013
    Consegnato il 08 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited T/a Danske Bank
    Transazioni
    • 08 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 nov 2007
    Consegnato il 21 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2020Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 21 apr 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 26 gen 2000
    Consegnato il 11 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east side of clayton wood close west park leeds west yorkshire t/n YWE43029.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 ago 1999
    Consegnato il 26 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 ott 1998
    Consegnato il 03 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0