CROWNFLIGHT LIMITED

CROWNFLIGHT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCROWNFLIGHT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01169725
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CROWNFLIGHT LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CROWNFLIGHT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o WELL
    Merchants Warehouse
    Castle Street
    M3 4LZ Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CROWNFLIGHT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    E.R. PEAR LIMITED10 mag 197410 mag 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di CROWNFLIGHT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al11 gen 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CROWNFLIGHT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CROWNFLIGHT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Angel Square Manchester M60 0AG a C/O Well Merchants Warehouse Castle Street Manchester M3 4LZ in data 14 set 2015

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ago 2015

    Stato del capitale al 05 ago 2015

    • Capitale: GBP 298
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a C/O Tlt Llp One Redcliff Street Bristol BS1 6TP

    1 pagineAD02

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 11 gen 2015 al 30 giu 2015

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Caroline Jane Sellers come segretario in data 30 set 2014

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 11/08/2014
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 ago 2014

    Stato del capitale al 04 ago 2014

    • Capitale: GBP 298
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio modificato redatto al 11 gen 2014

    5 pagineAAMD

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Smith il 31 lug 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Branson Nuttall il 31 lug 2013

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2013

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES in data 03 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2011

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Smith il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CROWNFLIGHT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NUTTALL, John Branson
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    EnglandBritish44967060003
    SMITH, Anthony John
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    Amministratore
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    England
    EnglandBritish137558680002
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Segretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Segretario
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    MOULT, Stephen Phillip
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    British45585030001
    PEAR, Doria
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    Segretario
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    British24996800001
    SELLERS, Caroline Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    150071860001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Segretario
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375350001
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    CROFT, Kenneth Michael
    152 Melton Road
    Stanton On The Wolds Keyworth
    NG12 5BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    152 Melton Road
    Stanton On The Wolds Keyworth
    NG12 5BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    British5859440001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Amministratore
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    MARKS, Peter Vincent
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Barn Low House Farm
    Otley Road Eldwick
    BD16 3AZ Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish87486470001
    MOULT, Stephen Phillip
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Clearview 5 Sutton Spring Wood
    Calow
    S44 5XF Chesterfield
    Derbyshire
    British45585030001
    NUTTALL, John Branson
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Post Office Whitchurch Road
    Broomhall
    CW5 8BZ Nantwich
    Cheshire
    British44967060001
    PEAR, Aubrey Edmund
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    Amministratore
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    British25080400001
    PEAR, Doria
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    Amministratore
    Barncroft
    Church Lane
    NG13 0JD Plungar
    Notts
    British24996800001
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Amministratore
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritish182256460001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    United Co-Operatives Ltd
    Sandbrook House Sandbrook Way
    Rochdale
    Lancashire
    110375270001

    CROWNFLIGHT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 12 lug 1994
    Consegnato il 13 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    414 broxtowe lane aspley nottingham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 gen 1991
    Consegnato il 22 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 02 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 giu 1987
    Consegnato il 10 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 29 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 05 nov 1980
    Consegnato il 26 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 414 broxtowe lane, nottingham, nottinghamshire nt 114158.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0