MMSD (LSG) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMMSD (LSG) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01170357
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MMSD (LSG) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MMSD (LSG) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Reebok Stadium
    Burnden Way Lostock
    BL6 6JW Bolton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MMSD (LSG) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GROSVENOR STUDIOS LIMITED05 ott 199405 ott 1994
    HEDGES WRIGHT GROUP LIMITED03 feb 198803 feb 1988
    HEDGES WRIGHT (THAMESDOWN) LIMITED15 mag 197415 mag 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di MMSD (LSG) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per MMSD (LSG) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2011

    Stato del capitale al 04 nov 2011

    • Capitale: GBP 37,480
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Paula Marie Mulligan il 01 ott 2010

    2 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Philip Andrew Gartside il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2009

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2008

    7 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2007

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2006

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2005

    7 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2004

    8 pagineAA

    legacy

    6 pagine363s

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2003

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MMSD (LSG) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MULLIGAN, Paula Marie
    Burnden Way
    Lostock
    BL6 6JW Bolton
    Reebok Stadium
    United Kingdom
    Segretario
    Burnden Way
    Lostock
    BL6 6JW Bolton
    Reebok Stadium
    United Kingdom
    BritishAccountant53268570003
    GARTSIDE, Philip Andrew
    Burnden Way
    Lostock
    BL6 6JW Bolton
    Reebok Stadium
    United Kingdom
    Amministratore
    Burnden Way
    Lostock
    BL6 6JW Bolton
    Reebok Stadium
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector11273920001
    BALL, Susan Elisabeth
    25 Silver Birch Drive
    Houndsfield
    B47 5RB Wythall
    Birmingham
    Segretario
    25 Silver Birch Drive
    Houndsfield
    B47 5RB Wythall
    Birmingham
    British12407250001
    DALZELL, John Gordon
    2 Leycester Road
    WA16 8QS Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    2 Leycester Road
    WA16 8QS Knutsford
    Cheshire
    British93534470001
    ENTWISTLE, Len
    Sniddle Holme Farm
    Bank Fold
    BB3 3QG Darwen
    Lancashire
    Segretario
    Sniddle Holme Farm
    Bank Fold
    BB3 3QG Darwen
    Lancashire
    British62063680001
    OVALSEC LIMITED
    30 Queen Charlotte Street
    BS99 7QQ Bristol
    Segretario
    30 Queen Charlotte Street
    BS99 7QQ Bristol
    56728540001
    ANGRAVE, Leon Francis
    7 Hunters Walk
    Witherley
    CV9 3SU Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    7 Hunters Walk
    Witherley
    CV9 3SU Atherstone
    Warwickshire
    BritishChartered Accountant1558740001
    BALL, Susan Elisabeth
    25 Silver Birch Drive
    Houndsfield
    B47 5RB Wythall
    Birmingham
    Amministratore
    25 Silver Birch Drive
    Houndsfield
    B47 5RB Wythall
    Birmingham
    BritishChartered Accountant12407250001
    CHILDS, Robin Sheldon Colin
    36 Willow Lane
    OX14 4EG Milton
    Oxfordshire
    Amministratore
    36 Willow Lane
    OX14 4EG Milton
    Oxfordshire
    BritishCreative Services Director44027130001
    ILES, Edward George
    67 Delbush Avenue
    Sandhills
    OX3 8HA Oxford
    Amministratore
    67 Delbush Avenue
    Sandhills
    OX3 8HA Oxford
    BritishProduction Director37485830001
    MCKENNA, Paul John
    91 Beech Drive
    NN13 6JG Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    91 Beech Drive
    NN13 6JG Brackley
    Northamptonshire
    BritishFinance Director31006380003
    SURGUY, James Edward
    22 Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    Amministratore
    22 Piercing Hill
    Theydon Bois
    CM16 7JW Epping
    Essex
    United KingdomBritishDirector30193650001
    WILLIAMS, David Jeffreys
    Surville
    La Ruette Pinel St Helier
    JE2 3HF Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Surville
    La Ruette Pinel St Helier
    JE2 3HF Jersey
    Channel Islands
    JerseyBritishCompany Director141743090001
    WOODBRIDGE, Peter John
    11 Home Close
    Wootton
    OX13 6DB Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    11 Home Close
    Wootton
    OX13 6DB Abingdon
    Oxfordshire
    BritishOperations Director37485980001

    MMSD (LSG) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 26 mag 1993
    Consegnato il 02 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 11, manderville courtyard, 142 battersea park road, wandsworth, london SW11 t/no. TGL15569 and all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Single debenture
    Creato il 30 apr 1993
    Consegnato il 12 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement
    Creato il 26 set 1990
    Consegnato il 05 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £39,311-09 due from the company to company to close brothers limied pursuant to the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to all sums payable under the insurance (plsease see fform 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 05 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 set 1989
    Consegnato il 26 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Grosvenor studios isys house, county trading estate harrow road, watlington roadcornley, oxfordshire t/n on 115730.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 giu 1989
    Consegnato il 04 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 5 & 6 isis trading estate stratton road, swindon wilts.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 mar 1988
    Consegnato il 18 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 11, 142, battersea park rd, l/b of battersea part t/no 359084.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 gen 1986
    Consegnato il 13 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Uit 7, isis trading estate swindon, wiltshire also known as unit 7, stralton trading estate swinson.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 feb 1981
    Consegnato il 06 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H unit 8 isis trading estate stratton road swindon wiltshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 29 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 apr 1978
    Consegnato il 28 apr 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See doc ref M15 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank Limited
    Transazioni
    • 28 apr 1978Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0