DEN HARTOGH UK LIMITED

DEN HARTOGH UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDEN HARTOGH UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01171859
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DEN HARTOGH UK LIMITED?

    • Altre attività di supporto ai trasporti (52290) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Phoenix House
    Surtees Business Park
    TS18 3HR Stockton-On-Tees
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DEN HARTOGH LOGISTICS LIMITED24 apr 201724 apr 2017
    INTERBULK (TANKCONTAINERS) LIMITED02 feb 200902 feb 2009
    UNITED TRANSPORT TANK CONTAINERS LIMITED26 giu 200026 giu 2000
    INITIAL TANKCONTAINERS LTD31 mar 199831 mar 1998
    UNITED TRANSPORT TANKCONTAINERS LIMITED03 mag 198903 mag 1989
    BAILEE FREIGHT SERVICES LIMITED 28 mag 197428 mag 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 12 mar 2020

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    24 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Victoria House Pearson Court Pearson Way Teesdale Stockton Cleveland TS17 6PT a Phoenix House Surtees Business Park Stockton-on-Tees TS18 3HR in data 06 mar 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 dic 2018

    • Capitale: GBP 0.01
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    28 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    31 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 24 apr 2017

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2016 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Klaas Pieter Den Hartogh il 10 mar 2016

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Abraham Cornelis Paape come amministratore in data 10 mar 2016

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PAAPE, Abraham Cornelius
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Den Hartogh Uk Limited
    South Humberside
    England
    Amministratore
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Den Hartogh Uk Limited
    South Humberside
    England
    NetherlandsDutch205995900001
    PIETER DEN HARTOGH, Klaas
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Den Hartogh Uk Limited
    South Humberside
    England
    Amministratore
    Eastfield Road
    South Killingholme
    DN40 3DQ Immingham
    Den Hartogh Uk Limited
    South Humberside
    England
    NetherlandsDutch205990060001
    BROWN, Gareth Trevor
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    Segretario
    19 Holbrook School Lane
    RH12 5PP Horsham
    West Sussex
    British15885460002
    CUNNINGHAM, Scott Thomas
    Portland Park
    ML3 7JY Hamilton
    Athol Bank
    Lanarkshire
    Scotland
    Segretario
    Portland Park
    ML3 7JY Hamilton
    Athol Bank
    Lanarkshire
    Scotland
    British111223770001
    MOLENAAR, Roelof
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    Segretario
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    Dutch70774490001
    SMITH, Diana Jane
    Gedempte Zalmhaven 173
    FOREIGN 3011 Bt Rotterdam
    The Netherlands
    Segretario
    Gedempte Zalmhaven 173
    FOREIGN 3011 Bt Rotterdam
    The Netherlands
    British75147230002
    PLANT NOMINEES LIMITED
    Legal Dept
    Rentokil Initial Uk Ltd
    RH19 1DY Garland Road, East Grinstead
    West Sussex
    Segretario
    Legal Dept
    Rentokil Initial Uk Ltd
    RH19 1DY Garland Road, East Grinstead
    West Sussex
    28712520027
    BOS, Wouter
    PO BOX 525
    3300 AM Dordrecht
    The Netherlands
    Amministratore
    PO BOX 525
    3300 AM Dordrecht
    The Netherlands
    Dutch42169500001
    CUNNINGHAM, Scott Thomas
    Pearson Court
    Pearson Way
    TS17 6PT Stockton-On-Tees
    Victoria House
    Cleveland
    Amministratore
    Pearson Court
    Pearson Way
    TS17 6PT Stockton-On-Tees
    Victoria House
    Cleveland
    ScotlandBritish111223770001
    KULLBERG, Loek Frans Jacob
    Victoria House
    Pearson Court Pearson Way
    TS17 6PT Teesdale Stockton
    Cleveland
    Amministratore
    Victoria House
    Pearson Court Pearson Way
    TS17 6PT Teesdale Stockton
    Cleveland
    NetherlandsDutch184998400002
    MOLENAAR, Roelof
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    Amministratore
    Rochussenstraat 45a
    FOREIGN Rotterdam
    3015ec
    Netherlands
    Dutch70774490001
    NOEL, Michel
    Bergschenhoek
    Jf Kennedylaan 10
    2661jh
    Netherlands
    Amministratore
    Bergschenhoek
    Jf Kennedylaan 10
    2661jh
    Netherlands
    British129561360001
    PATTERSON, Ernest
    1 Hillside Road
    Penn
    HP10 8JJ High Wycombe
    Amministratore
    1 Hillside Road
    Penn
    HP10 8JJ High Wycombe
    British83721290001
    PEARCH, Nicholas Keith
    Bradfield Manor
    Hullavington
    SN14 6EU Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Bradfield Manor
    Hullavington
    SN14 6EU Chippenham
    Wiltshire
    British69879060001
    PRATT, Keith
    27 Whernside Ingleby
    Barwick
    TS17 0QF Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    27 Whernside Ingleby
    Barwick
    TS17 0QF Stockton On Tees
    Cleveland
    British113151880001
    RICHARDS, Timothy John
    Close End Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Close End Farm
    Ilmer
    HP27 9RD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish,Canadian71050390002
    SELESKI, Bernardus Kendrikus
    PO BOX 11094
    3004 EB Rotterdam
    The Netherlands
    Amministratore
    PO BOX 11094
    3004 EB Rotterdam
    The Netherlands
    Dutch33055810001
    SMITH, David Alan
    2 Thirsk Road
    Stokesley
    TS9 5BW Middlesbrough
    Cleveland
    Amministratore
    2 Thirsk Road
    Stokesley
    TS9 5BW Middlesbrough
    Cleveland
    British33055830002
    SMITH, Diana Jane
    Gedempte Zalmhaven 173
    FOREIGN 3011 Bt Rotterdam
    The Netherlands
    Amministratore
    Gedempte Zalmhaven 173
    FOREIGN 3011 Bt Rotterdam
    The Netherlands
    British75147230002
    VAN DER WARDT, Harald Christiaan
    Rotterdam
    3055 Be
    Van Hoytemalaan 10
    Netherlands
    Amministratore
    Rotterdam
    3055 Be
    Van Hoytemalaan 10
    Netherlands
    NetherlandsDutch136444450001
    WILDE, James Christie Falconer
    38 Box Ridge Avenue
    CR8 3AQ Purley
    Surrey
    Amministratore
    38 Box Ridge Avenue
    CR8 3AQ Purley
    Surrey
    EnglandBritish36882290001
    WILSON, Alan
    20 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    Amministratore
    20 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish147755040001
    WISE, Keith
    Lothlorien House
    19 Southcote Way Penn
    HP10 8JG High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lothlorien House
    19 Southcote Way Penn
    HP10 8JG High Wycombe
    Buckinghamshire
    British94707660001
    WISSEN, Jacobus Cornelis Josef Van
    Wielsingel 46
    Vj Dud Beijerland
    3261
    Holland
    Amministratore
    Wielsingel 46
    Vj Dud Beijerland
    3261
    Holland
    NetherlandsDutch71933000002

    Chi sono le persone con controllo significativo di DEN HARTOGH UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Klaas Pieter Den Hartogh
    6 Willingestraat
    3008PB Rotterdam
    6
    Netherlands
    06 apr 2016
    6 Willingestraat
    3008PB Rotterdam
    6
    Netherlands
    No
    Nazionalità: Dutch
    Paese di residenza: Netherlands
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DEN HARTOGH UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 apr 2007
    Consegnato il 18 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company or other obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 18 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 feb 2006
    Consegnato il 08 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company or other obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Secured Parties
    Transazioni
    • 08 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 nov 2002
    Consegnato il 02 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The containers and by way of first assignment the assigned property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 nov 2002
    Consegnato il 02 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 giu 2000
    Consegnato il 13 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and for Each of the Agent, the Banks, the Hedging Banks and the Investors (As Defined)
    Transazioni
    • 13 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 giu 1985
    Consegnato il 12 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge on all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts f/h property k/a land at stokesley approx. 3 acres at station road and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 mar 1985
    Consegnato il 13 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises at station road stokesley north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0