CONVOTHERM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCONVOTHERM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01172730
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CONVOTHERM LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CONVOTHERM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CONVOTHERM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    REGETHERMIC U.K. LIMITED05 giu 197405 giu 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di CONVOTHERM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per CONVOTHERM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    5 pagineDS01

    Stato del capitale al 12 ago 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    3 pagineSH20

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Michael James Kachmer come amministratore in data 03 apr 2013

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Graham Philip Brisley Veal come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Blades come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Prima Secretary Limited il 29 mar 2010

    2 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Thomas Doerr come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Adrian David Gray come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di CONVOTHERM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Segretario
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    CLAYTON, Gilbert Falkingham
    93 High Street
    TW12 1NH Hampton Hill
    Middlesex
    Segretario
    93 High Street
    TW12 1NH Hampton Hill
    Middlesex
    British89624880001
    DOBBS, Richard Noel
    19 Haygarth Place
    SW19 5BX London
    Segretario
    19 Haygarth Place
    SW19 5BX London
    British8685710001
    GEORGESON, Ian Barry
    40a Danehurst Street
    SW6 6SD London
    Segretario
    40a Danehurst Street
    SW6 6SD London
    British25947220001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Segretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    WARD, Elaine Florence Maud
    68 Abbey Road
    Westbury On Ttrym
    BS9 3QR Bristol
    Segretario
    68 Abbey Road
    Westbury On Ttrym
    BS9 3QR Bristol
    British51001180001
    WEBSTER, Randall Lewis
    St Helier 29 Wideatts Road
    BS27 3AT Cheddar
    Somerset
    Segretario
    St Helier 29 Wideatts Road
    BS27 3AT Cheddar
    Somerset
    British46406420001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Oakwoods
    Sawpit Lane
    PE28 5QS Hamerton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Oakwoods
    Sawpit Lane
    PE28 5QS Hamerton
    Cambridgeshire
    British79449700001
    CLAYTON, Gilbert Falkingham
    93 High Street
    TW12 1NH Hampton Hill
    Middlesex
    Amministratore
    93 High Street
    TW12 1NH Hampton Hill
    Middlesex
    British89624880001
    DIBBEN, John Mervyn Farquhar
    Morley Farm
    Eastcourt
    SN16 9HN Malmesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Morley Farm
    Eastcourt
    SN16 9HN Malmesbury
    Wiltshire
    British10193310003
    DITTMAN, Frank
    Farbergasse 33
    82362 Weilheim
    Germany
    Amministratore
    Farbergasse 33
    82362 Weilheim
    Germany
    German52478690001
    DOBBS, Richard Noel
    19 Haygarth Place
    SW19 5BX London
    Amministratore
    19 Haygarth Place
    SW19 5BX London
    British8685710001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    HERRMANN, Harvey Stuart
    27 Leyborne Park
    Kew
    TW9 3HB Richmond
    Surrey
    Amministratore
    27 Leyborne Park
    Kew
    TW9 3HB Richmond
    Surrey
    EnglandBritish23164010001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    LEE, Paul Allan
    Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    4
    Berkshire
    Amministratore
    Clifton Park Road
    Caversham
    RG4 7PD Reading
    4
    Berkshire
    EnglandBritish70564410001
    LOUGHTON, Stephen Andrew
    Rivendell
    Middleton Road
    GU15 3TU Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Rivendell
    Middleton Road
    GU15 3TU Camberley
    Surrey
    EnglandBritish30589020001
    LOWERY, Robert Johnson
    1 Devonshire Gardens
    Grove Park Chiswick
    W4 3TW London
    Amministratore
    1 Devonshire Gardens
    Grove Park Chiswick
    W4 3TW London
    British10629590001
    ROLT, Jeremy Charles
    4 Sycamore Close
    St Ippolyts
    SG4 7SN Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Sycamore Close
    St Ippolyts
    SG4 7SN Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish35716980001
    SCHWARZBACKER, Werner
    Kerschgarten 3
    82436 Untereglfing
    Germany
    Amministratore
    Kerschgarten 3
    82436 Untereglfing
    Germany
    German52478970001
    TONER, Robert Anthony
    29 Lamb Close
    WD25 0TB Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    29 Lamb Close
    WD25 0TB Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish70516300002
    WEBSTER, Randall Lewis
    St Helier 29 Wideatts Road
    BS27 3AT Cheddar
    Somerset
    Amministratore
    St Helier 29 Wideatts Road
    BS27 3AT Cheddar
    Somerset
    British46406420001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    Amministratore
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006

    CONVOTHERM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of furtherproperties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 19 apr 1995
    Consegnato il 21 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 gen 1995
    Consegnato il 18 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the rent deposit deed
    Brevi particolari
    Rent deposit monies in the sum of £5,000 and interest accrued thereon referred to in the rent deposit deed dated 9 january 1995.
    Persone aventi diritto
    • Tilbury Douglas Construction Limited
    Transazioni
    • 18 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 05 gen 1988
    Consegnato il 22 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all propety and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 feb 1984
    Consegnato il 08 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h proeprties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0