AIR PRODUCTS LLANWERN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | AIR PRODUCTS LLANWERN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01175461 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AIR PRODUCTS LLANWERN LIMITED?
- fabbricazione di gas industriali (20110) / Industrie manifatturiere
Dove si trova AIR PRODUCTS LLANWERN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1000 Hillswood Drive KT16 0PS Chertsey Surrey England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di AIR PRODUCTS LLANWERN LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per AIR PRODUCTS LLANWERN LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 18 dic 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 01 gen 2027 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 18 dic 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per AIR PRODUCTS LLANWERN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 18 dic 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Damian John Meadows come amministratore in data 01 ago 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Roberta Lesley Norris come amministratore in data 01 ago 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Craig Huw Phillips il 02 apr 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Stephen James Maynard il 02 apr 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Owen Rhys Jones il 02 apr 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth John Whiteley il 02 apr 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Andrew Chapman il 02 apr 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Hersham Place Technology Park Molesey Road Walton on Thames Surrey KT12 4RZ a 1000 Hillswood Drive Chertsey Surrey KT16 0PS in data 02 apr 2025 | 1 pagine | AD01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2024 | 23 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 dic 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2023 | 23 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 dic 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Mark Andrew Chapman come amministratore in data 17 ott 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Gareth John Whiteley come amministratore in data 17 ott 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Jonathan William Carter Walton come amministratore in data 17 ott 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Silvia Villota Ortega come amministratore in data 17 ott 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2022 | 24 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 dic 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Gareth Owen Rhys Jones come amministratore in data 11 nov 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Matthew Robert Wilson come amministratore in data 11 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2021 | 22 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 dic 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Tata Steel Uk Limited come persona con controllo significativo il 01 apr 2021 | 2 pagine | PSC05 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2020 | 20 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di AIR PRODUCTS LLANWERN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAPMAN, Mark Andrew | Amministratore | Hillswood Drive KT16 0PS Chertsey 1000 Surrey England | United Kingdom | British | 314898150001 | |||||
| JONES, Gareth Owen Rhys | Amministratore | 1000 Hillswood Drive KT16 0PS Chertsey C/O Law Department, Air Products Plc Surrey England | Wales | British | 302262510001 | |||||
| MAYNARD, Stephen James, Mr. | Amministratore | 1000 Hillswood Drive KT16 0PS Chertsey C/O Law Department, Air Products Plc Surrey England | Wales | British | 211875060001 | |||||
| MEADOWS, Damian John | Amministratore | Hillswood Drive KT16 0PS Chertsey 1000 Surrey England | England | British | 176590860001 | |||||
| PHILLIPS, Craig Huw, Mr. | Amministratore | 1000 Hillswood Drive KT16 0PS Chertsey C/O Law Department, Air Products Plc Surrey England | Wales | British | 211852790001 | |||||
| WHITELEY, Gareth John | Amministratore | Hillswood Drive KT16 0PS Chertsey 1000 Surrey England | United Kingdom | British | 314897600001 | |||||
| LLOYD, Caroline Mary | Segretario | The Little House Knightons Lane, Dunsfold GU8 4NU Godalming Surrey | British | 79670850001 | ||||||
| TUFNELL, John Francis, Mr. | Segretario | 32 Lower Hill Road KT19 8LT Epsom Surrey | British | 375540001 | ||||||
| ABBOTT, Jonathan | Amministratore | Llanfrechfa NP44 8AD Cwmbran Llysbrechfa House Gwent | United Kingdom | British | 44093990003 | |||||
| BELK, Alan Richard | Amministratore | Whitehall Hawkshill Close KT22 9DL Leatherhead Surrey | British | 31108710001 | ||||||
| BIZZELL, Robert Barry | Amministratore | c/o C/O European Law Group Hersham Place Technology Park Molesey Road, Hersham KT12 4RZ Walton-On-Thames Air Products Plc Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 126793560001 | |||||
| CALLINGHAM, Peter Harold | Amministratore | 5 Highfield Gardens GU33 7NQ Liss Hampshire | England | British | 31108700001 | |||||
| CASTLE-SMITH, Howard Graham, Mr. | Amministratore | Wellhouse Road GU344AQ Beech Beech Place Hampshire | British | 138480920001 | ||||||
| CIUKSZA, Andrzej Maciej | Amministratore | Hersham Place Technology Park Molesey Road KT12 4RZ Walton On Thames Surrey | England | British | 254314300003 | |||||
| CLARKE, Adrian John | Amministratore | Orchard House Mark Way GU7 2BE Godalming Surrey | British | 22180170001 | ||||||
| DAVIES, Neil | Amministratore | Hersham Place Technology Park Molesey Road KT12 4RZ Walton-On-Thames C/O Air Products Plc European Law Group Surrey England | Wales | British | 126393030003 | |||||
| DAVIES, Stephen, Mr. | Amministratore | Molesey Road Hersham KT12 4RZ Walton-On-Thames C/O Law Dept Air Products Plc Hersham Place Surrey England | Wales | British | 182518760001 | |||||
| DUNBAR, Andrew | Amministratore | c/o C/O European Law Group Hersham Place Technology Park Molesey Road, Hersham KT12 4RZ Walton-On-Thames Air Products Plc Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 68085080001 | |||||
| FINDLAY, Stuart Ian | Amministratore | 7 Lansdown Drive NP7 6AW Abergavenny Gwent | British | 31119540001 | ||||||
| FRIEND, James Frederick | Amministratore | Haslemere Oakcroft Road KT14 6JH West Byfleet Surrey | British | 22180180001 | ||||||
| GEORGE, Stephen John, Mr. | Amministratore | c/o C/O European Law Group Hersham Place Technology Park Molesey Road Hersham KT12 4RZ Walton-On-Thames Air Products Plc Surrey England | United Kingdom | British | 165103560001 | |||||
| KIDD, Peter Gordon | Amministratore | Derwent Windmill Close Wick CF7 7QD Cowbridge S Glamorgan | British | 3884990001 | ||||||
| LENEY, David | Amministratore | Hersham Place Technology Park Molesey Road KT12 4RZ Walton On Thames Surrey | England | British | 140196340001 | |||||
| MCCUSKER, Philip John | Amministratore | Hersham Place Technology Park Molesey Road KT12 4RZ Walton On Thames Surrey | United Kingdom | British | 62065210003 | |||||
| MESSINA, Marisa Paolina | Amministratore | Hersham Place Technology Park Molesey Road KT12 4RZ Walton On Thames Surrey | England | British | 203390100001 | |||||
| NORRIS, Roberta Lesley | Amministratore | Hillswood Drive KT16 0PS Chertsey 1000 Surrey England | England | British | 247039820001 | |||||
| PATEL, Manish, Mr. | Amministratore | Hersham Place Technology Park Molesey Road KT12 4RZ Walton On Thames Surrey | England | British | 210632220001 | |||||
| SPARKS, John Leslie | Amministratore | Hurtwood The Chase, East Horsley KT24 5DQ Leatherhead Surrey | British | 71083380001 | ||||||
| VILLOTA ORTEGA, Silvia | Amministratore | Molesey Road KT12 4RZ Walton-On-Thames Hersham Place Technology Park United Kingdom | England | Spanish | 275872340001 | |||||
| WALTON, Jonathan William Carter | Amministratore | Molesey Road Hersham KT12 4RZ Walton-On-Thames Hersham Place Technology Park England | England | British | 267696230001 | |||||
| WILLIAMS, John Gwynne | Amministratore | Perthi Bach Berthlwyd CF15 9PG Pentyrch Cardiff | Wales | British | 2371090001 | |||||
| WILSON, Matthew Robert | Amministratore | Hersham Place Technology Park Molesey Road KT12 4RZ Walton-On-Thames C/O Law Department, Air Products Plc Surrey England | Wales | British | 203502900001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di AIR PRODUCTS LLANWERN LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata Steel Uk Limited | 06 apr 2016 | Grosvenor Place SW1X 7HS London 18 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Air Products Plc | 06 apr 2016 | Molesey Road Hersham KT12 4RZ Walton-On-Thames Hersham Place Technology Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0