JARVIS DORMANT 20 LIMITED

JARVIS DORMANT 20 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJARVIS DORMANT 20 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01175652
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JARVIS DORMANT 20 LIMITED?

    • (3663) /
    • (5113) /

    Dove si trova JARVIS DORMANT 20 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Meridian House, The Crescent
    York
    YO24 1AW North Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JARVIS DORMANT 20 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ZEBRAFLEX LIMITED16 ago 199416 ago 1994
    ZEBRAFLEX SEALANTS AND SURFACING LIMITED14 dic 198814 dic 1988
    JOHN WORTHINGTON (PLANT) LIMITED28 giu 197428 giu 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di JARVIS DORMANT 20 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2010
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2010
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per JARVIS DORMANT 20 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 19 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 lug 2010

    Stato del capitale al 27 lug 2010

    • Capitale: GBP 15,866
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    2 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    8 pagine363s

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed zebraflex LIMITED\certificate issued on 27/11/06
    2 pagineCERTNM

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    3 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2004

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di JARVIS DORMANT 20 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    Segretario
    Meridian House
    The Crescent
    YO24 1AW York
    North Yorkshire
    70053320013
    AKINLADE, Mark Adeyemi Asagba
    The Haven
    Woodview Close
    KT21 1HA Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    The Haven
    Woodview Close
    KT21 1HA Ashtead
    Surrey
    EnglandBritish116740230002
    LAIRD, Stuart Wilson
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane
    Horton Heath
    SO50 7DF Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish60742240002
    BUTTERY, Alison Tracey
    9 Cornish Court
    16 Bridlington Road
    N9 7RS London
    Segretario
    9 Cornish Court
    16 Bridlington Road
    N9 7RS London
    British61671200001
    MCGOWAN, Gerard Francis
    135 Rushams Road
    RH12 2NY Horsham
    West Sussex
    Segretario
    135 Rushams Road
    RH12 2NY Horsham
    West Sussex
    Irish47622160002
    THORNHILL, Derek Nelson
    Hedgerows Bowden Avenue
    Pleasington
    BB2 5JJ Blackburn
    Lancashire
    Segretario
    Hedgerows Bowden Avenue
    Pleasington
    BB2 5JJ Blackburn
    Lancashire
    British6786050001
    BAYMAN, Gordon Martin
    161 Southport Road
    Ulnes Walton Leyland
    PR5 3LN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    161 Southport Road
    Ulnes Walton Leyland
    PR5 3LN Preston
    Lancashire
    British43871230001
    DOYLE, Robert John
    The Limes
    112 Hewarth Green
    York
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Limes
    112 Hewarth Green
    York
    North Yorkshire
    British79420210002
    FLOATE, Ernst
    17 Ludlow Road
    Ealing
    W5 1NX London
    Amministratore
    17 Ludlow Road
    Ealing
    W5 1NX London
    British31983560001
    GAY, Andrew
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    Amministratore
    Bircham Dyson Bell
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    United KingdomBritish73774260004
    HALL, David Ian
    37 Buckingham Avenue
    Whitefield
    M45 6DJ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    37 Buckingham Avenue
    Whitefield
    M45 6DJ Manchester
    Lancashire
    British8767460001
    HARRISON, Mark Edwards, Mr
    27 Hatchway
    Kirtlington
    OX5 3JS Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    27 Hatchway
    Kirtlington
    OX5 3JS Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish161031310001
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Amministratore
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritish57954340003
    KENDALL, Robert William
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    44 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20374510001
    KIRKWOOD, Colin Bryan
    2 Baslow Drive
    Hazel Grove
    SK7 6DR Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    2 Baslow Drive
    Hazel Grove
    SK7 6DR Stockport
    Cheshire
    British56538230001
    LEECH, David Ernest
    Ridgewood Springfield Lane
    Colgate
    RH12 4TA Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Ridgewood Springfield Lane
    Colgate
    RH12 4TA Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish36303610003
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish37404250003
    MCGOWAN, Gerard Francis
    135 Rushams Road
    RH12 2NY Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    135 Rushams Road
    RH12 2NY Horsham
    West Sussex
    Irish47622160002
    NICHOLSON, Michael Edward
    Nook Cottage
    Carr House Lane
    PR5 7AR Bretherton
    Lancashire
    Amministratore
    Nook Cottage
    Carr House Lane
    PR5 7AR Bretherton
    Lancashire
    British63774800001
    SIMPSON, Terence Colin Frank
    Homer Cottage
    Ipsden
    OX10 6QS Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Homer Cottage
    Ipsden
    OX10 6QS Wallingford
    Oxfordshire
    British34093540001
    THORNHILL, Derek Nelson
    Hedgerows Bowden Avenue
    Pleasington
    BB2 5JJ Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    Hedgerows Bowden Avenue
    Pleasington
    BB2 5JJ Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish6786050001
    TUNG, Min Eric
    39 Quaggy Walk
    Blackheath
    SE3 9EJ London
    Amministratore
    39 Quaggy Walk
    Blackheath
    SE3 9EJ London
    EnglandBritish85434150001
    WESTBROOK, Bernard Leslie
    4 Quantock Close
    Barton Seagrave
    NN15 6RR Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Quantock Close
    Barton Seagrave
    NN15 6RR Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish51336870001
    YEARWOOD, Michael Brian
    19 Hexham Close
    Worth
    RH10 7TZ Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    19 Hexham Close
    Worth
    RH10 7TZ Crawley
    West Sussex
    British59502270001

    JARVIS DORMANT 20 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Credit agreement
    Creato il 15 giu 1993
    Consegnato il 19 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £27525.20 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to all sums payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 19 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 03 ott 1988
    Consegnato il 07 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 ott 1988
    Consegnato il 04 ott 1988
    In corso
    Importo garantito
    £65,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Enterprises (Investments) Limited
    Transazioni
    • 04 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 29 lug 1982
    Consegnato il 10 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 10 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 22 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0