KESTREL DATA SERVICES LIMITED

KESTREL DATA SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKESTREL DATA SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01177562
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KESTREL DATA SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova KESTREL DATA SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di KESTREL DATA SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per KESTREL DATA SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Roderick Day come amministratore in data 14 ott 2016

    1 pagineTM01
    X5XFWET6

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A5JZOQL5

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA
    S5AU6FS9

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 gen 2016

    Stato del capitale al 29 gen 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01
    X4ZKVTWR

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA
    S4ADH28B

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 feb 2015

    Stato del capitale al 05 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01
    X40LP6HT

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA
    S3J0K103

    Cessazione della carica di Christopher Thomas come segretario

    1 pagineTM02
    X30KDCMO

    Nomina di Mr Simon Patrick Moynihan come segretario

    2 pagineAP03
    X30KDC17

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 gen 2014

    Stato del capitale al 24 gen 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01
    X309VMUZ

    Dettagli del direttore cambiati per Patrick John Keddy il 22 ott 2013

    2 pagineCH01
    X2JIXZFU

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA
    A2CV9AVS

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    X1ZOWBUY

    Nomina di Patrick John Keddy come amministratore

    2 pagineAP01
    X1O28T5K

    Cessazione della carica di Peter Eglinton come amministratore

    1 pagineTM01
    X1O28S35

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA
    A1BI7H7D

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    X114TDS3

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA
    AO81VT83

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    XIOOSQX6

    Stato del capitale al 07 gen 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19
    RQWX3QKN

    legacy

    1 pagineSH20
    AVZLVQ7H

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    AVZLWQ7I

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Chi sono gli amministratori di KESTREL DATA SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOYNIHAN, Simon Patrick
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Segretario
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    184667770001
    GOLESWORTHY, Simon Paul
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Amministratore
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    EnglandBritishFinance Director126710690002
    KEDDY, Patrick John
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Amministratore
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    EnglandBritishDirector174435840002
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector45345090004
    FORDHAM, Andrew
    The Granary Bears
    Hay Farm Brookhay Lane
    WS13 8RG Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    The Granary Bears
    Hay Farm Brookhay Lane
    WS13 8RG Lichfield
    Staffordshire
    British110434940001
    HODGSON, Richard
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    Segretario
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    BritishFinance Director96788660001
    LYON, Joseph
    34 The Uplands
    SL9 7JG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    34 The Uplands
    SL9 7JG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishAccountant57811150001
    MORRIS, Ronald Michael
    24 Southbury
    NW8 0RY London
    Segretario
    24 Southbury
    NW8 0RY London
    BritishCompany Director28887980001
    PETERS, John Fabian
    Redwood Sheethanger Lane
    Felden
    HP3 0BG Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Redwood Sheethanger Lane
    Felden
    HP3 0BG Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British46920180001
    RADTKE, Kenneth
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    Segretario
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    American96788410001
    THOMAS, Christopher David George
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Segretario
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    BritishCompany Secretary136331200001
    VARAH, David John Raphael
    30 Ewell Road
    KT6 6HX Surbiton
    Surrey
    Segretario
    30 Ewell Road
    KT6 6HX Surbiton
    Surrey
    BritishChartered Accountant1858870001
    CAMPBELL, Thomas Walter
    Warwick Gardens
    Kensington
    W14 8PH London
    13
    England
    Amministratore
    Warwick Gardens
    Kensington
    W14 8PH London
    13
    England
    AmericanDirector106922290002
    CROWN, Stephen Maurice
    14 Spaniards Close
    NW11 6TH London
    Amministratore
    14 Spaniards Close
    NW11 6TH London
    BritishCompany Director2996560001
    DAY, Roderick
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Amministratore
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    United KingdomBritishDirector132997840001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishDirector45345090004
    DUALE, Marc
    6 Bentinck Mansions
    12-16 Bentinck Street
    W1U 2ER London
    Amministratore
    6 Bentinck Mansions
    12-16 Bentinck Street
    W1U 2ER London
    FrenchDirector121593810001
    EDGE, Roderick Boris Clifford
    The Water Tower Knoll Road
    GU7 2EJ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    The Water Tower Knoll Road
    GU7 2EJ Godalming
    Surrey
    SurreyBritishDirector15622690001
    EGLINTON, Peter Damian
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Amministratore
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    United KingdomBritishSvp Uk Ireland And Norway137660810001
    HODGSON, Richard
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    Amministratore
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    BritishFinance Director96788660001
    MCGUIGAN, Neil Simon
    42 Linksway
    HA6 2XB Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    42 Linksway
    HA6 2XB Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director64780280001
    PETERS, John Fabian
    Redwood Sheethanger Lane
    Felden
    HP3 0BG Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Redwood Sheethanger Lane
    Felden
    HP3 0BG Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant46920180001
    PRICE, Phillip John
    Broadway House
    Chartridge
    HP5 2TT Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Broadway House
    Chartridge
    HP5 2TT Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector119570600001
    PROWSE, John
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    Amministratore
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    EnglandBritishManaging Director96786510001
    RADTKE, Kenneth
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    Amministratore
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    AmericanCompany Director96788410001
    SMITH, Nicholas Paul
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    Amministratore
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    United KnigdomBritishDirector32981540001

    KESTREL DATA SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 giu 1989
    Consegnato il 30 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade & tenants fixtures).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 set 1986
    Consegnato il 12 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    11 ullswater crescent coulsden, surrey CR3 2HR.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 set 1986
    Consegnato il 12 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    114/118 southwark bridge road, london SE1 0ES.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 08 set 1986
    Consegnato il 12 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    98/112 southwark bridge road, london SE1 0ES.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 04 set 1986
    Consegnato il 11 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed charge on all book and other debts owing to the company floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. (Excluding those mentioned above).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 gen 1984
    Consegnato il 17 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or kestrel reprographics limited. To the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 gen 1984
    Consegnato il 17 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or kestrel data (UK) limited. To the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 gen 1984
    Consegnato il 17 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or kestrel data storape and management limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 gen 1984
    Consegnato il 17 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or storape systems and services limited. To the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 20 dic 1983
    Consegnato il 29 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H banks & browside farms garsdale cumbria.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 08 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H plot 11 ullswater crescent morlpit lane industrial estate coulsdeon london title no. Sgl 111309.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 08 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 51 greencoat place westminster london.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 08 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 50 rochester row westminster london SW1.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1983
    Consegnato il 01 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £315,000
    Brevi particolari
    F/H land on the north east side of ullswater crescent marlpit lane croyden london title no sgl 111309.
    Persone aventi diritto
    • Contrell & Cochran (Southern) Limited.
    Transazioni
    • 01 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 06 gen 1981
    Consegnato il 09 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £90,535
    Brevi particolari
    Mossdale estate situate near hawes, in the counties of north yorkshire and cumbria.
    Persone aventi diritto
    • C. W. Garnett
    Transazioni
    • 09 gen 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1981
    Consegnato il 09 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Mossdale estates situate near hawes, north yorkshire and cumbria.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0