RAYMARINE 2002 LIMITED

RAYMARINE 2002 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRAYMARINE 2002 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01177969
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RAYMARINE 2002 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova RAYMARINE 2002 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Marine House Cartwright Drive
    Fareham
    PO15 5RJ Hampshire
    England
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RAYMARINE 2002 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RAYMARINE LIMITED30 gen 200130 gen 2001
    RAYTHEON MARINE LIMITED07 set 199807 set 1998
    RAYTHEON MARINE EUROPE LIMITED30 ott 199530 ott 1995
    AUTOHELM LIMITED08 mar 199408 mar 1994
    NAUTECH LIMITED19 lug 197419 lug 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di RAYMARINE 2002 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per RAYMARINE 2002 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 31 dic 2012

    • Capitale: GBP 1.00
    6 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 dic 2012

    • Capitale: GBP 1,423,064.00
    6 pagineSH01

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    3 pagineSH10

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Risoluzioni

    Resolutions
    13 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Notice of name of shares, variation of rights attached to shares, allotment of shares, cancellation of share premium account 31/12/2012
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Marine House 5 Harbourgate Southampton Road Portsmouth Hampshire PO6 4BQ in data 30 dic 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Varie

    Auditor's resignation
    1 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    21 pagineAA

    Cessazione della carica di Joanne Dobbie come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 14 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Mr Andrew Carleton Teich come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Thomas Aquinas Surran come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di RAYMARINE 2002 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SURRAN, Thomas Aquinas
    Cartwright Drive
    Fareham
    PO15 5RJ Hampshire
    Marine House
    England
    United Kingdom
    Amministratore
    Cartwright Drive
    Fareham
    PO15 5RJ Hampshire
    Marine House
    England
    United Kingdom
    United StatesAmerican153125220001
    TEICH, Andrew Carleton
    Cartwright Drive
    Fareham
    PO15 5RJ Hampshire
    Marine House
    England
    United Kingdom
    Amministratore
    Cartwright Drive
    Fareham
    PO15 5RJ Hampshire
    Marine House
    England
    United Kingdom
    Oregon United States Of AmericaAmerican151805170001
    DAY, Ian Bruce
    17 The Vulcan Gunwharf Quays
    PO1 3BF Portsmouth
    Hampshire
    Segretario
    17 The Vulcan Gunwharf Quays
    PO1 3BF Portsmouth
    Hampshire
    British122740160001
    DOBBIE, Joanne Elizabeth
    Bex Lane
    Heyshott
    GU29 0DQ Midhurst
    Bex Lodge
    West Sussex
    Segretario
    Bex Lane
    Heyshott
    GU29 0DQ Midhurst
    Bex Lodge
    West Sussex
    British140574970001
    HOWELL, Terri Georgina
    19 Ranvilles Lane
    PO14 3DX Fareham
    Hampshire
    Segretario
    19 Ranvilles Lane
    PO14 3DX Fareham
    Hampshire
    British76080790001
    MCBRIDE, Martin
    North Saltings
    Harbour Way Chidham
    PO18 8TG Chichester
    West Sussex
    Segretario
    North Saltings
    Harbour Way Chidham
    PO18 8TG Chichester
    West Sussex
    British121585460001
    MCBRIDE, Martin
    North Saltings
    Harbour Way Chidham
    PO18 8TG Chichester
    West Sussex
    Segretario
    North Saltings
    Harbour Way Chidham
    PO18 8TG Chichester
    West Sussex
    British121585460001
    OSBALDISTON, Anthony John
    Manor Road
    HP10 8HY Penn
    Ashley House
    Buckinghamshire
    Segretario
    Manor Road
    HP10 8HY Penn
    Ashley House
    Buckinghamshire
    British139343910001
    OSBALDISTON, John Anthony
    Ashley House
    Manor Road
    HP10 8HY Penn
    Buckinghamshire
    Segretario
    Ashley House
    Manor Road
    HP10 8HY Penn
    Buckinghamshire
    British100098300001
    RIDDLE, Edward Michael
    Crosstrees
    Station Road Bursledon
    SO31 8AA Southampton
    Hampshire
    Segretario
    Crosstrees
    Station Road Bursledon
    SO31 8AA Southampton
    Hampshire
    British63749560001
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    Segretario
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    38915800008
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    22 Kings Park Road
    SO15 2UF Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22 Kings Park Road
    SO15 2UF Southampton
    Hampshire
    59771390002
    BREHENY, Kieran Francis
    Freshacre
    West Walberton Lane, Walberton
    BN18 0QS Arundel
    West Sussex
    Amministratore
    Freshacre
    West Walberton Lane, Walberton
    BN18 0QS Arundel
    West Sussex
    EnglandBritish73945540001
    CHENEY, Philip W, Doctor
    282 Elm Street
    01742 Concord
    Massachusetts
    Usa
    Amministratore
    282 Elm Street
    01742 Concord
    Massachusetts
    Usa
    American41373550001
    CLARK, Stanley L
    141 Spring Street
    Lexington Massachusetts Ma 02173
    Usa
    Amministratore
    141 Spring Street
    Lexington Massachusetts Ma 02173
    Usa
    American31366770001
    DUERDIN, Leslie
    1 Prettyjohn House
    Gunners Row
    PO4 9XG Southsea
    Hampshire
    Amministratore
    1 Prettyjohn House
    Gunners Row
    PO4 9XG Southsea
    Hampshire
    EnglandBritish73945560005
    FAWCETT, Derek James
    Swallows
    Prinsted
    PO10 8HS Emsworth
    Hampshire
    Amministratore
    Swallows
    Prinsted
    PO10 8HS Emsworth
    Hampshire
    British4820450001
    GODFREY, Ian
    Watersplash Cottage
    Blissford
    SP6 2JQ Fordingbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Watersplash Cottage
    Blissford
    SP6 2JQ Fordingbridge
    Hampshire
    British18340770001
    GREEN, Raymond Charles
    5 Oldwick Meadows
    Lavant
    PO18 0BE Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    5 Oldwick Meadows
    Lavant
    PO18 0BE Chichester
    West Sussex
    British27243660001
    KANE, Richard Patrick
    15 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    Amministratore
    15 Courtney Place
    KT11 2BE Cobham
    Surrey
    American74360910004
    KANE, Richard Patrick
    2454 Provence Court
    Weston
    Florida 33327
    Usa
    Amministratore
    2454 Provence Court
    Weston
    Florida 33327
    Usa
    American74360910001
    KEILLOR, Sharon Ann, Doctor
    154 Oyster Quay
    Port Way Cosham
    PO6 4TQ Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    154 Oyster Quay
    Port Way Cosham
    PO6 4TQ Portsmouth
    Hampshire
    American58393520001
    LIPPERT, Del
    2 Gleneagle Drive
    03110 Bedford
    New Hampshire
    Usa
    Amministratore
    2 Gleneagle Drive
    03110 Bedford
    New Hampshire
    Usa
    Canadian58045550001
    MCBRIDE, Martin
    North Saltings
    Harbour Way Chidham
    PO18 8TG Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    North Saltings
    Harbour Way Chidham
    PO18 8TG Chichester
    West Sussex
    EnglandBritish121585460001
    MCKEE, Peter Robert
    12 Southcote Way
    Penn
    HP10 8JG High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    12 Southcote Way
    Penn
    HP10 8JG High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish13424020001
    MILLER, Malcolm Myer
    Winton House
    The Avenue
    WD7 7DW Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    Winton House
    The Avenue
    WD7 7DW Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish40527180001
    MONTGOMERY, Timothy Locke
    3 Admirals House
    Newtown Road, Warsash
    SO31 9GB Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    3 Admirals House
    Newtown Road, Warsash
    SO31 9GB Southampton
    Hampshire
    American68161970002
    OSBALDISTON, John Anthony
    Ashley House
    Manor Road
    HP10 8HY Penn
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ashley House
    Manor Road
    HP10 8HY Penn
    Buckinghamshire
    EnglandBritish100098300001
    RIDDLE, Edward Michael
    Crosstrees
    Station Road Bursledon
    SO31 8AA Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Crosstrees
    Station Road Bursledon
    SO31 8AA Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish63749560001
    SPALDING, Richard John
    Four Ways
    West Marden
    PO18 9EN Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Four Ways
    West Marden
    PO18 9EN Chichester
    West Sussex
    British18340780001
    THOMPSON, Stuart Anthony
    48 Beacon Square
    PO10 7HU Emsworth
    Hampshire
    Amministratore
    48 Beacon Square
    PO10 7HU Emsworth
    Hampshire
    United KingdomBritish73945570001
    VATCHER, Richard Paul
    5 Nixon Road
    01701 Framingham
    Massachusetts
    Usa
    Amministratore
    5 Nixon Road
    01701 Framingham
    Massachusetts
    Usa
    American66279450001
    WARD, Peter Terry
    21 Alexander Square
    SW3 2AU London
    Amministratore
    21 Alexander Square
    SW3 2AU London
    EnglandBritish55900930001

    RAYMARINE 2002 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 dic 2008
    Consegnato il 31 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each other member of the group to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC the Security Trustee
    Transazioni
    • 31 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 gen 2001
    Consegnato il 07 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the various finance documents (as defined) and all other provisions of the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 dic 1987
    Consegnato il 06 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book & other debts floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ago 1985
    Consegnato il 30 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & premises on the west side of robinson way anchorage park, portsmouth hamps.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0