RAYMARINE 2002 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RAYMARINE 2002 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01177969 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RAYMARINE 2002 LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova RAYMARINE 2002 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Marine House Cartwright Drive Fareham PO15 5RJ Hampshire England United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RAYMARINE 2002 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RAYMARINE LIMITED | 30 gen 2001 | 30 gen 2001 |
| RAYTHEON MARINE LIMITED | 07 set 1998 | 07 set 1998 |
| RAYTHEON MARINE EUROPE LIMITED | 30 ott 1995 | 30 ott 1995 |
| AUTOHELM LIMITED | 08 mar 1994 | 08 mar 1994 |
| NAUTECH LIMITED | 19 lug 1974 | 19 lug 1974 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RAYMARINE 2002 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per RAYMARINE 2002 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale al 31 dic 2012
| 6 pagine | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 dic 2012
| 6 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 3 pagine | SH10 | ||||||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 13 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Marine House 5 Harbourgate Southampton Road Portsmouth Hampshire PO6 4BQ in data 30 dic 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Varie Auditor's resignation | 1 pagine | MISC | ||||||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Joanne Dobbie come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Andrew Carleton Teich come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Thomas Aquinas Surran come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di RAYMARINE 2002 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURRAN, Thomas Aquinas | Amministratore | Cartwright Drive Fareham PO15 5RJ Hampshire Marine House England United Kingdom | United States | American | 153125220001 | |||||
| TEICH, Andrew Carleton | Amministratore | Cartwright Drive Fareham PO15 5RJ Hampshire Marine House England United Kingdom | Oregon United States Of America | American | 151805170001 | |||||
| DAY, Ian Bruce | Segretario | 17 The Vulcan Gunwharf Quays PO1 3BF Portsmouth Hampshire | British | 122740160001 | ||||||
| DOBBIE, Joanne Elizabeth | Segretario | Bex Lane Heyshott GU29 0DQ Midhurst Bex Lodge West Sussex | British | 140574970001 | ||||||
| HOWELL, Terri Georgina | Segretario | 19 Ranvilles Lane PO14 3DX Fareham Hampshire | British | 76080790001 | ||||||
| MCBRIDE, Martin | Segretario | North Saltings Harbour Way Chidham PO18 8TG Chichester West Sussex | British | 121585460001 | ||||||
| MCBRIDE, Martin | Segretario | North Saltings Harbour Way Chidham PO18 8TG Chichester West Sussex | British | 121585460001 | ||||||
| OSBALDISTON, Anthony John | Segretario | Manor Road HP10 8HY Penn Ashley House Buckinghamshire | British | 139343910001 | ||||||
| OSBALDISTON, John Anthony | Segretario | Ashley House Manor Road HP10 8HY Penn Buckinghamshire | British | 100098300001 | ||||||
| RIDDLE, Edward Michael | Segretario | Crosstrees Station Road Bursledon SO31 8AA Southampton Hampshire | British | 63749560001 | ||||||
| BLAKELAW SECRETARIES LIMITED | Segretario | Harbour Court Compass Road North Harbour PO6 4ST Portsmouth Hampshire | 38915800008 | |||||||
| BONDLAW SECRETARIES LIMITED | Segretario | 22 Kings Park Road SO15 2UF Southampton Hampshire | 59771390002 | |||||||
| BREHENY, Kieran Francis | Amministratore | Freshacre West Walberton Lane, Walberton BN18 0QS Arundel West Sussex | England | British | 73945540001 | |||||
| CHENEY, Philip W, Doctor | Amministratore | 282 Elm Street 01742 Concord Massachusetts Usa | American | 41373550001 | ||||||
| CLARK, Stanley L | Amministratore | 141 Spring Street Lexington Massachusetts Ma 02173 Usa | American | 31366770001 | ||||||
| DUERDIN, Leslie | Amministratore | 1 Prettyjohn House Gunners Row PO4 9XG Southsea Hampshire | England | British | 73945560005 | |||||
| FAWCETT, Derek James | Amministratore | Swallows Prinsted PO10 8HS Emsworth Hampshire | British | 4820450001 | ||||||
| GODFREY, Ian | Amministratore | Watersplash Cottage Blissford SP6 2JQ Fordingbridge Hampshire | British | 18340770001 | ||||||
| GREEN, Raymond Charles | Amministratore | 5 Oldwick Meadows Lavant PO18 0BE Chichester West Sussex | British | 27243660001 | ||||||
| KANE, Richard Patrick | Amministratore | 15 Courtney Place KT11 2BE Cobham Surrey | American | 74360910004 | ||||||
| KANE, Richard Patrick | Amministratore | 2454 Provence Court Weston Florida 33327 Usa | American | 74360910001 | ||||||
| KEILLOR, Sharon Ann, Doctor | Amministratore | 154 Oyster Quay Port Way Cosham PO6 4TQ Portsmouth Hampshire | American | 58393520001 | ||||||
| LIPPERT, Del | Amministratore | 2 Gleneagle Drive 03110 Bedford New Hampshire Usa | Canadian | 58045550001 | ||||||
| MCBRIDE, Martin | Amministratore | North Saltings Harbour Way Chidham PO18 8TG Chichester West Sussex | England | British | 121585460001 | |||||
| MCKEE, Peter Robert | Amministratore | 12 Southcote Way Penn HP10 8JG High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | 13424020001 | |||||
| MILLER, Malcolm Myer | Amministratore | Winton House The Avenue WD7 7DW Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 40527180001 | |||||
| MONTGOMERY, Timothy Locke | Amministratore | 3 Admirals House Newtown Road, Warsash SO31 9GB Southampton Hampshire | American | 68161970002 | ||||||
| OSBALDISTON, John Anthony | Amministratore | Ashley House Manor Road HP10 8HY Penn Buckinghamshire | England | British | 100098300001 | |||||
| RIDDLE, Edward Michael | Amministratore | Crosstrees Station Road Bursledon SO31 8AA Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 63749560001 | |||||
| SPALDING, Richard John | Amministratore | Four Ways West Marden PO18 9EN Chichester West Sussex | British | 18340780001 | ||||||
| THOMPSON, Stuart Anthony | Amministratore | 48 Beacon Square PO10 7HU Emsworth Hampshire | United Kingdom | British | 73945570001 | |||||
| VATCHER, Richard Paul | Amministratore | 5 Nixon Road 01701 Framingham Massachusetts Usa | American | 66279450001 | ||||||
| WARD, Peter Terry | Amministratore | 21 Alexander Square SW3 2AU London | England | British | 55900930001 |
RAYMARINE 2002 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 23 dic 2008 Consegnato il 31 dic 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor and each other member of the group to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 26 gen 2001 Consegnato il 07 feb 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the various finance documents (as defined) and all other provisions of the debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 16 dic 1987 Consegnato il 06 gen 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on all book & other debts floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 ago 1985 Consegnato il 30 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H land & premises on the west side of robinson way anchorage park, portsmouth hamps. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0