01179565 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società01179565 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01179565
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 01179565 LIMITED?

    • (1582) /

    Dove si trova 01179565 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pricewaterhouse Coopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 01179565 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NFF LIMITED03 apr 199503 apr 1995
    SHAW'S BISCUITS LIMITED04 nov 198604 nov 1986
    NORTHUMBRIAN FINE FOODS LIMITED 02 ago 197402 ago 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di 01179565 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2000

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 01179565 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per 01179565 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 05 ago 2013

    4 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Relazione del commissario giudiziario amministrativo

    9 pagine3.10

    legacy

    3 pagineLQ01

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 29 gen 2009

    3 pagine3.6

    legacy

    1 pagine405(2)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    3 pagine3.6

    legacy

    1 pagine287

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    3 pagine3.6

    legacy

    1 pagine405(2)

    legacy

    1 pagine403a

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    4 pagine3.6

    Stato patrimoniale in amministrazione controllata a seguito della relazione ai creditori

    79 pagine3.3

    Relazione del commissario giudiziario amministrativo

    9 pagine3.10

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di 01179565 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HALLIDAY, Steven Don
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    Segretario
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    BritishFinance Director61413670001
    BRAITHWAITE, David
    11 Lower Wrigley Green
    Diggle
    OL3 5WG Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    11 Lower Wrigley Green
    Diggle
    OL3 5WG Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritishCommercial Director94329600001
    HALLIDAY, Steven Don
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director61413670001
    MATHERS, James Elliot
    120 Stanton Road
    Sandiacres
    NG10 5EP Nottingham
    Amministratore
    120 Stanton Road
    Sandiacres
    NG10 5EP Nottingham
    BritishChief Executive73184880001
    BROWN, Andrew Stephen Francis La Hausse
    64 Duchy Road
    HG1 2EZ Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    64 Duchy Road
    HG1 2EZ Harrogate
    North Yorkshire
    British62796600001
    DAVISON, Andrew John
    Fir Trees Farm
    Lowgate
    NE46 2NS Hexham
    Northumberland
    Segretario
    Fir Trees Farm
    Lowgate
    NE46 2NS Hexham
    Northumberland
    British3159270006
    BROWN, Andrew Stephen Francis La Hausse
    64 Duchy Road
    HG1 2EZ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    64 Duchy Road
    HG1 2EZ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishFinance Director62796600001
    GIBSON, John
    Shaws Farm
    NE48 2JU Bellingham
    Northumberland
    Amministratore
    Shaws Farm
    NE48 2JU Bellingham
    Northumberland
    BritishAccountant19815410001
    KENDALL-SMITH, Michael Andrew
    42 Spofforth Hill
    LS22 6SE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    42 Spofforth Hill
    LS22 6SE Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector55508710001
    MUSGRAVE, Michael Harry
    52 Moor Lane
    High Burton
    HD8 0QS Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    52 Moor Lane
    High Burton
    HD8 0QS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishConfectioner32410400001
    O'KEEFFE, Richard Kevin
    56 Flask Walk
    Hampstead
    NW3 1HE London
    Amministratore
    56 Flask Walk
    Hampstead
    NW3 1HE London
    BritishCompany Director14239310001
    ROBERTS, Henry William
    Silverwood 153 West Ella Road
    Kirk Ella
    HU10 7RN East Yorkshire
    Amministratore
    Silverwood 153 West Ella Road
    Kirk Ella
    HU10 7RN East Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director148220750001
    SMITH, Mark Andrew
    30 Silvermead
    HP18 9JS Worminghall
    Buckinghamshire
    Amministratore
    30 Silvermead
    HP18 9JS Worminghall
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director147868460001

    01179565 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of certain equipment
    Creato il 16 ott 2000
    Consegnato il 23 ott 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the equipment listed in schedule to form 395 titled sullich con bar line and headed by GL15 glycol circulation cooling unit m/c no. 3977. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed
    Creato il 02 ago 2000
    Consegnato il 17 ago 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by the mortgage debenture dated 4TH august 1993
    Brevi particolari
    All right,title and benefit in and to the sale agreement dated on or about the same date as the supplemental deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge over all assets (as defined)
    Creato il 26 lug 2000
    Consegnato il 08 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nmb-Heller Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 apr 2000
    Consegnato il 12 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a station approach johnston haverfordwest, dyfed, wales t/n WA915846. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 21 feb 2000
    Consegnato il 10 mar 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit 21 glanyrafon industrial estate llandbadarn aberystwyth ceredigion t/no.WA760289. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 21 feb 2000
    Consegnato il 10 mar 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a unit 5 and land adjoining glanyrafon industrial estate llandbadarn aberystwyth ceredigion t/n's WA915449 and WA748625. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 05 gen 1996
    Consegnato il 11 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings on the south side of ayres road stretford greater manchester t/n GM101622. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 18 apr 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly knwon as shaw's biscuits limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property situate off highgate lane, lepton, near huddersfield and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 18 apr 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as shaw's biscuits limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land situate off greave house terrace, lepton, near huddersfield, west yorkshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 18 apr 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as shaw's biscuits limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the west side of brixham road, stretford, greater manchester t/nos. GM431895 and LA362298 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 18 apr 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as shaw's biscuits limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the south west side of wakefield road, lepton, huddersfield t/no. WYK449674 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 18 apr 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as shaw's biscuits limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property situate off greave house terrace, lepton, near huddersfield, west yorkshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Book debts debenture
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 12 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 12 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 giu 1994
    Acquisito il 31 mar 1995
    Consegnato il 20 apr 1995
    In corso
    Importo garantito
    All moneys due from the company (formerly known as shaw's biscuits limited)
    Brevi particolari
    All that f/h property known as knightsbridge bakery, brixham road, old trafford, manchester t/n LA362298 and GM431895.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1995Registrazione di un'acquisizione (400)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1993
    Consegnato il 17 ago 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 01 feb 2001Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 03 gen 2003Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
      • Numero di pratica 1
    Collateral debenture
    Creato il 04 ago 1993
    Consegnato il 13 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from northumbrian fine foods PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings on the eastern side of dukesway team valley t/n's TY109916 and TY166080. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 214 feb 2013Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 207 ago 2013Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 204 ott 2013Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 2
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 1992
    Consegnato il 15 mag 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining site bti/5259 team valley trading estate gateshead tyne and wear t/no ty 109916 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 1992
    Consegnato il 15 mag 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Site bti/5259 team valley trading estate gateshead tyne and wear t/no ty 166080 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 28 giu 1989
    Acquisito il 31 mar 1995
    Consegnato il 20 apr 1995
    In corso
    Importo garantito
    All moneys due from the company (formerly known as shaw's biscuits limited)
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings on the south west side of wakefield road, lepton, huddersfield, west yorkshire WYK449674.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1995Registrazione di un'acquisizione (400)
    Collateral mortgage
    Creato il 04 feb 1988
    Consegnato il 09 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys now due, or hereafter to become due, or from time to time accruing due from northumbrian fine foods PLC to investors in industry PLC on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Leasehold premises lying to the east of dukesway team valley trading estate, gateshead, tyne & wear title nos ty 109916 ty 166080.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 09 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral mortgage.
    Creato il 04 feb 1988
    Consegnato il 09 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from northumbrian fine foods PLC to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    L/H premises lying to the east of dukesway team valley trading estate, gateshead tyne & wear, title no:- ty 109916, ty 166080 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 09 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 feb 1988
    Consegnato il 12 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 02 feb 1988
    Consegnato il 04 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures) all that l/h premises lying to the east of dukesway team valley trading estate gateshead, tyne & wear title no. Ty 109916, ty 166080. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 04 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral supplemental legal charge
    Creato il 15 ago 1983
    Consegnato il 22 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from shawis biscuits limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book and other debts due or owing the company.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 22 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture.
    Creato il 21 apr 1977
    Consegnato il 03 mag 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement and debenture both dated 21 april 77.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. Fixed & floating charges see doc M12.
    Persone aventi diritto
    • Industrial & Commercial Finance Corporation LTD.
    Transazioni
    • 03 mag 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    01179565 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 ago 1993Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Edward Klempka
    9 Bond Court
    Leeds
    LS1 2SN
    Praticante
    9 Bond Court
    Leeds
    LS1 2SN
    Stephen Andrew Ellis
    Pricewaterhousecoopers
    9 Bond Court
    LS1 2SN Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    9 Bond Court
    LS1 2SN Leeds
    David N Wilson
    Pricewaterhousecoopers
    9 Bond Court
    LS1 2SN Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    9 Bond Court
    LS1 2SN Leeds
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David James Kelly
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Ricevitore/gestore
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Stephen Andrew Ellis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Ricevitore/gestore
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0