THE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED

THE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01182631
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di THE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED?

    • Istruzione primaria (85200) / Istruzione
    • Istruzione secondaria generale (85310) / Istruzione

    Dove si trova THE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Woodard Corporation High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WOODARD SCHOOLS (NORTHERN DIVISION) LIMITED02 set 197402 set 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 ago 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mag 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al15 dic 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma29 dic 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al15 dic 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per THE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 ago 2023

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 ago 2022

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 ago 2021

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 ago 2020

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 ago 2019

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 ago 2018

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 ago 2017

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 ago 2016

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Ms Nicola Jane Downing come segretario in data 16 giu 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Alan Jackson come segretario in data 16 giu 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 ago 2015

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 dic 2015

    Stato del capitale al 18 dic 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 ago 2014

    21 pagineAA

    Nomina di Mr David Alan Jackson come segretario in data 18 feb 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Roy Cudworth come segretario in data 18 mar 2015

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da The Kings School Tynemouth 9 Huntington Place Tynemouth Newcastle upon Tyne NE30 4RF a Woodard Corporation High Street Abbots Bromley Rugeley Staffordshire WS15 3BW in data 20 mar 2015

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di THE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DOWNING, Nicola Jane
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Corporation
    Staffordshire
    Segretario
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Corporation
    Staffordshire
    209158360001
    EVANS, Maldwyn John
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Corporation
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Corporation
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishBarrister67726310001
    JOYCE, Ronald
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Corporation
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Corporation
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishAccountant79711900001
    CUDWORTH, David Roy
    c/o The Woodard Corporation
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Schools
    Staffordshire
    England
    Segretario
    c/o The Woodard Corporation
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Schools
    Staffordshire
    England
    191069660001
    DOBSON, Christine
    The Kings School Tynemouth
    9 Huntington Place
    NE30 4RF Tynemouth
    Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    The Kings School Tynemouth
    9 Huntington Place
    NE30 4RF Tynemouth
    Newcastle Upon Tyne
    British133166300001
    HOPES, Dorothy Gillian
    14 Westbourne Avenue
    HG2 9BD Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    14 Westbourne Avenue
    HG2 9BD Harrogate
    North Yorkshire
    British61031660001
    INGLE, Richard Henry
    Horsemill Cottage
    Markington
    HG3 3PG Harrogate
    Segretario
    Horsemill Cottage
    Markington
    HG3 3PG Harrogate
    British2681630002
    JACKSON, David Alan
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Corporation
    Staffordshire
    England
    Segretario
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    Woodard Corporation
    Staffordshire
    England
    196094980001
    PURDY, Patience
    10 Bath Terrace
    Tynemouth
    NE30 4BL North Shields
    Tyne & Wear
    Segretario
    10 Bath Terrace
    Tynemouth
    NE30 4BL North Shields
    Tyne & Wear
    Australian9614010001
    SCOTT BATEY, John
    50 Darras Road
    Ponteland
    NE20 9PA Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    50 Darras Road
    Ponteland
    NE20 9PA Newcastle Upon Tyne
    BritishBursar81182650001
    ADDISON, Shirley Catherine
    Auchingramont Road
    ML3 6JP Hamilton
    7a
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Auchingramont Road
    ML3 6JP Hamilton
    7a
    Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritishActive Schools Coordinator151479730003
    ANGUS, Ian Antony
    The Kings School Tynemouth
    9 Huntington Place
    NE30 4RF Tynemouth
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    The Kings School Tynemouth
    9 Huntington Place
    NE30 4RF Tynemouth
    Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishChartered Surveyor96101790001
    BAXTER, Dorothy Ann
    The Rivelin
    Lindale
    LA11 6LJ Grange Over Sands
    Cumbria
    Amministratore
    The Rivelin
    Lindale
    LA11 6LJ Grange Over Sands
    Cumbria
    BritishEducation Consultant59586250001
    BAXTER, Roger George, Dr
    The Rivelin
    Lindale
    LA11 6LJ Grange Over Sands
    Cumbria
    Amministratore
    The Rivelin
    Lindale
    LA11 6LJ Grange Over Sands
    Cumbria
    EnglandBritishEducational Consultant43914870003
    BELL, Peter Stuart
    41 Old Elvet
    DH1 3HN Durham
    County Durham
    Amministratore
    41 Old Elvet
    DH1 3HN Durham
    County Durham
    United KingdomBritishDirector41218700003
    BILTON, David Robert
    19 Ashleigh Grove
    Tynemouth
    NE30 2LA North Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    19 Ashleigh Grove
    Tynemouth
    NE30 2LA North Shields
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishChartered Engineer8235830001
    BODE, Delma Mary
    Green Gables
    Exelby
    DL8 2EZ Bedale
    North Yorkshire
    Amministratore
    Green Gables
    Exelby
    DL8 2EZ Bedale
    North Yorkshire
    BritishHousewife23016240001
    BRENNAN, Mary, Dr
    Huntingdon Place
    NE30 4RF Tynemouth
    The Kings School
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    Huntingdon Place
    NE30 4RF Tynemouth
    The Kings School
    Tyne And Wear
    England
    UkIrishUniversity Lecturer110510490001
    CLOVER, Brendan David, The Reverend Canon
    45 Lower Burlington Road
    BS20 7BP Portishead
    North Somerset
    Amministratore
    45 Lower Burlington Road
    BS20 7BP Portishead
    North Somerset
    United KingdomBritishSenior Provost117789460001
    COCKERILL, Harry Constable
    13 Church Avenue
    Gosforth
    NE3 1AN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    13 Church Avenue
    Gosforth
    NE3 1AN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishRetired2682440001
    COLVER, Patricia Anne, Dr
    Burnbrae
    Hepscott
    NE61 6LH Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Burnbrae
    Hepscott
    NE61 6LH Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishGeneral Medical Practitioner104474850001
    CONN, Alastair Macbeth
    Clifton Terrace
    NE66 1XF Alnwick
    Old Appletree House
    Northumberland
    United Kingdom
    Amministratore
    Clifton Terrace
    NE66 1XF Alnwick
    Old Appletree House
    Northumberland
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director9387900003
    CRAGGS, Patricia Frances
    5 Glendyn Close
    Jesmond Park West
    NE7 7DZ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    5 Glendyn Close
    Jesmond Park West
    NE7 7DZ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    IrishSolicitor102235790001
    CUNLIFFE-LISTER, Elizabeth Susan, The Honourable
    Glebe House
    Masham
    HG4 4EQ Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Glebe House
    Masham
    HG4 4EQ Ripon
    North Yorkshire
    United KingdomBritishHousewife4316300001
    CURRALL, Arnold Edward, Dr
    Kelsyke
    Great Strickland
    CA10 3DJ Penrith
    Cumbria
    Amministratore
    Kelsyke
    Great Strickland
    CA10 3DJ Penrith
    Cumbria
    BritishRetired4835940001
    DENYER, Mark Edward, Dr
    Wighill House
    Wighill
    LS24 8BG Tadcaster
    North Yorkshire
    Amministratore
    Wighill House
    Wighill
    LS24 8BG Tadcaster
    North Yorkshire
    EnglandBritishConsultant Physician52768590001
    DUDLEY, John Rea, The Rev
    St Marys Vicarage
    Thames Street
    TW16 6AA Sunbury On Thames
    Midlesex
    Amministratore
    St Marys Vicarage
    Thames Street
    TW16 6AA Sunbury On Thames
    Midlesex
    BritishCleric23016250001
    FEARNLEY, David
    11 Hopton Hall Lane
    WF14 8EL Mirfield
    The Grange
    West Yorkshire
    Amministratore
    11 Hopton Hall Lane
    WF14 8EL Mirfield
    The Grange
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChairman/Md Walter Walker & Sons7309160001
    GARSIDE, Howard, The Rev Canon
    73 Kirkby Road
    HG4 2HH Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    73 Kirkby Road
    HG4 2HH Ripon
    North Yorkshire
    BritishRetired23016260001
    GIBBONS, Kenneth Harry, Venerable
    112 Valley Road
    CR8 5BU Kenley
    Surrey
    Amministratore
    112 Valley Road
    CR8 5BU Kenley
    Surrey
    EnglishArchdeacon Of Lancaster10980320002
    GIBBS, Frank Silverthorne
    Windrush Broadway
    EX10 8RQ Sidmouth
    Devon
    Amministratore
    Windrush Broadway
    EX10 8RQ Sidmouth
    Devon
    BritishRetired797550002
    GIFFORD, Adrian Clive
    Glenholme The Dene
    Allendale
    NE47 9PX Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Glenholme The Dene
    Allendale
    NE47 9PX Hexham
    Northumberland
    BritishSolicitor33105390002
    GOOD, Kenneth Roy
    Hoppus House
    Hutton Conyers
    HG4 1HA Ripon
    Amministratore
    Hoppus House
    Hutton Conyers
    HG4 1HA Ripon
    BritishArchdeacon Of Richmond39829200001
    GRAHAM, Judith
    Badger Bank
    Norton Conyers
    HG4 5LT Ripon
    Yorkshire
    Amministratore
    Badger Bank
    Norton Conyers
    HG4 5LT Ripon
    Yorkshire
    United KingdomBritishHousewife57310940001
    HALL, Katherine Sarah
    Arcot Avenue
    NE25 9DX Whitley Bay
    11
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Arcot Avenue
    NE25 9DX Whitley Bay
    11
    Tyne & Wear
    EnglandBritishPr & Marketing Consultant138510780001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE KING'S SCHOOL TYNEMOUTH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Woodard Corporation
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    The Woodard Corporation
    Staffordshire
    England
    06 apr 2016
    High Street
    Abbots Bromley
    WS15 3BW Rugeley
    The Woodard Corporation
    Staffordshire
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Guarantee, Registered Charity
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act, Charities Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione4659710
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0