COPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED

COPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01189078
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova COPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    20 Triton Street
    NW1 3BF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PHOTOSTATIC COPIERS (BIRMINGHAM) LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    GREEN & BRICK TRADING LIMITED31 ott 197431 ott 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di COPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per COPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 mar 2011

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 66 Chiltern Street London W1U 4AG in data 06 dic 2010

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Peter Simpson come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Nicola Clare Downing come segretario

    3 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 18 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mag 2010

    Stato del capitale al 25 mag 2010

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ikon House 30 Cowcross Street London EC1M 6DQ in data 11 nov 2009

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    6 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    6 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    6 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2005

    6 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 set 2004

    6 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2003

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DOWNING, Nicola Clare
    Chiltern Street
    W1U 4AG London
    66
    United Kingdom
    Segretario
    Chiltern Street
    W1U 4AG London
    66
    United Kingdom
    British155537690001
    MILLS, David
    Fourfields
    Uvedale Road
    RH8 0EW Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Fourfields
    Uvedale Road
    RH8 0EW Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish72326700001
    PRASTKA, Christopher Richard
    Cedars 26 Portman Park
    TN9 1LW Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Cedars 26 Portman Park
    TN9 1LW Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish38634910001
    DOBSON, Isabel Claire
    10 Stockfield Road
    SW16 2LR London
    Segretario
    10 Stockfield Road
    SW16 2LR London
    British66065060001
    DUCKER, Andrew James
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    British78519720002
    HOLLEBONE, Paul Stephen
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    Segretario
    Old Orchard Dog Lane
    BN44 3GE Steyning
    West Sussex
    British15201600002
    SIMPSON, Peter John
    Gleniffer
    2 Elizabethan Way Maidenbower
    RH10 7GU Crawley
    West Sussex
    Segretario
    Gleniffer
    2 Elizabethan Way Maidenbower
    RH10 7GU Crawley
    West Sussex
    British712540001
    DUCKER, Andrew James
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    42 St Marys Road
    CV31 1JP Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish78519720002
    DUNCKLEY, Peter John
    Lake House Deerleap Road
    Westcott
    RH4 3LE Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Lake House Deerleap Road
    Westcott
    RH4 3LE Dorking
    Surrey
    EnglandBritish1173580001
    GOODALL, Bernard
    The Cottage
    Pangbourne Road
    RG8 8LN Upper Basildon
    Berkshire
    Amministratore
    The Cottage
    Pangbourne Road
    RG8 8LN Upper Basildon
    Berkshire
    British34918420001
    ROBERJOT, Paul Anthony
    The Gallops
    Middleton Common Road Westmeston
    BN6 8SF Hassocks
    West Sussex
    Amministratore
    The Gallops
    Middleton Common Road Westmeston
    BN6 8SF Hassocks
    West Sussex
    British10397700001
    WILLIAMSON, Graham Thomas
    Rydal 147 Old Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0HE Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Rydal 147 Old Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0HE Solihull
    West Midlands
    British18618370001

    COPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 giu 1995
    Consegnato il 04 lug 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 28 feb 1995
    Consegnato il 10 mar 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited(As Security Trustee for the Lenders)
    Transazioni
    • 10 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 02 lug 1992
    Consegnato il 08 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 ott 1989
    Consegnato il 07 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 nov 1987
    Consegnato il 26 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £240,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Unit 7 the wharf 16 bridge street birmingham. Floating security over the goodwill of the business and the benefit of all contracts. (See form M395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Exeter Trust Limited.
    Transazioni
    • 26 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    Letter of set-off
    Creato il 07 lug 1987
    Consegnato il 16 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or copier products (holding) limited to lloyds bank PLC
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 27 apr 1987
    Consegnato il 11 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    361, 361A, b,c,d 363, 363A and land adjoining 363C hagley road, edgbaston, birmingham and assigns the goodwill of the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 giu 1986
    Consegnato il 06 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold 361, 361A, 361B, 361C, 361D, 363, 363A, and land adjoining 363C hagley rd, edgbasten, birmingham.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 25 apr 1986
    Consegnato il 01 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1983
    Consegnato il 31 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold 717, hagley road west, quinton, birmingham. Title no wk 217266.
    Persone aventi diritto
    • First National Securities Limited
    Transazioni
    • 31 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 gen 1982
    Consegnato il 01 feb 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold 363C, hagley road, ledgbaston, birmingham, west midlands. Title no.wm 221126.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 06 nov 1980
    Consegnato il 12 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    3, 3A and 5 brook street, lye, west midlands.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limited(As Security Trustee for the Lenders)
    Transazioni
    • 12 nov 1980Registrazione di un'ipoteca

    COPIER PRODUCTS (B.HAM) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 gen 2012Data di scioglimento
    10 mar 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kevin Anthony Murphy
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Praticante
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Praticante
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0