TAYVIN 30 PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTAYVIN 30 PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01189413
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TAYVIN 30 PLC?

    • (3663) /

    Dove si trova TAYVIN 30 PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Abbotsgate House
    Hollow Road
    IP32 7FA Bury St Edmunds
    Suffolk
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TAYVIN 30 PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EUROPLUS TECHNOLOGIES PLC18 apr 200118 apr 2001
    EUROPLUS SERVICES LIMITED04 nov 197404 nov 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di TAYVIN 30 PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per TAYVIN 30 PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    1 pagine4.43

    legacy

    1 pagine287

    Varie

    S/S cert. Release of liquidator
    1 pagineMISC

    Varie

    C/O replacement of liquidator
    4 pagineMISC

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    8 pagine1.4

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 06 set 2002

    3 pagine1.3

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ordine del tribunale di liquidazione

    1 pagineCOCOMP

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    10 pagine363s

    legacy

    2 pagine403a

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed europlus technologies PLC\certificate issued on 07/06/02
    2 pagineCERTNM

    legacy

    1 pagine288b

    Memorandum e Statuto

    36 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    5 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    4 pagine88(3)

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine88(2)R

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    £49400 19/11/01
    RES14

    Chi sono gli amministratori di TAYVIN 30 PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPALDING, Diane Ellinor
    8 Seckford Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5QG Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    8 Seckford Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5QG Ipswich
    Suffolk
    BritishSales Director79075330001
    BARKER, Christopher Jefferson
    Poplar Farm
    Cretingham
    IP13 7BW Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Poplar Farm
    Cretingham
    IP13 7BW Woodbridge
    Suffolk
    BritishFinancial Consultant5606810002
    CONWAY, Christopher John
    29 Lattice Avenue
    IP4 5LJ Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    29 Lattice Avenue
    IP4 5LJ Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritishFibre Optic Component Manufact59834970001
    MARSH, Philip, Dr
    1 Wood Cottages
    Chillesford
    IP12 3PS Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    1 Wood Cottages
    Chillesford
    IP12 3PS Woodbridge
    Suffolk
    BritishTechnical Director79075360001
    SCRIPPS, Martin Charles
    6 Kingfisher Rise
    IP17 1WE Saxmundham
    Suffolk
    Amministratore
    6 Kingfisher Rise
    IP17 1WE Saxmundham
    Suffolk
    BritishManufacturing Director79075390001
    SPALDING, Diane Ellinor
    8 Seckford Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5QG Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    8 Seckford Close
    Rushmere St. Andrew
    IP4 5QG Ipswich
    Suffolk
    BritishSales Director79075330001
    DEAS, Diana Lesley
    Rydall Cottage Ferry Road
    Bawdsey
    IP12 3AW Woodbridge
    Suffolk
    Segretario
    Rydall Cottage Ferry Road
    Bawdsey
    IP12 3AW Woodbridge
    Suffolk
    British12968800001
    DEAS, Diana Lesley
    Rydall Cottage Ferry Road
    Bawdsey
    IP12 3AW Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Rydall Cottage Ferry Road
    Bawdsey
    IP12 3AW Woodbridge
    Suffolk
    BritishSecretary12968800001
    DEAS, Dudley John
    Rydall Cottage Ferry Road
    Bawdsey
    IP12 3AW Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    Rydall Cottage Ferry Road
    Bawdsey
    IP12 3AW Woodbridge
    Suffolk
    BritishEngineer9430960001
    HALLS, Ashley Louise
    114 Bucklesham Road
    IP3 8TU Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    114 Bucklesham Road
    IP3 8TU Ipswich
    Suffolk
    BritishFinance Director72901550001
    LESLEY, William Jeffrey
    67 Dumont Avenue
    CO16 8JP St Osyth
    Essex
    Amministratore
    67 Dumont Avenue
    CO16 8JP St Osyth
    Essex
    BritishConsultant81520220001

    TAYVIN 30 PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattel mortgage
    Creato il 14 set 2001
    Consegnato il 20 set 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bridgeport turret mill serial no.419430586W. Bridgeport vertical mill serial no.720935.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage deed
    Creato il 24 gen 2001
    Consegnato il 08 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £54,378 from the company to the chargee
    Brevi particolari
    32,33 and 34 avocet mews rendlesham woodbridge suffolk.
    Persone aventi diritto
    • Norwich & Peterborough Building Society
    Transazioni
    • 08 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 23 feb 1999
    Consegnato il 25 feb 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Credit Services Limited
    Transazioni
    • 25 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 09 apr 1998
    Consegnato il 18 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 3 wilford bridge road melton woodbridge suffolk. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 dic 1997
    Consegnato il 31 dic 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 19 feb 1997
    Consegnato il 25 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Corporate mortgage
    Creato il 10 mar 1988
    Consegnato il 22 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facilety letter dated 12TH/1/88
    Brevi particolari
    The goods (hereafter described) the benefit of all contracts warranties and agreements pertaining thereto insurance log books any moneys payable in connection with a sale & proposed sale of any of the goods colchester model 2000L cnccentre lathe sarial no. L2150GFBSA/01562.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 06 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 mar 1988
    Consegnato il 18 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 06 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mar 1987
    Consegnato il 20 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 2 wilford bridge road industrial estate melton, woodbridge, suffolk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 28 giu 1984
    Consegnato il 02 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and futue including goodwill bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 1984Registrazione di un'ipoteca

    TAYVIN 30 PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 set 2001Data della riunione per approvare il CVA
    11 giu 2003Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Aileen Jane Crooks
    Hlb Kidsons
    Friars Courtyard
    IP1 1RJ 30 Princes Street
    Ipswich
    Praticante
    Hlb Kidsons
    Friars Courtyard
    IP1 1RJ 30 Princes Street
    Ipswich
    2
    DataTipo
    10 nov 2011Data di scioglimento
    26 lug 2002Data della petizione
    02 ago 2011Conclusione della liquidazione
    18 set 2002Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Aileen Jane Crooks
    Hlb Kidsons
    Friars Courtyard
    IP1 1RJ 30 Princes Street
    Ipswich
    Praticante
    Hlb Kidsons
    Friars Courtyard
    IP1 1RJ 30 Princes Street
    Ipswich
    Nigel Millar
    Baker Tilly
    Friars Courtyard
    IP1 1RJ 30 Princes Street
    Ipswich
    Praticante
    Baker Tilly
    Friars Courtyard
    IP1 1RJ 30 Princes Street
    Ipswich

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0