TBU HOLDINGS LIMITED

TBU HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTBU HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01191154
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TBU HOLDINGS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TBU HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Rose Court
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TBU HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE BRAND UNION LIMITED30 giu 199730 giu 1997
    L N HOLDINGS LIMITED18 gen 199318 gen 1993
    LAMBIE-NAIRN & COMPANY LIMITED21 mag 199021 mag 1990
    ROBINSON LAMBIE-NAIRN LIMITED30 gen 198730 gen 1987
    ROBINSON, LAMBIE-NAIRN LIMITED19 nov 197419 nov 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di TBU HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per TBU HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Nicky Nicholls come amministratore in data 19 set 2023

    1 pagineTM01

    Stato del capitale al 18 ago 2023

    • Capitale: GBP 0.117924
    13 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account/cancellation of capital redemption reserve 16/08/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Modifica dei dettagli di Wpp Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Lambie-Nairn & Company Limited 6 Brewhouse Yard London EC1V 4DG a Rose Court 2 Southwark Bridge Road London SE1 9HS in data 10 gen 2022

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 feb 2021 con aggiornamenti

    10 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Wpp Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 26 nov 2018

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    10 pagineAA

    Nomina di Mr Byron Brinkley come amministratore in data 27 lug 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Varuna Rungusumy come amministratore in data 28 giu 2020

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 feb 2020 con aggiornamenti

    9 pagineCS01

    Cessazione della carica di Timothy Douglas Beauchamp come segretario in data 12 mag 2019

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TBU HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRINKLEY, Byron
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    Rose Court
    England
    Amministratore
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    Rose Court
    England
    United KingdomBritish272425160001
    BEAUCHAMP, Timothy Douglas
    c/o Lambie-Nairn & Company Limited
    Brewhouse Yard
    EC1V 4DG London
    6
    England
    Segretario
    c/o Lambie-Nairn & Company Limited
    Brewhouse Yard
    EC1V 4DG London
    6
    England
    British118137370001
    HEWITT, Colin David
    The Troon
    Borers Arms Road, Copthorne
    RH10 3LJ Crawley
    West Sussex
    Segretario
    The Troon
    Borers Arms Road, Copthorne
    RH10 3LJ Crawley
    West Sussex
    British63187200002
    LAMBIE NAIRN, Martin John
    Pirbright Manor Farm House
    Fairdeane Hogscross Lane
    CR5 3SJ Chipstead Coulsdon
    Surrey
    Segretario
    Pirbright Manor Farm House
    Fairdeane Hogscross Lane
    CR5 3SJ Chipstead Coulsdon
    Surrey
    British85474610001
    MORRIS, Barry Howard
    51 Farrer Road
    N8 8LD London
    Segretario
    51 Farrer Road
    N8 8LD London
    British7845400001
    SCOTT, Jeremy William Lemessurier
    25 Lady Margaret Road
    NW5 London
    Segretario
    25 Lady Margaret Road
    NW5 London
    British2596030001
    SHARP, Alan Donald
    253 Lower Richmond Road
    TW9 4LU Richmond
    Surrey
    Segretario
    253 Lower Richmond Road
    TW9 4LU Richmond
    Surrey
    British81055160001
    ALLEN, David
    7 Linden Road
    IP15 5JQ Aldeburgh
    Suffolk
    Amministratore
    7 Linden Road
    IP15 5JQ Aldeburgh
    Suffolk
    British40752560002
    BEAUCHAMP, Timothy Douglas
    c/o Lambie-Nairn & Company Limited
    Brewhouse Yard
    EC1V 4DG London
    6
    England
    Amministratore
    c/o Lambie-Nairn & Company Limited
    Brewhouse Yard
    EC1V 4DG London
    6
    England
    EnglandBritish118137370002
    CASEY, Janet Paula
    30 Coalecroft Road
    SW15 6LP London
    Amministratore
    30 Coalecroft Road
    SW15 6LP London
    British7845360001
    CHAPMAN, Celia
    8 Bedales
    Lewes Road
    RH17 7TE Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    8 Bedales
    Lewes Road
    RH17 7TE Haywards Heath
    West Sussex
    British54643230001
    DAVIES, Hilary Sarah Ellis
    102 Bennerley Road
    SW11 London
    Amministratore
    102 Bennerley Road
    SW11 London
    British7845370003
    DUNNING, Elizabeth Ann
    25 Petersham Place
    SW7 5PU London
    Amministratore
    25 Petersham Place
    SW7 5PU London
    British65110920002
    HEWITT, Colin David
    The Troon
    Borers Arms Road, Copthorne
    RH10 3LJ Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    The Troon
    Borers Arms Road, Copthorne
    RH10 3LJ Crawley
    West Sussex
    EnglandBritish63187200002
    JONES, Beverley
    Flat 1 50 Coolhurst Road
    N8 8EU London
    Amministratore
    Flat 1 50 Coolhurst Road
    N8 8EU London
    British63280600001
    KELLY, Anthony William
    38 Pemberton Road
    KT8 9LH East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    38 Pemberton Road
    KT8 9LH East Molesey
    Surrey
    British32239400001
    LAMBIE-NAIRN, Cordelia Margot
    Purbright Manor Farmhouse
    Fairdene Hogscross Lane
    Hipstead
    Surrey
    Amministratore
    Purbright Manor Farmhouse
    Fairdene Hogscross Lane
    Hipstead
    Surrey
    British7845380001
    LAMBIE-NAIRN, Martin John
    Pirbright Manor Farmhouse
    Fairdene Hogscross Lane
    CR5 3SJ Chipstead Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    Pirbright Manor Farmhouse
    Fairdene Hogscross Lane
    CR5 3SJ Chipstead Coulsdon
    Surrey
    United KingdomBritish32250680001
    MORRIS, Barry Howard
    51 Farrer Road
    N8 8LD London
    Amministratore
    51 Farrer Road
    N8 8LD London
    EnglandBritish7845400001
    NICHOLLS, Nicky
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    Rose Court
    England
    Amministratore
    2 Southwark Bridge Road
    SE1 9HS London
    Rose Court
    England
    EnglandBritish260580910001
    OWEN, Helen Lindsay Bland
    43 Grove Hill Road
    SE5 8DF London
    Amministratore
    43 Grove Hill Road
    SE5 8DF London
    British47204130001
    RUNGUSUMY, Varuna
    c/o Lambie-Nairn & Company Limited
    Brewhouse Yard
    EC1V 4DG London
    6
    Amministratore
    c/o Lambie-Nairn & Company Limited
    Brewhouse Yard
    EC1V 4DG London
    6
    EnglandBritish262122380001
    ST JOHN, Ian Richard
    21 Rectory Road
    SW13 0DU London
    Amministratore
    21 Rectory Road
    SW13 0DU London
    United KingdomBritish7845410001
    TUTSSEL, Glenn Gifford
    c/o Lambie-Nairn & Company Limited
    Brewhouse Yard
    EC1V 4DG London
    6
    England
    Amministratore
    c/o Lambie-Nairn & Company Limited
    Brewhouse Yard
    EC1V 4DG London
    6
    England
    EnglandBritish27950630001
    WATSON, Claire
    93 Fitzjohns Avenue
    NW3 6NX London
    Amministratore
    93 Fitzjohns Avenue
    NW3 6NX London
    United KingdomBritish55099600002
    WOOTTON, Timothy Paul
    North End Cottage
    North End Common Turville Heath
    RG9 6LJ Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    North End Cottage
    North End Common Turville Heath
    RG9 6LJ Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    British26739760001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TBU HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    06 apr 2016
    18 Upper Ground
    SE1 9GL London
    Sea Containers House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02670617
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TBU HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 30 giu 1998
    Consegnato il 03 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The performance of the tenant's obligations contained in a lease of suite 2A greencoat house,francis street,london W.1 dated 30TH june 1998 (as defined) and in a rent deposit deed of the same date
    Brevi particolari
    An interest bearing designated business premium account for £43,990 or such funds as may from time to time credited to the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derwent Valley Property Investments Limited
    Transazioni
    • 03 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 giu 1998
    Consegnato il 03 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The performance of the tenant's obligations contained in a lease of suite 1B greencoat house,francis street,london W.1 dated 30TH june 1998 (as defined) and in a rent deposit deed of the same date
    Brevi particolari
    A separate interest bearing designated business premium account for £46,265 or such funds from time to time credited thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derwent Valley Property Investments Limited
    Transazioni
    • 03 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 giu 1998
    Consegnato il 03 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The performance of the tenant's obligations contained in a lease of suite 2B greencoat house,francis street,london W.1 dated 30TH june 1998 (as defined) and in a rent deposit deed of the same date
    Brevi particolari
    A separate interest bearing designated business premium account containing £46,265 or such funds from time to time credited to the said account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Derwent Valley Property Investments Limited
    Transazioni
    • 03 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 19 dic 1997
    Consegnato il 03 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 16 mag 1990
    Consegnato il 18 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assignment by way of security of all the interest of the company under a building contract dated 16TH may 1990 (see form 395 relevant to this charge).
    Persone aventi diritto
    • U C B Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 12 giu 1989
    Consegnato il 26 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 giu 1989
    Consegnato il 14 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a 46/48 beak street, london W1 title no ngl 572471. and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • U C B Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 giu 1989
    Consegnato il 22 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H the basement ground and mazzanine floors of 40/41 great marlborough street, london N1 title no 24620 and ln 90477 and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0