TBU HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TBU HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01191154 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TBU HOLDINGS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TBU HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Rose Court 2 Southwark Bridge Road SE1 9HS London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TBU HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| THE BRAND UNION LIMITED | 30 giu 1997 | 30 giu 1997 |
| L N HOLDINGS LIMITED | 18 gen 1993 | 18 gen 1993 |
| LAMBIE-NAIRN & COMPANY LIMITED | 21 mag 1990 | 21 mag 1990 |
| ROBINSON LAMBIE-NAIRN LIMITED | 30 gen 1987 | 30 gen 1987 |
| ROBINSON, LAMBIE-NAIRN LIMITED | 19 nov 1974 | 19 nov 1974 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TBU HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per TBU HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Nicky Nicholls come amministratore in data 19 set 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 18 ago 2023
| 13 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Wpp Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Lambie-Nairn & Company Limited 6 Brewhouse Yard London EC1V 4DG a Rose Court 2 Southwark Bridge Road London SE1 9HS in data 10 gen 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 feb 2021 con aggiornamenti | 10 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Wpp Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 26 nov 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Byron Brinkley come amministratore in data 27 lug 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Varuna Rungusumy come amministratore in data 28 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 feb 2020 con aggiornamenti | 9 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Douglas Beauchamp come segretario in data 12 mag 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 9 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TBU HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRINKLEY, Byron | Amministratore | 2 Southwark Bridge Road SE1 9HS London Rose Court England | United Kingdom | British | 272425160001 | |||||
| BEAUCHAMP, Timothy Douglas | Segretario | c/o Lambie-Nairn & Company Limited Brewhouse Yard EC1V 4DG London 6 England | British | 118137370001 | ||||||
| HEWITT, Colin David | Segretario | The Troon Borers Arms Road, Copthorne RH10 3LJ Crawley West Sussex | British | 63187200002 | ||||||
| LAMBIE NAIRN, Martin John | Segretario | Pirbright Manor Farm House Fairdeane Hogscross Lane CR5 3SJ Chipstead Coulsdon Surrey | British | 85474610001 | ||||||
| MORRIS, Barry Howard | Segretario | 51 Farrer Road N8 8LD London | British | 7845400001 | ||||||
| SCOTT, Jeremy William Lemessurier | Segretario | 25 Lady Margaret Road NW5 London | British | 2596030001 | ||||||
| SHARP, Alan Donald | Segretario | 253 Lower Richmond Road TW9 4LU Richmond Surrey | British | 81055160001 | ||||||
| ALLEN, David | Amministratore | 7 Linden Road IP15 5JQ Aldeburgh Suffolk | British | 40752560002 | ||||||
| BEAUCHAMP, Timothy Douglas | Amministratore | c/o Lambie-Nairn & Company Limited Brewhouse Yard EC1V 4DG London 6 England | England | British | 118137370002 | |||||
| CASEY, Janet Paula | Amministratore | 30 Coalecroft Road SW15 6LP London | British | 7845360001 | ||||||
| CHAPMAN, Celia | Amministratore | 8 Bedales Lewes Road RH17 7TE Haywards Heath West Sussex | British | 54643230001 | ||||||
| DAVIES, Hilary Sarah Ellis | Amministratore | 102 Bennerley Road SW11 London | British | 7845370003 | ||||||
| DUNNING, Elizabeth Ann | Amministratore | 25 Petersham Place SW7 5PU London | British | 65110920002 | ||||||
| HEWITT, Colin David | Amministratore | The Troon Borers Arms Road, Copthorne RH10 3LJ Crawley West Sussex | England | British | 63187200002 | |||||
| JONES, Beverley | Amministratore | Flat 1 50 Coolhurst Road N8 8EU London | British | 63280600001 | ||||||
| KELLY, Anthony William | Amministratore | 38 Pemberton Road KT8 9LH East Molesey Surrey | British | 32239400001 | ||||||
| LAMBIE-NAIRN, Cordelia Margot | Amministratore | Purbright Manor Farmhouse Fairdene Hogscross Lane Hipstead Surrey | British | 7845380001 | ||||||
| LAMBIE-NAIRN, Martin John | Amministratore | Pirbright Manor Farmhouse Fairdene Hogscross Lane CR5 3SJ Chipstead Coulsdon Surrey | United Kingdom | British | 32250680001 | |||||
| MORRIS, Barry Howard | Amministratore | 51 Farrer Road N8 8LD London | England | British | 7845400001 | |||||
| NICHOLLS, Nicky | Amministratore | 2 Southwark Bridge Road SE1 9HS London Rose Court England | England | British | 260580910001 | |||||
| OWEN, Helen Lindsay Bland | Amministratore | 43 Grove Hill Road SE5 8DF London | British | 47204130001 | ||||||
| RUNGUSUMY, Varuna | Amministratore | c/o Lambie-Nairn & Company Limited Brewhouse Yard EC1V 4DG London 6 | England | British | 262122380001 | |||||
| ST JOHN, Ian Richard | Amministratore | 21 Rectory Road SW13 0DU London | United Kingdom | British | 7845410001 | |||||
| TUTSSEL, Glenn Gifford | Amministratore | c/o Lambie-Nairn & Company Limited Brewhouse Yard EC1V 4DG London 6 England | England | British | 27950630001 | |||||
| WATSON, Claire | Amministratore | 93 Fitzjohns Avenue NW3 6NX London | United Kingdom | British | 55099600002 | |||||
| WOOTTON, Timothy Paul | Amministratore | North End Cottage North End Common Turville Heath RG9 6LJ Henley-On-Thames Oxfordshire | British | 26739760001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TBU HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wpp Group (Uk) Limited | 06 apr 2016 | 18 Upper Ground SE1 9GL London Sea Containers House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TBU HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 30 giu 1998 Consegnato il 03 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The performance of the tenant's obligations contained in a lease of suite 2A greencoat house,francis street,london W.1 dated 30TH june 1998 (as defined) and in a rent deposit deed of the same date | |
Brevi particolari An interest bearing designated business premium account for £43,990 or such funds as may from time to time credited to the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 30 giu 1998 Consegnato il 03 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The performance of the tenant's obligations contained in a lease of suite 1B greencoat house,francis street,london W.1 dated 30TH june 1998 (as defined) and in a rent deposit deed of the same date | |
Brevi particolari A separate interest bearing designated business premium account for £46,265 or such funds from time to time credited thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 30 giu 1998 Consegnato il 03 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The performance of the tenant's obligations contained in a lease of suite 2B greencoat house,francis street,london W.1 dated 30TH june 1998 (as defined) and in a rent deposit deed of the same date | |
Brevi particolari A separate interest bearing designated business premium account containing £46,265 or such funds from time to time credited to the said account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 dic 1997 Consegnato il 03 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 16 mag 1990 Consegnato il 18 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Assignment by way of security of all the interest of the company under a building contract dated 16TH may 1990 (see form 395 relevant to this charge). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 12 giu 1989 Consegnato il 26 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 giu 1989 Consegnato il 14 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land k/a 46/48 beak street, london W1 title no ngl 572471. and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 09 giu 1989 Consegnato il 22 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H the basement ground and mazzanine floors of 40/41 great marlborough street, london N1 title no 24620 and ln 90477 and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0