SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED

SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSANCTUARY LAND COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01192287
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Chamber Court
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Worcestershire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Chamber Court Castle Street Worcester WR1 3ZQ a Chamber Court Castle Street Worcester Worcestershire WR1 3ZQ in data 03 feb 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2015

    Stato del capitale al 04 nov 2015

    • Capitale: GBP 5
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 nov 2014

    Stato del capitale al 06 nov 2014

    • Capitale: GBP 6
    SH01

    Dimissioni del revisore

    3 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    13 pagineAA

    Nomina di Ms Sophie Atkinson come segretario in data 21 lug 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Craig Jon Moule come segretario in data 21 lug 2014

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Neil King il 27 giu 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Craig Jon Moule il 05 mar 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 nov 2013

    Stato del capitale al 14 nov 2013

    • Capitale: GBP 6
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Jeffrey Mcdermott il 08 nov 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Craig Jon Moule il 08 nov 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Neil King il 08 nov 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Craig Jon Moule il 08 nov 2013

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John Bennett il 08 nov 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    11 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ATKINSON, Sophie
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    Segretario
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    189782000001
    BENNETT, David John
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    Amministratore
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    United KingdomBritish86724350001
    KING, Anthony Neil
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    Amministratore
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    EnglandBritish9255540009
    MCDERMOTT, Ian Jeffrey
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    Amministratore
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    EnglandBritish101774900001
    MOULE, Craig Jon
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    Amministratore
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    Worcestershire
    England
    EnglandBritish135984850004
    BENNETT, David John
    Timberlea House
    HR4 8DQ Moreton-On-Lugg
    Herefordshire
    Segretario
    Timberlea House
    HR4 8DQ Moreton-On-Lugg
    Herefordshire
    British86724350001
    BOYLES, Lynette
    104 Huntingdon Road
    N2 9DU London
    Segretario
    104 Huntingdon Road
    N2 9DU London
    British53764040001
    MOULE, Craig Jon
    Chamber Court
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Segretario
    Chamber Court
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    British135984850002
    TOULE, John Philip
    2 Oakrits
    Meldreth
    SG8 6JH Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    2 Oakrits
    Meldreth
    SG8 6JH Royston
    Hertfordshire
    British78482060001
    ASH, Herbert John
    Cedar Lodge 39 Church Road
    Newick
    BN8 4JX Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    Cedar Lodge 39 Church Road
    Newick
    BN8 4JX Lewes
    East Sussex
    British50771830001
    ASHRAF BISMIL, Mohammad
    22 Hill Park Avenue
    Hebble Lane Wheatley
    HX3 5JJ Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    22 Hill Park Avenue
    Hebble Lane Wheatley
    HX3 5JJ Halifax
    West Yorkshire
    British48655670001
    BARTON, Donald Carroll
    33 Galahad Way
    DY13 8SQ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    33 Galahad Way
    DY13 8SQ Stourport On Severn
    Worcestershire
    British55901690001
    BENTLEY, Laurence
    45 Sefton Avenue
    NW7 3QE London
    Amministratore
    45 Sefton Avenue
    NW7 3QE London
    British56352370001
    CLEGG, Derek Peter
    Ridgeway 34 Hambleton Grove
    HG5 0DB Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Ridgeway 34 Hambleton Grove
    HG5 0DB Knaresborough
    North Yorkshire
    British45227230001
    COATHAM, Veronica Mary
    5 Southam Drive
    Wylde Green
    B73 5PD Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    5 Southam Drive
    Wylde Green
    B73 5PD Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish122358020001
    COLLIER, Joseph Anthony
    7 College Mews
    CV37 6FF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    7 College Mews
    CV37 6FF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British18604760001
    EVANS, Gilean Mary Rohilla
    8 Broadlands Close
    Calcot Park
    RG31 7RP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    8 Broadlands Close
    Calcot Park
    RG31 7RP Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish55899670001
    GARDNER, Hilary
    7 Chancellor Close
    Grange Park
    SN5 6HH Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    7 Chancellor Close
    Grange Park
    SN5 6HH Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish73791660001
    GRIFFITHS, Mary Megan
    15 Copthorne Road
    WV3 0AB Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    15 Copthorne Road
    WV3 0AB Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish113045000001
    HAWKINS, Richard John
    85 Castle Street
    IP12 1HL Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    85 Castle Street
    IP12 1HL Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish45899770002
    HAWKINS, Richard John
    104 Constable Road
    IP4 2XA Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    104 Constable Road
    IP4 2XA Ipswich
    Suffolk
    British45899770001
    HAWKINS, Richard
    C/O Carter Jones
    25 Princes Street
    IP1 Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    C/O Carter Jones
    25 Princes Street
    IP1 Ipswich
    Suffolk
    British29000930002
    HEAD, Roy
    3 Florence Drive
    EN2 8DG Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    3 Florence Drive
    EN2 8DG Enfield
    Middlesex
    British18604730001
    HILTON, Christopher Graham
    Arundale Old London Road
    Coldwatham
    RH20 1LF Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Arundale Old London Road
    Coldwatham
    RH20 1LF Pulborough
    West Sussex
    British82668680001
    HODGSON, Frederick John Warmingham
    Rock House
    PL20 6BS Yelverton
    Devon
    Amministratore
    Rock House
    PL20 6BS Yelverton
    Devon
    British6357950001
    HOLT, Robert George
    59 Weetwood Lane
    LS16 5NP Leeds
    Amministratore
    59 Weetwood Lane
    LS16 5NP Leeds
    EnglandBritish35400070001
    JACKSON, David John
    95 West Ella Road
    HU10 7QR Kirk Ella
    East Riding
    Amministratore
    95 West Ella Road
    HU10 7QR Kirk Ella
    East Riding
    British98790720001
    LIMER, Frederick William
    The Coach House
    Thornwood Road
    CM16 6SX Epping
    Essex
    Amministratore
    The Coach House
    Thornwood Road
    CM16 6SX Epping
    Essex
    British18604740001
    MOORE, Roger
    39 Arundel Road
    BN10 8RS Peacehaven
    East Sussex
    Amministratore
    39 Arundel Road
    BN10 8RS Peacehaven
    East Sussex
    British55900170001
    NASH, Joan Isabel
    Holcombe Farm
    Painswick
    GL6 6RG Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Holcombe Farm
    Painswick
    GL6 6RG Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish55901730001
    STACY, Graham Henry
    31 Fordington Road
    N6 4TD London
    Amministratore
    31 Fordington Road
    N6 4TD London
    United KingdomBritish45227350001
    STACY, Graham Henry
    31 Fordington Road
    N6 4TD London
    Amministratore
    31 Fordington Road
    N6 4TD London
    United KingdomBritish45227350001
    WILLIAMS, Ronald Peter
    Longlands 8 St Werburgh Close
    Wembury
    PL9 0AP Plymouth
    Devon
    Amministratore
    Longlands 8 St Werburgh Close
    Wembury
    PL9 0AP Plymouth
    Devon
    British26339420001

    SANCTUARY LAND COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 30 set 1988
    Consegnato il 19 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H & l/h properties at phase ii iii & iv shadwell basin wapping london.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First legal charge
    Creato il 26 giu 1987
    Consegnato il 09 lug 1987
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks (as defined in the loan agreement) under the terms of a loan agreement dated 11/6/87
    Brevi particolari
    L/Hold land situate at shadwell basin wapping t/no egl 173650 together with the fixed machinery buildings erections & other fixtures & fittings.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 09 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 26 giu 1987
    Consegnato il 01 lug 1987
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 11-6-87
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • N.M. Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 01 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    Charge over deposit
    Creato il 26 giu 1987
    Consegnato il 01 lug 1987
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent for the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 11-6-87
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the company's estate right title & interest in all monies from time to time held in a deposit account opened in the name of the company at n m rothschild & sons limited.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 01 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage deed
    Creato il 04 mar 1986
    Consegnato il 20 mar 1986
    In corso
    Importo garantito
    Securing £5,000.000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Whereby land at shadwell basin wapping in the l/b of tower hamlets (see doc M36 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Halifax Building Society
    Transazioni
    • 20 mar 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0