PEGLER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPEGLER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01194543
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PEGLER LIMITED?

    • forgiatura, stampaggio, punzonatura e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri (25500) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova PEGLER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PEGLER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STEEL NUT AND JOSEPH HAMPTON LIMITED(THE)31 dic 198031 dic 1980
    WODEN STEEL & FASTENERS LIMITED 31 dic 197631 dic 1976
    HEXAGON FASTENINGS LIMITED20 dic 197420 dic 1974

    Quali sono gli ultimi bilanci di PEGLER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per PEGLER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 apr 2023

    7 pagineLIQ03

    Nomina di Jeroen Praas come amministratore in data 02 nov 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Guy Walker Robinson come amministratore in data 02 nov 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Craig Malloy come amministratore in data 02 nov 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 apr 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020

    19 pagineAA

    legacy

    128 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Seconda presentazione della Dichiarazione di conformità datata 01 dic 2019

    3 pagineRP04CS01

    Nomina di Mr Guy Walker Robinson come amministratore in data 14 dic 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 dic 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    19 pagineAA

    legacy

    157 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Chi sono gli amministratori di PEGLER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOUSLEY, Claire Anne
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    271574930001
    PRAAS, Jeroen
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    Belmont Works
    United Kingdom
    Amministratore
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    Belmont Works
    United Kingdom
    United KingdomDutch302847600001
    ABLETT, Roger Colin
    4 Drewry Lane
    Westwoodside
    DN9 2RE Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    4 Drewry Lane
    Westwoodside
    DN9 2RE Doncaster
    South Yorkshire
    British111377550001
    BROOKS, Malcolm Rodney
    Church View
    St Nicholas Way, Bawtry
    DN10 6HB Doncaster
    Segretario
    Church View
    St Nicholas Way, Bawtry
    DN10 6HB Doncaster
    British116420280001
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    PARKER, Kevin Michael
    16 Pinders Grove
    WF1 4AH Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    16 Pinders Grove
    WF1 4AH Wakefield
    West Yorkshire
    British42755700001
    ABLETT, Roger Colin
    High Street
    Misterton
    DN10 4BU Doncaster
    9a
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    Misterton
    DN10 4BU Doncaster
    9a
    South Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish111377550002
    ADAMS, David Mcdonald
    55 Ley Hill Road
    Four Oaks
    B75 6TE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    55 Ley Hill Road
    Four Oaks
    B75 6TE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British86150100001
    ANDERSON, Stuart John
    Rickstones Farmhouse
    300 Rickstones Road Rivenhall
    CM8 3HQ Witham
    Essex
    Amministratore
    Rickstones Farmhouse
    300 Rickstones Road Rivenhall
    CM8 3HQ Witham
    Essex
    British95628750001
    BEARDALL, Malcolm Derek
    Glenshirra Lodge Main Street
    Alne
    YO61 1TD York
    Amministratore
    Glenshirra Lodge Main Street
    Alne
    YO61 1TD York
    British25053140003
    BLACKWOOD, Kenneth John
    33 Hunters Ride
    Appleton Wiske
    DL6 2BD Northallerton
    North Yorkshire
    Amministratore
    33 Hunters Ride
    Appleton Wiske
    DL6 2BD Northallerton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish183082590001
    BROOKS, Malcolm Rodney
    Church View
    St Nicholas Way, Bawtry
    DN10 6HB Doncaster
    Amministratore
    Church View
    St Nicholas Way, Bawtry
    DN10 6HB Doncaster
    British116420280001
    CLARKSON, Antoni Raymond
    2 York Gardens Main Street
    Willerby
    HU10 6AQ Hull
    North Humberside
    Amministratore
    2 York Gardens Main Street
    Willerby
    HU10 6AQ Hull
    North Humberside
    British95628860001
    DOWLING, Martin John
    33 Rossett Drive
    HG2 9NS Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    33 Rossett Drive
    HG2 9NS Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish85410210001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Amministratore
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    FLANAGAN, Paul Edward
    First Floor Flat
    138 Shepherds Bush Road
    W6 7PB London
    Amministratore
    First Floor Flat
    138 Shepherds Bush Road
    W6 7PB London
    British69281780001
    HALL, Alan David
    169 Healey Wood Road
    HD6 3RW Brighouse
    West Yorkshire
    Amministratore
    169 Healey Wood Road
    HD6 3RW Brighouse
    West Yorkshire
    EnglandBritish33149710001
    HAYCOCK, Patrick John
    Grove House Norton Gardens
    Pebworth
    CV37 8YA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Grove House Norton Gardens
    Pebworth
    CV37 8YA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British33062310001
    HOUGHTON, Paul David
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    British95097460001
    HOWARTH, Ian Martin
    Fenay Lane
    Almondbury
    HD5 8UJ Huddersfield
    80
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fenay Lane
    Almondbury
    HD5 8UJ Huddersfield
    80
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish88051000002
    LASSETER, Ronald Sydney
    Rest Harrow
    Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Rest Harrow
    Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British44202370001
    LEWIS, David James
    51 Kingsley Crescent
    Birkenshaw
    BD11 2NJ Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    51 Kingsley Crescent
    Birkenshaw
    BD11 2NJ Bradford
    West Yorkshire
    United KingdomBritish33062330001
    LIDDLE, Bryan
    47 Lesbury Close
    Waldridge Park
    DH2 3SS Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    47 Lesbury Close
    Waldridge Park
    DH2 3SS Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish74328530002
    MALLOY, Craig
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish191150650001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCCARROLL, Neil Robert
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritish183381810001
    NELSON, Nigel David
    40 Tong Lane
    Tong Village
    BD4 0RP Bradford
    Pinfold Cottage
    Amministratore
    40 Tong Lane
    Tong Village
    BD4 0RP Bradford
    Pinfold Cottage
    British117580540003
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    READING, Anthony John
    16 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    Amministratore
    16 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish17110410001
    ROBINSON, Guy Walker
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Belmont Works
    St Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish195362020001
    SAUNDERS, Michael John
    The Beeches
    Grimley
    WR2 6LU Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    The Beeches
    Grimley
    WR2 6LU Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish87395770001
    SHIRLEY, Nigel Graham
    26 Windmill Hill
    HP27 0EP Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    26 Windmill Hill
    HP27 0EP Princes Risborough
    Buckinghamshire
    EnglandBritish99898590001
    STARK, John David Sinclair
    Tara 15 Copsem Drive
    KT10 9HD Esher
    Surrey
    Amministratore
    Tara 15 Copsem Drive
    KT10 9HD Esher
    Surrey
    British27350001
    WATSON, Brian
    The Oaks Castle Rising Road
    PE30 3JD South Wootton
    Norfolk
    Amministratore
    The Oaks Castle Rising Road
    PE30 3JD South Wootton
    Norfolk
    British74326200001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PEGLER LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    St. Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    Belmont Works
    England
    06 apr 2016
    St. Catherines Avenue
    DN4 8DF Doncaster
    Belmont Works
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04928300
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PEGLER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 14 lug 2011
    Consegnato il 16 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 mag 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 03 nov 2010
    Consegnato il 04 nov 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Note: by cla use 14.7 of the agreement the company agreed that it would not without the prior written consent of the bank assign mortgage charge or otherwise confer upon any third party any right title or interest in or to all or any of the accounts for the time being of the company with the bank or any sum or sums standing to the credit of any one or more of such accounts or agree to do any such thing or allow any such third pary right title or interest to subsist except in each case in favour of or upon the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 mag 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 30 august 2004 and
    Creato il 06 feb 2007
    Consegnato il 12 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-of agreement dated 30/08/04 (the agreement)
    Creato il 28 dic 2005
    Consegnato il 04 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture made between the company, ever 2214 limited (now known as pegler holdings limited) and gmac commercial finance PLC and
    Creato il 31 gen 2004
    Consegnato il 17 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor or any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge all the present and future property, undertaking and assets of the company including, without limitation, by way of first legal mortgage the f/h land and buildings owned by the company at st catherine's avenue, balby, doncaster t/nos. SYK286454, SYK438339, SYK286296, SYK446965, SYK438315 and SYK438336.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 17 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of credit insurance policy
    Creato il 31 gen 2004
    Consegnato il 17 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policy being the policy of credit insurance with gerling ncm, policy number 140719 dated 14 october 2003 for the sum assured of £2,500,000.00, all sums assured by it and all benefits which may arise under it; and the company's whole right, title, benefit and interest present and future in the policy, and all sums arising thereunder.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 17 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 gen 2004
    Consegnato il 09 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tomkins PLC
    Transazioni
    • 09 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PEGLER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 apr 2022Inizio della liquidazione
    07 mar 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoo0pers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoo0pers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0