CRAWLEY WARREN GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CRAWLEY WARREN GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01195662 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CRAWLEY WARREN GROUP LIMITED?
- (6601) /
Dove si trova CRAWLEY WARREN GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Devonshire House 60 Goswell Road EC1M 7AD London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CRAWLEY WARREN GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CRAWLEY WARREN (HOLDINGS) LIMITED | 07 gen 1975 | 07 gen 1975 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CRAWLEY WARREN GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2008 |
Quali sono le ultime deposizioni per CRAWLEY WARREN GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 15 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mar 2016 | 21 pagine | 4.68 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip Leighton Hanson come amministratore in data 15 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mar 2015 | 13 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Philip Leighton Hanson il 30 giu 2014 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Philip Leighton Hanson come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Christine Marie Williams come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Gale come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mar 2014 | 12 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mar 2013 | 17 pagine | 4.68 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Clayden come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mar 2012 | 13 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mar 2012 | 13 pagine | 4.68 | ||||||||||
Cessazione della carica di Yvonne Fisher come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 8 Devonshire Square London EC2M 4PL United Kingdom* in data 19 apr 2011 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Risoluzione di insolvenza Resolution insolvency:special resolution :- "in specie" | 1 pagine | LIQ MISC RES | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata | 2 pagine | AD04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Arfan Syeed come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2009 al 30 giu 2010 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Yvonne Jane Fisher come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CRAWLEY WARREN GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSEC 2000 LIMITED | Segretario | 8 Devonshire Square EC2M 4PL London | 64208180001 | |||||||
| WILLIAMS, Christine Marie | Amministratore | Devonshire Square EC2M 4PL London 8 United Kingdom | United Kingdom | American | 173125590001 | |||||
| EVANS, Jonathan Richard William | Segretario | 10 Sussex Court 50 Roan Street SE10 9JT London | British | 52263390002 | ||||||
| FITZPATRICK, Barry John | Segretario | 410 Marlyn Lodge Mansell Street E1 8RB London | British | 66086260001 | ||||||
| BOWEN, Christopher Anthony Richard | Amministratore | 71 Bolingbroke Grove SW11 6HD London | England | British | 48802110001 | |||||
| CLAYDEN, Paul Francis | Amministratore | Devonshire Square EC2M 4PL London 8 | United Kingdom | British | 138098080001 | |||||
| CRUTTWELL, Edward Robert Charles | Amministratore | Devonshire Square EC2M 4PL London 8 | British | 34367480002 | ||||||
| EVANS, Jonathan Richard William | Amministratore | 10 Sussex Court 50 Roan Street SE10 9JT London | United Kingdom | British | 52263390002 | |||||
| EVANS, Peter Anthony, Mr. | Amministratore | 47 Derwent Road AL5 3NY Harpenden Hertfordshire | England | British | 55924940001 | |||||
| FARMER, William Dickson | Amministratore | 4432 N Versailles Avenue Dallas Texas 75219 Usa | American | 67625250002 | ||||||
| FISHER, Yvonne Jane | Amministratore | Devonshire Square EC2M 4PL London 8 England | England | British | 152086390001 | |||||
| GALE, Stephen Dudley | Amministratore | Devonshire Square EC2M 4PL London 8 | United Kingdom | British | 152013590001 | |||||
| HANSON, Philip Leighton | Amministratore | Devonshire Square EC2M 4PL London 8 United Kingdom | England | British | 161795850002 | |||||
| HARGRAVE, Richard | Amministratore | Widcombe Cottage 3 Burntwood Road TN13 1PS Sevenoaks Kent | British | 73895030001 | ||||||
| HEAP, Michael Conrad | Amministratore | Devonshire Square EC2M 4PL London 8 | British | 93892910002 | ||||||
| HOLLAND, Robert Einion | Amministratore | 55 Corkscrew Hill BR4 9BA West Wickham Kent | British | 32829280001 | ||||||
| HOWES, John Harrison | Amministratore | Cervantes 2 Riesco Drive CR0 5RS Croydon Surrey | British | 5198300001 | ||||||
| LESSER, Maxwell Edward | Amministratore | 6 Prospect Road EN5 5BN New Barnet Hertfordshire | British | 37557770002 | ||||||
| LLOYD, Christopher Charles | Amministratore | Oakley 34 Lloyd Park Avenue CR0 5SB Croydon Surrey | British | 5198330001 | ||||||
| MORANT, Leslie Guy Mark | Amministratore | 20 Seeleys Road HP9 1SZ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 26855470001 | ||||||
| PATEL, Ebrahim Adam | Amministratore | 52 Thurnview Road LE5 6HJ Leicester Leicestershire | British | 67438680001 | ||||||
| SYEED, Arfan Mohammed | Amministratore | 84 Cissbury Ring South N12 7BD London | England | British | 89187900001 | |||||
| WARREN, Bernard James | Amministratore | Magnolia House 26 Kippington Road TN13 2LJ Sevenoaks Kent | England | British | 5198380001 |
CRAWLEY WARREN GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit agreement | Creato il 27 ago 1993 Consegnato il 10 set 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee arising under a term loan facility agreement dated 28TH may 1993 | |
Brevi particolari The sum of canadian dollars 6,178,602.08 together with interest on fixed canadian dollar account no: 150/1/03603466 at national westminster bank PLC, knightsbridge business centre. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit agreement | Creato il 27 mag 1993 Consegnato il 11 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee (as defined) | |
Brevi particolari The sum of canadian dollars 6,175,000.00 together with interest on account no: 150/1/03603466. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 24 giu 1991 Consegnato il 28 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Secured loan stock | Creato il 01 ott 1990 Consegnato il 03 ott 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £4,312,500 | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 27 apr 1990 Consegnato il 04 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Flat 3, 27 the street, london SW3 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 25 ago 1982 Consegnato il 09 set 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys due from time to time held to the credit of the company by national westminster bank PLC (see doc M22 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 25 ago 1982 Consegnato il 09 feb 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys from time to time held to the company by international westminster bank PLC (see doc M21 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 24 gen 1979 Consegnato il 02 feb 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property known as new forest hampshire title no hp 110745 flat 66 and garage space 98 cambden hurst pliss road milford on sea f/h clifford cottage lower market street east looe cornwall. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CRAWLEY WARREN GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0