ARCADIA PRODUCTS PLC

ARCADIA PRODUCTS PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARCADIA PRODUCTS PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01195839
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARCADIA PRODUCTS PLC?

    • fabbricazione di apparecchi di illuminazione elettrica (27400) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova ARCADIA PRODUCTS PLC?

    Indirizzo della sede legale
    8 Silverlea Gardens
    RH6 9BB Horley
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARCADIA PRODUCTS PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JERRARD BROS. PLC06 apr 198806 apr 1988
    JERRARD BROS. (ENGINEERING) LIMITED09 gen 197509 gen 1975

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARCADIA PRODUCTS PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ARCADIA PRODUCTS PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Soddisfazione dell'onere 011958390019 in pieno

    1 pagineMR04

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 011958390018 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 giu 2017

    27 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 29 giu 2017 al 28 giu 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 8 Io Centre Salbrook Road Salfords Redhill Surrey RH1 5GJ a 8 Silverlea Gardens Horley RH6 9BB in data 24 ott 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    24 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 011958390019, creata il 10 mar 2016

    42 pagineMR01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    28 pagineAA

    Bilancio modificato redatto al 30 giu 2014

    28 pagineAAMD

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 ott 2015

    Stato del capitale al 30 ott 2015

    • Capitale: GBP 945,333
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 ott 2014

    Stato del capitale al 13 ott 2014

    • Capitale: GBP 945,333
    SH01

    Chi sono gli amministratori di ARCADIA PRODUCTS PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OATES, Gerard Charles Holland
    8 Silverlea Gardens
    RH6 9BB Horley
    Surrey
    Segretario
    8 Silverlea Gardens
    RH6 9BB Horley
    Surrey
    British11658680004
    BENNETT, Martin Peter
    c/o C/O Arcadia Products Plc
    Io Centre
    Salbrook Road Salfords
    RH1 5GJ Redhill
    8
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Arcadia Products Plc
    Io Centre
    Salbrook Road Salfords
    RH1 5GJ Redhill
    8
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish162195390001
    OATES, Gerard Charles Holland
    8 Silverlea Gardens
    RH6 9BB Horley
    Surrey
    Amministratore
    8 Silverlea Gardens
    RH6 9BB Horley
    Surrey
    United KingdomBritish11658680004
    ARMSTRONG, Anthony John
    Moorside Lodge Panorama Drive
    LS29 9RA Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Moorside Lodge Panorama Drive
    LS29 9RA Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish48774750001
    HARAKIS, Louis Michael
    51 Buxton Road
    CR7 7HJ Thornton Heath
    Surrey
    Amministratore
    51 Buxton Road
    CR7 7HJ Thornton Heath
    Surrey
    United KingdomBritish74880780001
    HASTINGS, Julian Martin
    Broomden
    Vineyard Lane
    TN5 7LP Ticehurst
    East Sussex
    Amministratore
    Broomden
    Vineyard Lane
    TN5 7LP Ticehurst
    East Sussex
    United KingdomBritish74880960001
    JERRARD, Stephen Heath
    Innisfree Walpole Avenue
    CR5 3PR Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Innisfree Walpole Avenue
    CR5 3PR Chipstead
    Surrey
    British78475800002
    PALMER, David Michael
    8 Osmund Close
    Worth
    RH10 7RG Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    8 Osmund Close
    Worth
    RH10 7RG Crawley
    West Sussex
    British43166430002
    RUSSELL, Robin Christopher
    16 Quarry Gardens
    KT22 8UE Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    16 Quarry Gardens
    KT22 8UE Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish75517050002
    TAFT, Martin Stephen
    Bedgebury Close
    Vinters Park
    ME14 5QZ Maidstone
    58
    Kent
    Amministratore
    Bedgebury Close
    Vinters Park
    ME14 5QZ Maidstone
    58
    Kent
    United KingdomBritish100247320002
    WALKER, Gavin
    7 Bloomfield Terrace
    TN16 1DA Westerham
    Kent
    Amministratore
    7 Bloomfield Terrace
    TN16 1DA Westerham
    Kent
    United KingdomBritish122715610001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ARCADIA PRODUCTS PLC?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Amphiprion Sarl
    Terrasse Rhone Alpes
    Zac Terrasses De La Sarre
    57400 Sarrebourg
    2
    France
    06 apr 2016
    Terrasse Rhone Alpes
    Zac Terrasses De La Sarre
    57400 Sarrebourg
    2
    France
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneFrance
    Autorità legaleFrench Company Law
    Luogo di registrazioneFrench Registry
    Numero di registrazione503749129
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.

    ARCADIA PRODUCTS PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 mar 2016
    Consegnato il 11 mar 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 mar 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 gen 2014
    Consegnato il 04 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 05 giu 2013
    Consegnato il 13 giu 2013
    In corso
    Breve descrizione
    UK trade marks. UK00001178898 arcadia 22/07/1982 registered 11. UK00002384678 light for life 17/02/2005 registered 11. notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Gerard Oates
    Transazioni
    • 13 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 giu 2013
    Consegnato il 13 giu 2013
    In corso
    Breve descrizione
    UK trade marks. UK00001178898 arcadia 22/07/1982 registered 11. UK00002384678 light for life 17/02/2005 registered 11. notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Martin Bennett
    Transazioni
    • 13 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    All assets debenture
    Creato il 04 ott 2011
    Consegnato il 06 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 01 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal assignment
    Creato il 12 ago 2009
    Consegnato il 20 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 12 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Haeger stud machine HP6-CE2 s/n 2471, promecam press ITS2.50.20 S/n B40603, artos cs-336 cut & strip machine s/n 200070 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 12 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 26 apr 2004
    Consegnato il 27 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things listed in the schedule to form 395 including emc tester s/no. 81510620, panasonic DV2300 navigation system s/no. 017496 and apple power mac N5333OGHNAF (screen) (for details of further chattels charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 27 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 01 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 05 feb 2002
    Consegnato il 07 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at arcadia house cairo new road croydon CR0 1XP. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge (all assets
    Creato il 06 mar 2001
    Consegnato il 13 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 13 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 01 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 06 mar 2001
    Consegnato il 09 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at arcadia house cairo new road croydon CR10 1XP title number SGL518814. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 mar 2001
    Consegnato il 09 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at application house 3 ridges yard 107 waddon new road croydon title number SGL476743. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 01 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 06 mar 2001
    Consegnato il 09 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at unit 4 highams lodge business park london E17 title number EGL205301. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 feb 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 01 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 06 mar 2001
    Consegnato il 09 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 set 1997
    Consegnato il 23 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mag 1988
    Consegnato il 03 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land k/a 5 cairo new road croydon tog with the goodwill of the business & licenses held.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 03 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 giu 1987
    Consegnato il 10 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    45, 47 and 49 union road croydon, the good shepherd mission hall union road croydon & land on the south west side of union road croydon title nos SY188296, SY97923, SY223708.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 giu 1987
    Consegnato il 10 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0