CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED

CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01196227
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2014

    Stato del capitale al 10 feb 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Princess Way Redhill Surrey RH1 1NP in data 24 set 2013

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sharon Jill Caterer il 23 giu 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    18 pagineAA

    Nomina di Rbs Secretarial Services Limited come segretario in data 27 apr 2012

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Rachel Elizabeth Fletcher come segretario in data 27 apr 2012

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Paul Denzil John Sullivan come amministratore in data 30 mar 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter James Whitby come amministratore in data 16 feb 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    20 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mrs Sharon Jill Caterer come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Merriman come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    20 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Michael Merriman il 19 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Michael Merriman il 25 feb 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Segretario
    St Andrew Square
    EH2 1AF Edinburgh
    24/25
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC269847
    169073830001
    CATERER, Sharon Jill
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    Amministratore
    The Promonade
    GL50 1PX Cheltenham
    The Quadrangle
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish15490360003
    SULLIVAN, Paul Denzil John
    Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    10
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    Berberry Drive
    MK45 5ER Flitton
    10
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish111421900001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Segretario
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    FLETCHER, Rachel Elizabeth
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    Segretario
    Steerforth Street
    Earlsfield
    SW18 4HF London
    31a
    United Kingdom
    British106745220004
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Segretario
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Segretario
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    WOODCOCK, Michael Ian Charles
    High Elms Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BL Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    High Elms Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BL Cheltenham
    Gloucestershire
    British33177050001
    ASHWORTH, George Smith-Salmond
    2 Laurelsfield
    AL3 4BZ St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Laurelsfield
    AL3 4BZ St Albans
    Hertfordshire
    EnglandEnglish152638710001
    BOAG, Timothy John Donald
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    78 Bushwood Road
    TW9 3BQ Richmond
    Surrey
    British62111350002
    BROWNE, John Richard
    Gortenanima
    Bovally
    BT49 0GF Limavady
    34
    County Derry
    Northern Ireland
    Amministratore
    Gortenanima
    Bovally
    BT49 0GF Limavady
    34
    County Derry
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish133984130002
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Amministratore
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritish123744930001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish49141230004
    DOBBS, Clive Richard
    The Rowans Gravel Pits Close
    Bredon
    GL20 7QL Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Rowans Gravel Pits Close
    Bredon
    GL20 7QL Tewkesbury
    Gloucestershire
    British44775400001
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    FINLAYSON, David John Mcintosh
    8 Greenfields
    New Barn Lane Prestbury
    GL52 3LG Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    8 Greenfields
    New Barn Lane Prestbury
    GL52 3LG Cheltenham
    Gloucestershire
    British33124430005
    HALL, Phillip James
    45 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    45 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    UkBritish106668160001
    HARDY, Thomas William
    28 Piercing Hill
    CM16 7JW Theydon Bois
    Essex
    Amministratore
    28 Piercing Hill
    CM16 7JW Theydon Bois
    Essex
    EnglandBritish40359960002
    KNOWLES, Christopher George
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    British67501900002
    LYNAM, Paul Anthony
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    Amministratore
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    United KingdomIrish100755360001
    MARROW, Paul
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish85771600001
    MERRIMAN, Ian Michael
    Derrybawn
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Derrybawn
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Derrybawn
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Derrybawn
    Hampshire
    England
    EnglandBritish100771770002
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritish63084840002
    POLLARD, John Reginald
    Frome Hall Frome Hall Lane
    GL5 3JH Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Frome Hall Frome Hall Lane
    GL5 3JH Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish31820530002
    SULLIVAN, Christopher Paul
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    Amministratore
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    United KingdomBritish67033830004
    THORNTON, Jeffrey Michael
    108 March Road
    EH4 3SX Edinburgh
    Amministratore
    108 March Road
    EH4 3SX Edinburgh
    United KingdomBritish19241770002
    WHITBY, Peter James
    Finch Lane
    Knotty Green
    HP9 2TL Beaconsfield
    Maple Tree House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Finch Lane
    Knotty Green
    HP9 2TL Beaconsfield
    Maple Tree House
    Buckinghamshire
    EnglandEnglish76096790002
    WHITTICK, Robert James
    35 Englewood Road
    SW12 9PA London
    Amministratore
    35 Englewood Road
    SW12 9PA London
    British119328020001
    WOODCOCK, Michael Ian Charles
    High Elms Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    High Elms Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BL Cheltenham
    Gloucestershire
    British33177050001

    CHARTERHOUSE JAPHET FINANCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    First priority mortgage
    Creato il 30 set 2002
    Consegnato il 10 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interest in and to the goods and articles of computer hardware and other goods pursuant to the master hpa. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Electronic Data Systems Limited
    Transazioni
    • 10 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A first priority mortgage
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 07 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgagor with full title guarantee has mortgaged to the mortgagee all its interest, present and future in and to the goods by way of first priority legal mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Electronic Data Systems Limited
    Transazioni
    • 07 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    First priority mortgage
    Creato il 15 giu 2001
    Consegnato il 29 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of the company to the chargee pursuant to and/or under: a). To transfer and/or pass title, and to deliver, to the chargee any and all of the goods pursuant to and under clauses 10.3, 10.4, 14.2 and 15.1 of the master hpa (as the same are incorporated in the hp contract) and not to create,assume or permit to exist any security interest upon the goods other than pursuant to and/or under clause 12.2.3 of the master hpa (as the same is incorporated in the hp contract) and b). The mortgage
    Brevi particolari
    By way of first priority legal mortgage all the company's interest present and future in and to the goods listed in appendix a of the hp contract.
    Persone aventi diritto
    • Electronic Data Systems Limited
    Transazioni
    • 29 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A first priority mortgage
    Creato il 15 giu 2001
    Consegnato il 29 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of the company to the chargee pursuant to and/or under: (a) to transfer and/or pass title, and to deliver, to the chargee any and all of the goods pursuant to and/or under clauses 10.3, 10.4, 14.2 and 15.1 of the master hpa (as the same are incorporated in the hp contract) and not to create, assume or permit to exist any security interest upon the goods other than pursuant to and/or under clauses 12.2.3 of the master hpa (as the same is incorporated in the hp contract); and (b) the mortgage (all terms as defined)
    Brevi particolari
    By way of first priority legal mortgage all its interest, present and future in and to the goods provided that the chargee has acknowledged and agreed that the title to the goods the subject of the disposition by way of first priority legal mortgage shall be the same title recieved by the mortgagor on its purchase of the goods pursuant to the master hpa.
    Persone aventi diritto
    • Electronic Data Systems Limited
    Transazioni
    • 29 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First priority mortgage
    Creato il 28 feb 2001
    Consegnato il 16 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the master hire purchase agreement dated 28TH february 2001 between the mortgagor and mortgagee and the mortgage
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Electronic Data Systems Limited
    Transazioni
    • 16 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0